BLOOMS OF BRESSINGHAM LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | BLOOMS OF BRESSINGHAM LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03659183 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von BLOOMS OF BRESSINGHAM LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich BLOOMS OF BRESSINGHAM LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Wyevale Garden Centres Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Middlesex England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von BLOOMS OF BRESSINGHAM LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| STEELRAY NO. 127 LIMITED | 29. Okt. 1998 | 29. Okt. 1998 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BLOOMS OF BRESSINGHAM LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2017 |
Welche sind die letzten Einreichungen für BLOOMS OF BRESSINGHAM LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||
Beendigung der Bestellung von Roger Mclaughlan als Geschäftsführer am 01. Feb. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 29. Okt. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 8 Seiten | AA | ||
Beendigung der Bestellung von Mary Elizabeth Bourlet als Sekretär am 01. Feb. 2018 | 1 Seiten | TM02 | ||
Ernennung von Laura Harradine-Greene als Sekretär am 01. Feb. 2018 | 2 Seiten | AP03 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 29. Okt. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 25. Dez. 2016 | 3 Seiten | AA | ||
Änderung der Details des Sekretärs für Ms Mary Elizabeth Murray am 12. Mai 2017 | 1 Seiten | CH03 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Anthony Gerald Jones am 03. Apr. 2017 | 2 Seiten | CH01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 29. Okt. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||
Beendigung der Bestellung von Justin Matthew King als Geschäftsführer am 31. Okt. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 27. Dez. 2015 | 8 Seiten | AA | ||
Zweite Einreichung für die Abberufung von Kevin Michael Bradshaw als Geschäftsführer | 4 Seiten | RP04TM01 | ||
Zweite Einreichung für die Abberufung von Nils Olin Steinmeyer als Geschäftsführer | 3 Seiten | RP04TM01 | ||
Ernennung von Mr Justin Matthew King als Direktor am 18. Aug. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Stephen Thomas Murphy als Geschäftsführer am 18. Aug. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||
Ernennung von Ms Mary Elizabeth Murray als Sekretär am 25. Aug. 2016 | 2 Seiten | AP03 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Anthony Gerald Jones am 22. Juli 2016 | 2 Seiten | CH01 | ||
Ernennung von Mr Anthony Gerald Jones als Direktor am 06. Apr. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||
Ernennung von Mr Stephen Thomas Murphy als Direktor am 06. Apr. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Elizabeth Ann Ward als Sekretär am 13. Juli 2016 | 1 Seiten | TM02 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von BLOOMS OF BRESSINGHAM LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARRADINE-GREENE, Laura | Sekretär | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | 242726120001 | |||||||
| JONES, Anthony Gerald | Geschäftsführer | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | England | British | 212265950002 | |||||
| BOURLET, Mary Elizabeth | Sekretär | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | 213020850002 | |||||||
| FOALE, Stephen John | Sekretär | 42 Holmbury Avenue RG45 6TQ Crowthorne Berkshire | British | 37403500001 | ||||||
| GUNNING, George John | Sekretär | Meadow Bank Hockering Lane Bawburgh NR9 3LR Norwich Norfolk | British | 30443790001 | ||||||
| JENKINSON, Antonia Scarlett | Sekretär | 8 Stanmore Beedon RG20 8SR Newbury Berkshire | British | 72128340003 | ||||||
| RATCLIFFE, Sarah Elizabeth | Sekretär | 59b Grange Road SM2 6SP Sutton Surrey | British | 76162020001 | ||||||
| STEINMEYER, Nils Olin | Sekretär | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | 173112980001 | |||||||
| WARD, Elizabeth Ann | Sekretär | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | 205457410001 | |||||||
| STEELRAY SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Sekretär | 43 Richmond Hill BH2 6LR Bournemouth Richmond Point Dorset | 60731070001 | |||||||
| BERTRAM, Richard Christiaan | Geschäftsführer | 18 Ham Island Old Windsor SL4 2JY Windsor Berkshire | British | 6217370002 | ||||||
| BIGGS, Andrew Peter | Geschäftsführer | Woodside House Amport SP11 8BE Andover Hampshire | England | British | 58577370001 | |||||
| BRADSHAW, Kevin Michael | Geschäftsführer | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | England | British | 124019940001 | |||||
| BRIGDEN, Peter | Geschäftsführer | 16 Woodstock Gardens Appleton WA4 5HN Warrington Cheshire | United Kingdom | British | 195802400001 | |||||
| FOALE, Stephen John | Geschäftsführer | 42 Holmbury Avenue RG45 6TQ Crowthorne Berkshire | England | British | 37403500001 | |||||
| GOOD, Charles Anthony | Geschäftsführer | 31 Clapham Common West Side SW4 9AN London | British | 6848410004 | ||||||
| GUNNING, George John | Geschäftsführer | Meadow Bank Hockering Lane Bawburgh NR9 3LR Norwich Norfolk | England | British | 30443790001 | |||||
| HODKINSON, James Clifford | Geschäftsführer | 29b Western Avenue Branksome Park BH13 7AN Poole Dorset | England | British | 606430001 | |||||
| JENKINSON, Antonia Scarlett | Geschäftsführer | 8 Stanmore Beedon RG20 8SR Newbury Berkshire | United Kingdom | British | 72128340003 | |||||
| JONES, Anthony Gerald | Geschäftsführer | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | England | British | 73644040006 | |||||
| KING, Justin Matthew | Geschäftsführer | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | United Kingdom | British | 213157990001 | |||||
| KING, Wendy | Geschäftsführer | 9 Fielden Abbeydale GL4 5EW Gloucester Gloucestershire | England | British | 89910600001 | |||||
| KITCHING, Jonathan Andrew | Geschäftsführer | Beech House Harp Hill GL52 6PR Cheltenham | England | British | 68271660002 | |||||
| KOZLOWSKI, Richard Leon | Geschäftsführer | 34 Stubbs Wood HP6 6EX Amersham Buckinghamshire | England | British | 124967710001 | |||||
| LIVINGSTON, William Andrew | Geschäftsführer | 3 Barnes Close St Cross SO23 9QX Winchester Hampshire | England | British | 111439220001 | |||||
| LORIMER, Alistair Martin | Geschäftsführer | 3 Aston Cantlow Road Wilmcote CV37 9XN Stratford Upon Avon Warwickshire | United Kingdom | British | 64929030001 | |||||
| MARCH, Kenneth Ernest | Geschäftsführer | 21 Meadowlands Woolpit IP30 9SE Bury St Edmunds Suffolk | England | British | 30443800001 | |||||
| MARSHALL, Nicholas Charles Gilmour | Geschäftsführer | Glan Honddu House Llandefaelog Fach LD3 9PP Brecon Powys | Wales | British | 1470180001 | |||||
| MCLAUGHLAN, Roger | Geschäftsführer | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | England | British | 206428840001 | |||||
| MORANT, Nicholas David | Geschäftsführer | Clenston Manor Winterborne Clenston DT11 0NX Blandford Forum Dorset | British | 58070440005 | ||||||
| MURPHY, Stephen Thomas | Geschäftsführer | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | England | British | 208190040001 | |||||
| MURPHY, Stephen Thomas | Geschäftsführer | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | United Kingdom | British | 207509410001 | |||||
| PIERPOINT, David Julian | Geschäftsführer | 33 West Street RH7 6QP Dormsland Rockvale Surrey | England | British | 138653690001 | |||||
| RATCLIFFE, Sarah Elizabeth | Geschäftsführer | 59b Grange Road SM2 6SP Sutton Surrey | England | British | 76162020001 | |||||
| SAJID, Salim | Geschäftsführer | Apple Croft 9 High Street HP17 8ES Haddenham | British | 75730550003 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei BLOOMS OF BRESSINGHAM LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blooms Of Bressingham Holdings Ltd | 06. Apr. 2016 | Syon Park, London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat BLOOMS OF BRESSINGHAM LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Security agreement | Erstellt am 24. Feb. 2009 Geliefert am 04. März 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All of its mortgaged property,investments,plant and machinery,credit balances see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of accession to the debenture | Erstellt am 12. Dez. 2007 Geliefert am 21. Dez. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben (For details of properties charged pleas. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 19. Sept. 2007 Geliefert am 01. Okt. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben L/H stevenage garden centre graveley road stevenage hertfordshire, L.h land at worcester garden centre droitwich road claines worcester t/no WR101937 fixed charge all buildings & other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the proeprty fixed charge all plant machinery & other items affixed to the property. Assignment of the rental sums together with the benefit of all rights & remedies fixed charge the proceeds of any claim made under any insurance policy relating to the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 19. Sept. 2007 Geliefert am 01. Okt. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the chargors to the finance parties (or any of them) on any acount whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben L/H stevenage garden centre graveley road stevenage hertfordshire, l/h land at worcester garden centre droitwich road claines worcester WR101937 fixed charge all buildings & other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the proeprty fixed charge all plant machinery & other items affixed to the property. Assignment of the rental sums together with the benefit of all rights & remedies fixed charge the proceeds of any claim made under any insurance policy relating to the property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of accession to a debenture | Erstellt am 29. März 2007 Geliefert am 17. Apr. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the chargors to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben For details of properties charged please. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of accession to a debenture | Erstellt am 29. März 2007 Geliefert am 17. Apr. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from a chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben For details of properties charged please. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 20. Feb. 2007 Geliefert am 24. Feb. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 07. Juli 2006 Geliefert am 11. Juli 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a land on the north west of the straight mile, bourton, rugby. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 07. Juli 2006 Geliefert am 11. Juli 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a worcester garden centre, droitwich road, claines, worcester. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 07. Juli 2006 Geliefert am 11. Juli 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a bicester garden centre, bicester, oxfordshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge over credit balances | Erstellt am 16. März 2006 Geliefert am 24. März 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Details of charged account: barclays bank PLC re blooms of bressingham limited current account numbered 53617580. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 19. Dez. 2003 Geliefert am 23. Dez. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £2,500,000.00 due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben St mellons park garden centre newport road cardiff t/no WA652616. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 08. Okt. 2002 Geliefert am 10. Okt. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The l/h property k/a finebush nurseries hay lane studley grange swindon wiltshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 16. Mai 2001 Geliefert am 24. Mai 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 16. Mai 2001 Geliefert am 18. Mai 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys and liabilities due or to become due from the company to the chargee as trustee for the holders of the convertible secured loan stock of blooms of bressingham holdings PLC as the same is contributed by an instrument of even date and executed by blooms of bressingham holdings PLC | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 08. Mai 2000 Geliefert am 11. Mai 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/Hold land/blds at bicester garden centre,bicester,oxfordshire. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 08. Mai 2000 Geliefert am 11. Mai 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/Hold land/blds at bressingham,diss,norfolk. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 13. März 2000 Geliefert am 16. März 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H bicester garden centre bicester oxfordshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 28. Feb. 2000 Geliefert am 03. März 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 15. März 1999 Geliefert am 30. März 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 15. März 1999 Geliefert am 25. März 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company,formerly known as steelray no.127 Limited,to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Plant centre building/offices and surrounding car parking/hard standing area at bressingham,diss,norfolk. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0