WALTHAM CROSS INVESTMENTS LIMITED
Überblick
Unternehmensname | WALTHAM CROSS INVESTMENTS LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 03659957 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von WALTHAM CROSS INVESTMENTS LIMITED?
- Kauf und Verkauf eigener Immobilien (68100) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich WALTHAM CROSS INVESTMENTS LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 228 Bournemouth Road Chandler's Ford SO53 3AF Eastleigh |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von WALTHAM CROSS INVESTMENTS LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
ALCHEMIST INVESTMENTS LIMITED | 25. Okt. 2004 | 25. Okt. 2004 |
BARONSGATE INVESTMENTS LIMITED | 27. Okt. 1998 | 27. Okt. 1998 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WALTHAM CROSS INVESTMENTS LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2019 |
Welche sind die letzten Einreichungen für WALTHAM CROSS INVESTMENTS LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Juni 2019 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 27. Okt. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Juni 2018 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 27. Okt. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Juni 2017 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 27. Okt. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2016 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 27. Okt. 2016 mit Aktualisierungen | 6 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2015 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 27. Okt. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2014 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 27. Okt. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Sean Patrick Gillies am 06. Nov. 2014 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2013 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 27. Okt. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Dez. 2012 bis 29. Juni 2013 | 3 Seiten | AA01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * Aah Den House Maidenhead Road Windsor Berkshire SL4 5UB England* am 07. Nov. 2012 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 27. Okt. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Sean Patrick Gillies am 07. Nov. 2012 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Mr Brian Gillies am 13. Juni 2012 | 2 Seiten | CH03 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von WALTHAM CROSS INVESTMENTS LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILLIES, Brian | Sekretär | Bournemouth Road Chandler's Ford SO53 3AF Eastleigh 228 Hampshire United Kingdom | Scottish | Surveyor | 60956920005 | |||||
GILLIES, Sean Patrick | Geschäftsführer | Bournemouth Road Chandler's Ford SO53 3AF Eastleigh 228 | England | British | Surveyor | 56790600004 | ||||
GILLIES, Sean Patrick | Sekretär | 17 Riverway Barry Avenue SL4 5JA Windsor | British | Surveyor | 56790600002 | |||||
GILLIES, Sian Caroline Brook | Sekretär | 6 Kirklee Terrace G12 0TQ Glasgow | British | 60956910004 | ||||||
GILLIES, Brian | Geschäftsführer | 7 Boclair Road Bearsden G61 2AE Glasgow | United Kingdom | Scottish | Surveyor | 60956920005 | ||||
GILLIES, Sian Caroline Brook | Geschäftsführer | 6 Kirklee Terrace G12 0TQ Glasgow | British | Administrator | 60956910004 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei WALTHAM CROSS INVESTMENTS LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört |
---|---|---|---|
Mr Brian Gillies | 27. Okt. 2016 | Bournemouth Road Chandler's Ford SO53 3AF Eastleigh 228 | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: Singapore | |||
Arten der Kontrolle
| |||
Mr Sean Patrick Gillies | 27. Okt. 2016 | Bournemouth Road Chandler's Ford SO53 3AF Eastleigh 228 | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
|
Hat WALTHAM CROSS INVESTMENTS LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Charge of deposit | Erstellt am 21. Dez. 2007 Geliefert am 10. Jan. 2008 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All deposits now and in the future credited to account designation 10320472 with the bank and any deposit or account of any other description or designation which derives in whole or in part from such deposits or account. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 12. Juli 2006 Geliefert am 26. Juli 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 117 high street stockton on tees t/no CE165183. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge of deposit | Erstellt am 04. Juli 2006 Geliefert am 08. Juli 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The deposit initially of £60,000 credited to account designation number 10320472 with the bank and any addition to that deposit and any deposit or account from time to time of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposit or account. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 03. Mai 2006 Geliefert am 24. Mai 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 125 and 125A high street waltham cross f/h t/n HD265918. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 31. Mai 2005 Geliefert am 07. Juni 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The property k/a 3 churchill precinct, dudley, west midlands t/no SF93480. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A standard security which was presented for registration in scotland on 26 july 2004 and | Erstellt am 23. Juni 2004 Geliefert am 31. Juli 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligant to the chargee | |
Kurze Angaben Shop and office premises at 34 charlott street stranraer. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 23. Juni 2004 Geliefert am 09. Juli 2004 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 14. Okt. 2000 Geliefert am 20. Okt. 2000 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H 3 the churchill precinct dudley west midlands t/no.SF93480. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 03. Nov. 1998 Geliefert am 11. Nov. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H 3 churchill precinct dudley. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0