WALTHAM CROSS INVESTMENTS LIMITED

WALTHAM CROSS INVESTMENTS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameWALTHAM CROSS INVESTMENTS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03659957
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von WALTHAM CROSS INVESTMENTS LIMITED?

    • Kauf und Verkauf eigener Immobilien (68100) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich WALTHAM CROSS INVESTMENTS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    228 Bournemouth Road
    Chandler's Ford
    SO53 3AF Eastleigh
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von WALTHAM CROSS INVESTMENTS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    ALCHEMIST INVESTMENTS LIMITED25. Okt. 200425. Okt. 2004
    BARONSGATE INVESTMENTS LIMITED27. Okt. 199827. Okt. 1998

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WALTHAM CROSS INVESTMENTS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2019

    Welche sind die letzten Einreichungen für WALTHAM CROSS INVESTMENTS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Juni 2019

    6 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 27. Okt. 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Juni 2018

    8 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 27. Okt. 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Juni 2017

    10 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 27. Okt. 2017 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2016

    8 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 27. Okt. 2016 mit Aktualisierungen

    6 SeitenCS01

    Beschlüsse

    Resolutions
    3 SeitenRESOLUTIONS
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name29. Apr. 2016

    Namensänderung durch Beschluss

    NM01
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name

    Beschluss zur Änderung der Firma am 27. Apr. 2016

    RES15

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2015

    8 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 27. Okt. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital04. Nov. 2015

    Kapitalaufstellung am 04. Nov. 2015

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2014

    8 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 27. Okt. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital07. Nov. 2014

    Kapitalaufstellung am 07. Nov. 2014

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Sean Patrick Gillies am 06. Nov. 2014

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2013

    8 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 27. Okt. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital18. Nov. 2013

    Kapitalaufstellung am 18. Nov. 2013

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Dez. 2012 bis 29. Juni 2013

    3 SeitenAA01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Aah Den House Maidenhead Road Windsor Berkshire SL4 5UB England* am 07. Nov. 2012

    1 SeitenAD01

    Jahresrückblick erstellt bis 27. Okt. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Sean Patrick Gillies am 07. Nov. 2012

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2011

    7 SeitenAA

    Änderung der Details des Sekretärs für Mr Brian Gillies am 13. Juni 2012

    2 SeitenCH03

    Wer sind die Geschäftsführer von WALTHAM CROSS INVESTMENTS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    GILLIES, Brian
    Bournemouth Road
    Chandler's Ford
    SO53 3AF Eastleigh
    228
    Hampshire
    United Kingdom
    Sekretär
    Bournemouth Road
    Chandler's Ford
    SO53 3AF Eastleigh
    228
    Hampshire
    United Kingdom
    ScottishSurveyor60956920005
    GILLIES, Sean Patrick
    Bournemouth Road
    Chandler's Ford
    SO53 3AF Eastleigh
    228
    Geschäftsführer
    Bournemouth Road
    Chandler's Ford
    SO53 3AF Eastleigh
    228
    EnglandBritishSurveyor56790600004
    GILLIES, Sean Patrick
    17 Riverway
    Barry Avenue
    SL4 5JA Windsor
    Sekretär
    17 Riverway
    Barry Avenue
    SL4 5JA Windsor
    BritishSurveyor56790600002
    GILLIES, Sian Caroline Brook
    6 Kirklee Terrace
    G12 0TQ Glasgow
    Sekretär
    6 Kirklee Terrace
    G12 0TQ Glasgow
    British60956910004
    GILLIES, Brian
    7 Boclair Road
    Bearsden
    G61 2AE Glasgow
    Geschäftsführer
    7 Boclair Road
    Bearsden
    G61 2AE Glasgow
    United KingdomScottishSurveyor60956920005
    GILLIES, Sian Caroline Brook
    6 Kirklee Terrace
    G12 0TQ Glasgow
    Geschäftsführer
    6 Kirklee Terrace
    G12 0TQ Glasgow
    BritishAdministrator60956910004

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei WALTHAM CROSS INVESTMENTS LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Mr Brian Gillies
    Bournemouth Road
    Chandler's Ford
    SO53 3AF Eastleigh
    228
    27. Okt. 2016
    Bournemouth Road
    Chandler's Ford
    SO53 3AF Eastleigh
    228
    Nein
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: Singapore
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 25%, aber nicht mehr als 50% der Anteile an der Gesellschaft.
    Mr Sean Patrick Gillies
    Bournemouth Road
    Chandler's Ford
    SO53 3AF Eastleigh
    228
    27. Okt. 2016
    Bournemouth Road
    Chandler's Ford
    SO53 3AF Eastleigh
    228
    Nein
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: England
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 25%, aber nicht mehr als 50% der Anteile an der Gesellschaft.

    Hat WALTHAM CROSS INVESTMENTS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Charge of deposit
    Erstellt am 21. Dez. 2007
    Geliefert am 10. Jan. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All deposits now and in the future credited to account designation 10320472 with the bank and any deposit or account of any other description or designation which derives in whole or in part from such deposits or account.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 10. Jan. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 12. Juli 2006
    Geliefert am 26. Juli 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    117 high street stockton on tees t/no CE165183. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 26. Juli 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Dez. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge of deposit
    Erstellt am 04. Juli 2006
    Geliefert am 08. Juli 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The deposit initially of £60,000 credited to account designation number 10320472 with the bank and any addition to that deposit and any deposit or account from time to time of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposit or account.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 08. Juli 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 03. Mai 2006
    Geliefert am 24. Mai 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    125 and 125A high street waltham cross f/h t/n HD265918. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 24. Mai 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 31. Mai 2005
    Geliefert am 07. Juni 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property k/a 3 churchill precinct, dudley, west midlands t/no SF93480. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 07. Juni 2005Registrierung einer Belastung (395)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 26 july 2004 and
    Erstellt am 23. Juni 2004
    Geliefert am 31. Juli 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligant to the chargee
    Kurze Angaben
    Shop and office premises at 34 charlott street stranraer.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 31. Juli 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Feb. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 23. Juni 2004
    Geliefert am 09. Juli 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 09. Juli 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 14. Okt. 2000
    Geliefert am 20. Okt. 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H 3 the churchill precinct dudley west midlands t/no.SF93480. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Okt. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 03. Nov. 1998
    Geliefert am 11. Nov. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H 3 churchill precinct dudley. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Nov. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Aug. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0