SHINE REALISATIONS (2) LIMITED

SHINE REALISATIONS (2) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameSHINE REALISATIONS (2) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03664814
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von SHINE REALISATIONS (2) LIMITED?

    • (1920) /

    Wo befindet sich SHINE REALISATIONS (2) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    C/O KPMG LLP
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von SHINE REALISATIONS (2) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    ANTLER GROUP LIMITED28. Feb. 200028. Feb. 2000
    DMWSL 256 LIMITED04. Nov. 199804. Nov. 1998

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SHINE REALISATIONS (2) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2008

    Welche sind die letzten Einreichungen für SHINE REALISATIONS (2) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 12. Mai 2011

    17 Seiten2.24B

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung am 12. Mai 2011

    17 Seiten2.35B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 18. Nov. 2010

    16 Seiten2.24B

    Beendigung der Bestellung von Kay Twine als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    1 SeitenF2.18

    Vermögensübersicht mit Formular 2.15B/2.14B

    9 Seiten2.16B

    Vorschlag des Verwalters

    25 Seiten2.17B

    Beendigung der Bestellung von Robert Woodcock als Sekretär

    2 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Robert Woodcock als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Gary Capell als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Pilot Works Alfred Street Bury Lancashire BL9 9EF am 26. Mai 2010

    2 SeitenAD01

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Section 175 07/05/2010
    RES13

    Beschlüsse

    Resolutions
    3 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name

    Beschluss zur Änderung der Firma am 19. Mai 2010

    RES15

    Hinweis auf Namensänderung

    2 SeitenCONNOT

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008

    17 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 04. Nov. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital11. Nov. 2009

    Kapitalaufstellung am 11. Nov. 2009

    • Kapital: GBP 298,649
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Robert Jeffrey Woodcock am 04. Nov. 2009

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Gary Richard Laurence Capell am 04. Nov. 2009

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Kay Twine am 04. Nov. 2009

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Robert Jeffrey Woodcock am 04. Nov. 2009

    1 SeitenCH03

    legacy

    4 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007

    13 SeitenAA

    legacy

    8 Seiten363a

    Wer sind die Geschäftsführer von SHINE REALISATIONS (2) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    WOODCOCK, Robert Jeffrey
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    Sekretär
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    British18278130002
    DM COMPANY SERVICES LIMITED
    16 Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    Midlothian
    Bevollmächtigter Sekretär
    16 Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    Midlothian
    900000320001
    BRIDGE, Patricia
    Little Fairway
    114 Chatsworth Road, Manchester
    M28 2NT Manchester
    Geschäftsführer
    Little Fairway
    114 Chatsworth Road, Manchester
    M28 2NT Manchester
    British116690650001
    CAPELL, Gary Richard Laurence
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    Geschäftsführer
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    EnglandBritish36562010001
    COATES, Scott Terrence
    17 Buckingham Terrace
    EH4 3AD Edinburgh
    Geschäftsführer
    17 Buckingham Terrace
    EH4 3AD Edinburgh
    British92931280001
    KEARNEY, Douglas Richard
    11 Eastwoodmains Road
    G46 6QB Glasgow
    Geschäftsführer
    11 Eastwoodmains Road
    G46 6QB Glasgow
    ScotlandBritish93762430001
    MACFIE, Andrew James
    9 Corrennie Gardens
    EH10 6DG Edinburgh
    Geschäftsführer
    9 Corrennie Gardens
    EH10 6DG Edinburgh
    ScotlandBritish33487610001
    MILLER, Alasdair
    3 Gleneagles Drive
    G77 5UA Newton Mearns
    Glasgow
    Geschäftsführer
    3 Gleneagles Drive
    G77 5UA Newton Mearns
    Glasgow
    British76651710001
    PHILLIPS, William Mark
    496 Lanark Road
    EH14 5DH Juniper Green
    Midlothian
    Geschäftsführer
    496 Lanark Road
    EH14 5DH Juniper Green
    Midlothian
    ScotlandBritish66183430001
    RILEY, Stephen
    28 Hornton Street
    W8 4NR London
    Geschäftsführer
    28 Hornton Street
    W8 4NR London
    EnglandBritish80604480001
    STEVENS, Hugh Nigel
    Little Cobblers 3 Copners Drive
    Holmer Green
    HP15 6SG High Wycombe
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Little Cobblers 3 Copners Drive
    Holmer Green
    HP15 6SG High Wycombe
    Buckinghamshire
    British38584300001
    TWINE, Kay
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    Geschäftsführer
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    EnglandBritish114886670001
    WOODCOCK, Robert Jeffrey
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    Geschäftsführer
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    EnglandBritish18278130002
    WREFORD, Brian William
    6 The Dingle
    WA13 0AE Lymm
    Cheshire
    Geschäftsführer
    6 The Dingle
    WA13 0AE Lymm
    Cheshire
    British18278160001
    25 NOMINEES LIMITED
    Royal London House
    22-25 Finsbury Square
    EC2A 1DX London
    Geschäftsführer
    Royal London House
    22-25 Finsbury Square
    EC2A 1DX London
    42409900001

    Hat SHINE REALISATIONS (2) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 08. Juni 2004
    Geliefert am 24. Juni 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The property k/a land and buildings situated at and k/a pilot works, alfred street, bury, lancs t/no LA324526. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Private Equity Limited
    Transaktionen
    • 24. Juni 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 08. Juni 2004
    Geliefert am 19. Juni 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 19. Juni 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 08. Juni 2004
    Geliefert am 19. Juni 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a land and buildings k/a pilot works, alfred street, bury, lancs, t/n LA324526. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 19. Juni 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Assignment of life policy
    Erstellt am 01. Aug. 2000
    Geliefert am 12. Aug. 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the finance documents (as defined)
    Kurze Angaben
    The benefit of the policy of life assurance on patricia bridge with canada life LTD,policy no.3451816 Dated 22/1/2000.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland,as Agent and Security Trustee for Itself Andeach of the Lenders (As Defined)
    Transaktionen
    • 12. Aug. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    Assignment of life policy
    Erstellt am 01. Aug. 2000
    Geliefert am 12. Aug. 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under all or any of the finance documents (as defined)
    Kurze Angaben
    Life of robert jeffrey woodcock with zurich life assurance company LTD,policy no.E19087C-000-000 dated 2/11/99 with all benefits thereon.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland,as Agent and Security Trustee for Itself Andeach of the Lenders (As Defined)
    Transaktionen
    • 12. Aug. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 09. Juli 1999
    Geliefert am 16. Juli 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies, costs, charges, expenses, liabilities and obligations due or to become due from the company to the chargee under all or any of the finance documents (as defined)
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Agent and Security Trustee for Itself and Each of the Lenders (As Defined)
    Transaktionen
    • 16. Juli 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 09. Juli 1999
    Geliefert am 16. Juli 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies, costs, charges, expenses, liabilities and obligations due or to become due from the company to the chargee under all or any of the finance documents (as defined)
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage f/h land & buildings k/a pilot works alfred street bury lancashire t/n-LA324526. By way of fixed charge the charged assets and the proceeds of any insurance from time to time relating to the property or the charged assets.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Agent and Security Trustee for Itself and Each of the Lenders (As Defined)
    Transaktionen
    • 16. Juli 1999Registrierung einer Belastung (395)

    Hat SHINE REALISATIONS (2) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    12. Mai 2011Ende der Verwaltung
    19. Mai 2010Beginn der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Brian Green
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    Praktiker
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    David James Costley-Wood
    Kpmg Llp
    St James Square
    M2 6DS Manchester
    Praktiker
    Kpmg Llp
    St James Square
    M2 6DS Manchester

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0