BROADWAY PLAZA (BIRMINGHAM CHILDREN'S HOSPITAL) LIMITED

BROADWAY PLAZA (BIRMINGHAM CHILDREN'S HOSPITAL) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameBROADWAY PLAZA (BIRMINGHAM CHILDREN'S HOSPITAL) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03671773
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von BROADWAY PLAZA (BIRMINGHAM CHILDREN'S HOSPITAL) LIMITED?

    • (7011) /

    Wo befindet sich BROADWAY PLAZA (BIRMINGHAM CHILDREN'S HOSPITAL) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Anglian House
    Ambury Road
    PE29 3NZ Huntingdon
    Cambridgeshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von BROADWAY PLAZA (BIRMINGHAM CHILDREN'S HOSPITAL) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    MORRISON PROPERTY SOLUTIONS (BIRMINGHAM CHILDREN'S HOSPITAL) LIMITED05. Jan. 199905. Jan. 1999
    CHOQS 317 LIMITED23. Nov. 199823. Nov. 1998

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BROADWAY PLAZA (BIRMINGHAM CHILDREN'S HOSPITAL) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2010

    Welche sind die letzten Einreichungen für BROADWAY PLAZA (BIRMINGHAM CHILDREN'S HOSPITAL) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010

    3 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 28. Nov. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital09. Dez. 2010

    Kapitalaufstellung am 09. Dez. 2010

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009

    3 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 28. Nov. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008

    3 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    4 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007

    11 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006

    11 SeitenAA

    legacy

    6 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2005

    11 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von BROADWAY PLAZA (BIRMINGHAM CHILDREN'S HOSPITAL) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    SHEPHEARD, Geoffrey Arthur George
    Red Tiles
    62 Park Road
    GU22 7DB Woking
    Surrey
    Sekretär
    Red Tiles
    62 Park Road
    GU22 7DB Woking
    Surrey
    British143104990001
    DONNELLY, Anthony
    1 Old Kirk Road
    Corstorphine
    EH12 6JY Edinburgh
    Geschäftsführer
    1 Old Kirk Road
    Corstorphine
    EH12 6JY Edinburgh
    United KingdomBritish109258700001
    TULLY, Robert Charles
    29 Balmuir Avenue
    EH48 4BW Bathgate
    West Lothian
    Geschäftsführer
    29 Balmuir Avenue
    EH48 4BW Bathgate
    West Lothian
    United KingdomBritish48389830002
    FOX, Jacqueline Elizabeth
    Little Dormers
    3 Wicken Road
    CB11 3QD Newport
    Essex
    Sekretär
    Little Dormers
    3 Wicken Road
    CB11 3QD Newport
    Essex
    British35460890004
    GILLEN, Seamus Joseph
    20 Mountway
    EN6 1EP Potters Bar
    Hertfordshire
    Sekretär
    20 Mountway
    EN6 1EP Potters Bar
    Hertfordshire
    British66174560001
    MORRISON, John
    Willis Mar,13 Glen Brae
    FK1 5LH Falkirk
    Sekretär
    Willis Mar,13 Glen Brae
    FK1 5LH Falkirk
    British54477430001
    TURNER, David Charles
    13 Thorndales
    St Johns Avenue
    CM14 5DE Brentwood
    Essex
    Sekretär
    13 Thorndales
    St Johns Avenue
    CM14 5DE Brentwood
    Essex
    Other84007940001
    C H REGISTRARS LIMITED
    35 Old Queen Street
    SW1H 9JD London
    Sekretär
    35 Old Queen Street
    SW1H 9JD London
    39694450001
    BOTHWELL, Karen Margaret
    68 Ravelston Dykes
    EH12 6HF Edinburgh
    Midlothian
    Geschäftsführer
    68 Ravelston Dykes
    EH12 6HF Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish34800860003
    CUMMINGS, Peter Joseph
    Glen View
    6 Barloan Crescent
    G82 2AT Dumbarton
    Dunbartonshire
    Geschäftsführer
    Glen View
    6 Barloan Crescent
    G82 2AT Dumbarton
    Dunbartonshire
    ScotlandBritish68241910003
    GRAY, John Colin
    24 Fox Covert
    DY8 3TW Stourbridge
    West Midlands
    Geschäftsführer
    24 Fox Covert
    DY8 3TW Stourbridge
    West Midlands
    British1043660002
    HOPE, John Alexander
    Eildon, 17 Craigielaw Park
    Aberlady
    EH32 0PR Longniddry
    East Lothian
    Geschäftsführer
    Eildon, 17 Craigielaw Park
    Aberlady
    EH32 0PR Longniddry
    East Lothian
    United KingdomBritish71318590003
    HOWELL, Keith Martin
    Lynehurst Carlops Road
    EH46 7DS West Linton
    Peeblesshire
    Geschäftsführer
    Lynehurst Carlops Road
    EH46 7DS West Linton
    Peeblesshire
    British1499960006
    JEFFERSON, Andrew Gordon
    17 Belgrave Road
    EH12 6NG Edinburgh
    Midlothian
    Geschäftsführer
    17 Belgrave Road
    EH12 6NG Edinburgh
    Midlothian
    British63406350001
    MCDONALD, Derek
    8 Glen Sannox Grove
    Craigmarloch
    G68 0GH Cumbernauld
    Geschäftsführer
    8 Glen Sannox Grove
    Craigmarloch
    G68 0GH Cumbernauld
    ScotlandBritish190466700001
    MCDONALD, Derek
    8 Glen Sannox Grove
    Craigmarloch
    G68 0GH Cumbernauld
    Geschäftsführer
    8 Glen Sannox Grove
    Craigmarloch
    G68 0GH Cumbernauld
    ScotlandBritish190466700001
    MIDDLETON, Douglas Alister
    16 Wesley Crescent
    Bonnyrigg
    EH19 3RT Edinburgh
    Geschäftsführer
    16 Wesley Crescent
    Bonnyrigg
    EH19 3RT Edinburgh
    British73738070001
    MOHAMMED, Ashraf
    7e Highfield Road
    HA6 1EF Northwood
    Middlesex
    Geschäftsführer
    7e Highfield Road
    HA6 1EF Northwood
    Middlesex
    British54901250001
    MURRAY, Alan Adams
    3 Otterburn Park
    EH14 1JX Edinburgh
    Midlothian
    Geschäftsführer
    3 Otterburn Park
    EH14 1JX Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish559270001
    ROBB, Gordon William
    7 High Buckstone
    Fairmilehead
    EH10 6XS Edinburgh
    Midlothian
    Geschäftsführer
    7 High Buckstone
    Fairmilehead
    EH10 6XS Edinburgh
    Midlothian
    British11456230001
    RUSSELL, Peter
    52 Moorfield
    Edgeworth
    BL7 0DH Bolton
    Manchester
    Geschäftsführer
    52 Moorfield
    Edgeworth
    BL7 0DH Bolton
    Manchester
    EnglandBritish10920180001
    RUSSELL, Peter
    52 Moorfield
    Edgeworth
    BL7 0DH Bolton
    Manchester
    Geschäftsführer
    52 Moorfield
    Edgeworth
    BL7 0DH Bolton
    Manchester
    EnglandBritish10920180001
    WALLACE, Lesley Ann
    8 Cranberry Drive
    BL3 4TB Bolton
    Lancashire
    Geschäftsführer
    8 Cranberry Drive
    BL3 4TB Bolton
    Lancashire
    British64383520003
    WRIGHT, Martin James
    Well Cottage
    Well House Lane
    RH15 0BN Burgess Hill
    West Sussex
    Geschäftsführer
    Well Cottage
    Well House Lane
    RH15 0BN Burgess Hill
    West Sussex
    United KingdomBritish4403900006

    Hat BROADWAY PLAZA (BIRMINGHAM CHILDREN'S HOSPITAL) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 12. Aug. 2003
    Geliefert am 01. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All the f/h and l/h property including land known as the former birmingham's children's hospital and institute of child health,ladywood middleway and francis road edgbaston t/no's WM65763 and WM66221. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Awg Group Limited
    Transaktionen
    • 01. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Aug. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 27. Jan. 2000
    Geliefert am 04. Feb. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land k/a the former birmingham childrens hospital and institute of child health ladywood middleway and francis road edgbaston t/no. WM657963 and WM662221. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandin Its Capacity as Security Trustee for the Stockholders
    Transaktionen
    • 04. Feb. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Aug. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 27. Jan. 2000
    Geliefert am 04. Feb. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land known as the former birmingham childrens hospital and institute of child health ladywood middleway and francis road edgbaston t/no. WM657963 & wm 662221. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 04. Feb. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Aug. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Security agreement
    Erstellt am 27. Jan. 2000
    Geliefert am 04. Feb. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The rental account held by the company with the bank and such new account or accounts as may be opened relative to all rent and other monies due to the company for the benefit of the company under any agreements to lease or any leas and are charged by the charge.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 04. Feb. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Aug. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Assignment of performance bond
    Erstellt am 27. Jan. 2000
    Geliefert am 04. Feb. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies and obligations due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facility letter of even date and the bank documents
    Kurze Angaben
    The whole right title and interest in and to a performace bond dated 19 january 2000 by hermes kreditverscherings ag.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 04. Feb. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Aug. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Assignment of vat payments
    Erstellt am 27. Jan. 2000
    Geliefert am 04. Feb. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies and obligations due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility letter dated 27 january 2000
    Kurze Angaben
    The whole right title and interest in all payments repayments and refunds relating to value added tax and any other amounts due from customs & excise to the company under or pursuant to the value added tax act 1994 or other relevant legislation.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 04. Feb. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Aug. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 27. Jan. 2000
    Geliefert am 29. Jan. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property known as broadway plaza lady middleway edgbaston birmingham title numbers WM657963 and WM662221. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 29. Jan. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Aug. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0