OPAL AIGBURTH LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameOPAL AIGBURTH LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03673651
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von OPAL AIGBURTH LIMITED?

    • Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen
    • Verwaltung von Immobilien auf Provisions- oder Vertragsbasis (68320) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich OPAL AIGBURTH LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    c/o KPMG LLP
    Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SD Reading
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von OPAL AIGBURTH LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    HARRINGTON GENERAL TRADERS LIMITED25. Nov. 199825. Nov. 1998

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von OPAL AIGBURTH LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2012

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für OPAL AIGBURTH LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für OPAL AIGBURTH LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 12. Sept. 2014

    20 Seiten2.24B

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung am 12. Sept. 2014

    19 Seiten2.35B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 24. Juli 2014

    20 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 24. Jan. 2014

    58 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 24. Jan. 2014

    46 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 18. Sept. 2013

    50 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Ernennung eines Ersatz-/Zusatzadministrators

    1 Seiten2.40B

    Mitteilung über die Amtsniederlegung durch den Administrator

    10 Seiten2.39B

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    1 SeitenF2.18

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    1 SeitenF2.18

    Vorschlag des Verwalters

    72 Seiten2.17B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    4 Seiten2.16B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Opal Property Group the Place Ducie Street Manchester M1 2TP am 04. Apr. 2013

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2012

    18 SeitenAA

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2011

    18 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 25. Nov. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital11. Dez. 2012

    Kapitalaufstellung am 11. Dez. 2012

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Jahresrückblick erstellt bis 25. Nov. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2010

    14 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 25. Nov. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Ernennung von Mr Craig Allan Mellor als Direktor

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Gavin Robert Duncan als Direktor

    2 SeitenAP01

    Wer sind die Geschäftsführer von OPAL AIGBURTH LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    MELLOR, Craig Allan
    21 Queenston Road
    Didsbury
    M20 2NX Manchester
    Sekretär
    21 Queenston Road
    Didsbury
    M20 2NX Manchester
    British60906780002
    DUNCAN, Gavin Robert
    c/o Kpmg Llp
    Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SD Reading
    Geschäftsführer
    c/o Kpmg Llp
    Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SD Reading
    EnglandBritish151512820001
    MELLOR, Craig Allan
    c/o Kpmg Llp
    Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SD Reading
    Geschäftsführer
    c/o Kpmg Llp
    Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SD Reading
    EnglandBritish60906780002
    WALL, Stuart Barrie
    Old Acres
    Well Bank Lane Over Peover
    WA16 8UN Knutsford
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Old Acres
    Well Bank Lane Over Peover
    WA16 8UN Knutsford
    Cheshire
    United KingdomBritish95010340001
    TEMPLE SECRETARIES LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Bevollmächtigter Sekretär
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001120001
    MARTIN, Graham Hunter
    Rosegarth
    51 Adlington Road
    SK9 2BJ Wilmslow
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Rosegarth
    51 Adlington Road
    SK9 2BJ Wilmslow
    Cheshire
    British87259480001
    COMPANY DIRECTORS LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001110001

    Hat OPAL AIGBURTH LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 05. Feb. 2002
    Geliefert am 18. Feb. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land and buildings on the south west side of st michael's church road liverpool t/n MS417557 MS421784 and MS450717. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 18. Feb. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Assignment of rental income
    Erstellt am 17. Sept. 1999
    Geliefert am 01. Okt. 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All right,title and interest in the rents and other rights/remedies arising out of or in connection with any failure by the tenants to pay the rents. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 01. Okt. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge creating fixed and floating charges
    Erstellt am 17. Sept. 1999
    Geliefert am 28. Sept. 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/Hold land on south west side of st.michael's church rd,liverpool,merseyside; t/no MS127739. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 28. Sept. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 17. Sept. 1999
    Geliefert am 28. Sept. 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee whether or not the chargee shall have been an original party to the relevant transaction
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 28. Sept. 1999Registrierung einer Belastung (395)

    Hat OPAL AIGBURTH LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    19. März 2013Beginn der Verwaltung
    12. Sept. 2014Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Robert Andrew Croxen
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praktiker
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    David John Crawshaw
    Kpmg Llp 8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praktiker
    Kpmg Llp 8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Jane Bronwen Moriarty
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praktiker
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0