TEAMRESPECT LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameTEAMRESPECT LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03674378
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von TEAMRESPECT LIMITED?

    • (5530) /

    Wo befindet sich TEAMRESPECT LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    10-12 New College Parade Finchley Road
    Hampstead
    NW3 5EP London
    United Kingdom
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TEAMRESPECT LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2011

    Welche sind die letzten Einreichungen für TEAMRESPECT LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    14 Seiten4.72

    Insolvenzmeldung

    INSOLVENCY:MISCELLANEOUS:-Notice of Common Law disclaimer
    1 SeitenLIQ MISC

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    3 SeitenF10.2

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    3 SeitenF10.2

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    2 SeitenF10.2

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    2 SeitenF10.2

    Vermögensübersicht mit Formular 4.19

    6 Seiten4.20

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren am 08. Dez. 2011

    LRESEX

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2011

    5 SeitenAA

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 129 Allenby Road Leeds LS11 5RR am 02. Dez. 2011

    1 SeitenAD01

    Jahresrückblick erstellt bis 26. Nov. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital12. Jan. 2011

    Kapitalaufstellung am 12. Jan. 2011

    • Kapital: GBP 1,000
    SH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2010

    4 SeitenAA

    Ernennung von Miss Wendy Wai Ming Wong als Sekretär

    1 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Fat Wong als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Jahresrückblick erstellt bis 26. Nov. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Wendy Wai Ming Wong am 10. Jan. 2010

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2009

    4 SeitenAA

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2008

    4 SeitenAA

    legacy

    7 Seiten363a

    legacy

    5 Seiten363a

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2007

    4 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten287

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2006

    5 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von TEAMRESPECT LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    WONG, Wendy Wai Ming
    71 Whitworth Street
    M1 6LQ Manchester
    38
    United Kingdom
    Sekretär
    71 Whitworth Street
    M1 6LQ Manchester
    38
    United Kingdom
    150390700001
    WONG, Wendy Wai Ming
    38 Lancaster House
    71 Whitworth Street
    M1 6LQ Manchester
    Geschäftsführer
    38 Lancaster House
    71 Whitworth Street
    M1 6LQ Manchester
    United KingdomBritish82739750001
    KWANG, David Wai
    17 Bluebell Dene
    NE5 4DF Newcastle Upon Tyne
    Sekretär
    17 Bluebell Dene
    NE5 4DF Newcastle Upon Tyne
    British62037000001
    KWANG, Wai
    17 Bluebell Dene
    Westerhope
    NE5 4DF Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Sekretär
    17 Bluebell Dene
    Westerhope
    NE5 4DF Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British76559760001
    LOK, Sui Fong
    35 Baronswood
    Gosforth
    NE3 3UB Newcastle Upon Tyne
    Sekretär
    35 Baronswood
    Gosforth
    NE3 3UB Newcastle Upon Tyne
    British26655860002
    TSANG, Hin Chor
    32 Northumberland Avenue
    NE3 4XH Gosforth
    Tyne & Wear
    Sekretär
    32 Northumberland Avenue
    NE3 4XH Gosforth
    Tyne & Wear
    British91290790001
    WONG, Fat Hing
    25 Peel Street
    CA2 7AS Carlisle
    Sekretär
    25 Peel Street
    CA2 7AS Carlisle
    British82949960001
    JL NOMINEES TWO LIMITED
    1 Saville Chambers
    5 North Street
    NE1 8DF Newcastle Upon Tyne
    Bevollmächtigter Sekretär
    1 Saville Chambers
    5 North Street
    NE1 8DF Newcastle Upon Tyne
    900007220001
    KWANG, David Wai
    17 Bluebell Dene
    NE5 4DF Newcastle Upon Tyne
    Geschäftsführer
    17 Bluebell Dene
    NE5 4DF Newcastle Upon Tyne
    British62037000001
    LOK, Chu Lung
    35 Baronswood
    Gosforth
    NE3 3UB Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    35 Baronswood
    Gosforth
    NE3 3UB Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British65212090002
    LOK, Sui Fong
    35 Baronswood
    Gosforth
    NE3 3UB Newcastle Upon Tyne
    Geschäftsführer
    35 Baronswood
    Gosforth
    NE3 3UB Newcastle Upon Tyne
    British26655860002
    TSANG, Hin Chor
    32 Northumberland Avenue
    NE3 4XH Gosforth
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    32 Northumberland Avenue
    NE3 4XH Gosforth
    Tyne & Wear
    British91290790001
    WONG, Koon Chung
    1 Abbots Way
    Preston Farm
    NE16 4DB Northshed
    Newcastle Upon Tyne
    Geschäftsführer
    1 Abbots Way
    Preston Farm
    NE16 4DB Northshed
    Newcastle Upon Tyne
    British81163310001
    WONG, Koon Chung
    1 Abbots Way
    Preston Farm
    NE16 4DB Northshed
    Newcastle Upon Tyne
    Geschäftsführer
    1 Abbots Way
    Preston Farm
    NE16 4DB Northshed
    Newcastle Upon Tyne
    British81163310001
    JL NOMINEES ONE LIMITED
    1 Saville Chambers
    5 North Street
    NE1 8DF Newcastle Upon Tyne
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    1 Saville Chambers
    5 North Street
    NE1 8DF Newcastle Upon Tyne
    900007210001

    Hat TEAMRESPECT LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal mortgage
    Erstellt am 29. Okt. 2004
    Geliefert am 10. Nov. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a apartment 20 george street trading house george street nottingham. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Nov. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 23. März 2004
    Geliefert am 31. März 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property at 7 george street nottingham. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 31. März 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Aug. 2003
    Geliefert am 27. Aug. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The leasehold property situate at and known as flat 23 lancaster house 71 whitworth street manchester M1 6LQ title number GM588089.
    Berechtigte Personen
    • Bank of China
    Transaktionen
    • 27. Aug. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 24. März 2003
    Geliefert am 29. März 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. März 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 23. März 2003
    Geliefert am 11. Apr. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The l/h property k/a bryward house, commercial street, sheffield. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Apr. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 23. Aug. 2002
    Geliefert am 06. Sept. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    20 lancaster house, 71 whitworth street, manchester.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 06. Sept. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Rent security deposit deed
    Erstellt am 06. Dez. 2000
    Geliefert am 15. Dez. 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease dated 6TH december 2000
    Kurze Angaben
    The sum of £27,500 deposited by the company with the chargee.
    Berechtigte Personen
    • Crown Dilmun (Dominion) Limited
    Transaktionen
    • 15. Dez. 2000Registrierung einer Belastung (395)

    Hat TEAMRESPECT LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    01. Mai 2013Aufgelöst am
    08. Dez. 2011Beginn der Liquidation
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Kian Seng Tan
    10-12 New College Parade
    Finchley Road
    NW3 5EP Londonj
    Praktiker
    10-12 New College Parade
    Finchley Road
    NW3 5EP Londonj

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0