IGROUP BDA LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameIGROUP BDA LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03675910
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von IGROUP BDA LIMITED?

    • Finanzintermediation sonst. n.n.a. (64999) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen

    Wo befindet sich IGROUP BDA LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von IGROUP BDA LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    OCWEN BDA LIMITED24. Nov. 199824. Nov. 1998

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von IGROUP BDA LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Nov. 2015

    Welche sind die letzten Einreichungen für IGROUP BDA LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    8 SeitenLIQ13

    Beendigung der Bestellung von Kalpna Shah als Sekretär am 28. Feb. 2018

    2 SeitenTM02

    Geänderte Geschäftsanschrift vom PO Box 2497 Building 4 Hatters Lane Watford WD18 1YY United Kingdom zum 30 Finsbury Square London EC2P 2YU am 07. März 2018

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 20. Feb. 2018

    LRESSP

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    5 SeitenLIQ01

    Bestätigungserklärung erstellt am 24. Nov. 2017 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von Richard William Bird als Geschäftsführer am 29. Sept. 2017

    1 SeitenTM01

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Nov. 2016 bis 31. Mai 2017

    1 SeitenAA01

    Beendigung der Bestellung von Laurence Anne Renee Perrin als Geschäftsführer am 30. Dez. 2016

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 24. Nov. 2016 mit Aktualisierungen

    10 SeitenCS01

    legacy

    1 SeitenSH20

    Kapitalaufstellung am 16. Nov. 2016

    • Kapital: GBP 1
    3 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Ernennung von Miss Samantha Jones als Direktor am 10. Okt. 2016

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Bernardus Petrus Maria Van Bunnik als Geschäftsführer am 01. Okt. 2016

    1 SeitenTM01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Building 4 Hatters Lane Croxley Green Business Park Watford Hertfordshire WD18 8YF zum PO Box 2497 Building 4 Hatters Lane Watford WD18 1YY am 23. Aug. 2016

    1 SeitenAD01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Nov. 2015

    23 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Manuel Uria-Fernandez als Geschäftsführer am 14. Juni 2016

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Richard William Bird als Direktor am 14. Juni 2016

    2 SeitenAP01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Manuel Uria-Fernandez am 17. Dez. 2015

    2 SeitenCH01

    Jahresrückblick erstellt bis 24. Nov. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital27. Nov. 2015

    Kapitalaufstellung am 27. Nov. 2015

    • Kapital: GBP 10,000,001
    SH01

    Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 15. Sept. 2015

    • Kapital: GBP 10,000,001
    3 SeitenSH01

    Wer sind die Geschäftsführer von IGROUP BDA LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    JONES, Samantha
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    Geschäftsführer
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    United KingdomBritish216074420001
    SHAH, Kalpna
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    Sekretär
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    199403700001
    SHAH, Kalpna
    18 Vicarage Road
    WD18 0EH Watford
    Hertfordshire
    Sekretär
    18 Vicarage Road
    WD18 0EH Watford
    Hertfordshire
    British80753870001
    FN SECRETARY LIMITED
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Sekretär
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    88740300002
    RUTLAND SECRETARIES LIMITED
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    Bevollmächtigter Sekretär
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    900005290001
    AINSWORTH, Keith
    76 Howes Lane
    Finham
    CV3 6PJ Coventry
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    76 Howes Lane
    Finham
    CV3 6PJ Coventry
    Warwickshire
    EnglandBritish46161840001
    BELLORA, Michael Richard
    Russet House
    1a Latchmoor Avenue
    SL9 8LL Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Russet House
    1a Latchmoor Avenue
    SL9 8LL Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    American98453650001
    BERRY, Duncan Gee
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    EnglandBritish107695600022
    BIRD, Richard William
    Building 4
    Hatters Lane
    WD18 1YY Watford
    PO BOX 2497
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Building 4
    Hatters Lane
    WD18 1YY Watford
    PO BOX 2497
    United Kingdom
    United KingdomBritish209298590001
    BOAKES, Jeremy Edward
    41 Sherrards Park Road
    AL8 7LD Welwyn Garden City
    Herts
    Geschäftsführer
    41 Sherrards Park Road
    AL8 7LD Welwyn Garden City
    Herts
    British106122240001
    BRENNAN, Peter
    10 Ardross Avenue
    HA6 3DS Northwood
    Middlesex
    Geschäftsführer
    10 Ardross Avenue
    HA6 3DS Northwood
    Middlesex
    British84912240001
    CAMERON, Ewan Douglas
    13 Heathfield Gardens
    W4 4JU London
    Geschäftsführer
    13 Heathfield Gardens
    W4 4JU London
    British122900270001
    CARSON, David Richard
    26 Loynells Road
    Rednal
    B45 9NP Birmingham
    Geschäftsführer
    26 Loynells Road
    Rednal
    B45 9NP Birmingham
    British73271960002
    CRICHTON, Susan Elizabeth
    The Pheasantries
    Ley Hill
    HP5 3QR Chesham
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    The Pheasantries
    Ley Hill
    HP5 3QR Chesham
    Buckinghamshire
    EnglandBritish69358970001
    DE RIDDER, Kimon Celicourt Macris, Dr
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish131081660001
    DEANE JOHNS, Simon Joshua
    61 Stanlake Road
    W12 7HG London
    Geschäftsführer
    61 Stanlake Road
    W12 7HG London
    Australian80748330001
    DLUTOWSKI, Joseph Arthur
    13127 Silver Fox Lane
    Palm Beach Gardens
    Palm Beach County 33418
    United States Of America
    Geschäftsführer
    13127 Silver Fox Lane
    Palm Beach Gardens
    Palm Beach County 33418
    United States Of America
    American66506120001
    ERBEY, William Charles
    110 Sunset Avenue Apartment 2b
    3947 Palm Beach
    Florida 33480-3947
    United Statesof America
    Geschäftsführer
    110 Sunset Avenue Apartment 2b
    3947 Palm Beach
    Florida 33480-3947
    United Statesof America
    American58072470001
    EVANS, Kellie Victoria
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish167417000001
    FERGUSON, Ian George
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish133318850001
    FLYNN, William John
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    British99330320002
    GARDEN, Robert James
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish152764360001
    GUNNIGLE, Clodagh
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomIrish138244630002
    HARRIS, Jeffrey
    9 Northaw Place
    Coopers Lane
    EN6 4NQ Northaw
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    9 Northaw Place
    Coopers Lane
    EN6 4NQ Northaw
    Hertfordshire
    American98233530002
    HARVEY, David
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish97086950001
    HARVEY, Richard John
    6 Heronsford
    West Hunsbury
    NN4 9XG Northampton
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    6 Heronsford
    West Hunsbury
    NN4 9XG Northampton
    Northamptonshire
    British122892160001
    HUNKIN, Ricky David
    2 Hockeridge View
    Oakwood
    HP4 3NB Berkhamsted
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    2 Hockeridge View
    Oakwood
    HP4 3NB Berkhamsted
    Hertfordshire
    British115390900001
    JOHAR, Mandeep Singh
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomIndian127046380002
    JOHNSON, Alec David
    12 The Witherings, Emerson Park
    RM11 2RA Hornchurch
    Essex
    Geschäftsführer
    12 The Witherings, Emerson Park
    RM11 2RA Hornchurch
    Essex
    United KingdomBritish103446140001
    KAGAN, Jeffrey Allan
    14 Norrice Lea
    N2 0RE London
    Geschäftsführer
    14 Norrice Lea
    N2 0RE London
    Australian78535300001
    MILLWARD, Keith Roger
    Le Marque Manor Close
    Penn
    HP10 8HZ High Wycombe
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Le Marque Manor Close
    Penn
    HP10 8HZ High Wycombe
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish80388420001
    PERRIN, Laurence Anne Renee
    Building 4
    Hatters Lane
    WD18 1YY Watford
    PO BOX 2497
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Building 4
    Hatters Lane
    WD18 1YY Watford
    PO BOX 2497
    United Kingdom
    United KingdomFrench183220720001
    PICKERING, Steven Mark
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United KingdomBritish164833430002
    PUNCH, Andrew Robert
    Pepys Way
    6 Ford Road
    GU24 9EJ Bisley
    Surrey
    Geschäftsführer
    Pepys Way
    6 Ford Road
    GU24 9EJ Bisley
    Surrey
    United KingdomBritish147703850001
    SANDERS, Colin George
    Burleigh Grange
    Nightingales Lane
    HP8 4SR Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Burleigh Grange
    Nightingales Lane
    HP8 4SR Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    British81421480002

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei IGROUP BDA LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Building 4
    Hatters Lane
    WD18 1YY Watford
    PO BOX 2497
    United Kingdom
    08. Sept. 2016
    Building 4
    Hatters Lane
    WD18 1YY Watford
    PO BOX 2497
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformLimited By Shares
    RegistrierungslandEngland And Wales
    RechtsgrundlageUnited Kingdom (England And Wales)
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer5128935
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.
    Hatters Lane
    2497
    WD18 1YY Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    Hatters Lane
    2497
    WD18 1YY Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Ja
    RechtsformUnlimited With Shares
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageUnited Kingdom (England)
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer06440028
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat IGROUP BDA LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Deed of charge
    Erstellt am 06. Apr. 2001
    Geliefert am 20. Apr. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All obligations (whether actual or contingent, present and future) of the company owing or owed to the chargee under the terms loan facility dated 1ST october 1999, the coupon facility dated 12TH january 2000, the coupon facility dated 26TH april 2000, the coupon facility dated 15TH august 2000, the coupon facility dated 20TH november 2000 and the finance documents
    Kurze Angaben
    By way of first fixed security all of the borrower's rights and benefits under the custody agreement; all of the borrower's rights title and interest in and to the coupon securities and all sums payable or which become payable in respect of the coupon securities;. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Apr. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Jan. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Pledge agreement
    Erstellt am 06. Apr. 2001
    Geliefert am 20. Apr. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All obligations (whether actual or contingent, present and future) of the company owing or owed to the chargee under the terms loan facility dated 1ST october 1999, the coupon facility dated 12TH january 2000, the coupon facility dated 26TH april 2000, the coupon facility dated 15TH august 2000, the coupon facility dated 20TH november 2000 and the finance documents
    Kurze Angaben
    The coupon securities and any cash balances standing from time to time to the credit of the collateral account (as more particularly defined in the pledge).
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Apr. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Jan. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of charge
    Erstellt am 20. Nov. 2000
    Geliefert am 30. Nov. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the term loan facility dated 1ST october 1999 and a deed of charge dated 1ST october 1999 and/or the coupon facility dated 12TH january 2000 and a deed of charge dated 12TH january 2000 and/or the coupon facility dated 26TH april 2000 and the deed of charge dated 26TH april 2000 and/or the coupon facility dated 15TH august 2000 and the deed of charge dated 15TH august 2000 and/or the finance documents (as defined) as such documents may be amended from time to time
    Kurze Angaben
    All of the borrower's rights and benefits under the custody agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Nov. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Jan. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Pledge agreement
    Erstellt am 20. Nov. 2000
    Geliefert am 30. Nov. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the term loan facility dated 1 october 1999 and a deed of charge of the same date and/or the coupon facility dated 12 january 2000 and a deed of charge of the same date and/or the coupon facility dated 26 april 2000 and a deed of charge of the same date and/or the coupon facility dated 15 august 2000 and a deed of charge of the same date and/or the finance documents (all as defined therein)
    Kurze Angaben
    The pledgor pledged the charged assets (as defined therein). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Nov. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Jan. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of charge
    Erstellt am 06. Sept. 2000
    Geliefert am 16. Sept. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the term loan facility dated 1 october 1999 and deed of charge dated 1 october 1999 and/or the coupon facility dated 12 january 2000 and a deed of charge dated 12 january 2000 and/or the finance documents
    Kurze Angaben
    By way of first fixed security all rights and benefits under the custody agreement and to the coupon securities and all sums payable in respect of the coupon securities and all rights title and interest in and to the coupon account. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Sept. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Jan. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Pledge agreement
    Erstellt am 06. Sept. 2000
    Geliefert am 16. Sept. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the term loan facility dated 1 october 1999 and deed of charge dated 1 october 1999 and/or the coupon facility dated 12 january 2000 and deed of charge dated 12 january 2000 and/or the finance documents
    Kurze Angaben
    The charged assets meaning the coupon securities and any cash balances standing from time to time to the credit of the collateral account. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Sept. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Jan. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Pledge agreement
    Erstellt am 15. Aug. 2000
    Geliefert am 24. Aug. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under (a) the term loan facility dated 1 october 1999 and a deed of charge dated 1 october 1999,(b) the coupon facility dated 12 january 2000 and a deed of charge dated 12 january 2000 and/or (c) the coupon facility dated 26 april 2000 and the deed of charge dated 26 april 2000 and/or (d) the finance documents (all terms as defined)
    Kurze Angaben
    The charged assets,as defined, and any cash balances from time to time standing to the credit of the collateral account. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Aug. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Jan. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of charge
    Erstellt am 15. Aug. 2000
    Geliefert am 24. Aug. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the term loan facility dated 01/10/99, the coupon facility dated 12/01/00 and 26/04/00 and the finance documents
    Kurze Angaben
    All of the borrowers rights and benefits under the custody agreement and other agreements and accounts the details of which are listed on the form 395.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Aug. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Jan. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Pledge agreement
    Erstellt am 12. Jan. 2000
    Geliefert am 20. Jan. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a term loan facility dated 1 october 1999
    Kurze Angaben
    The pledgor pledged the charged assets to the pledgee as security for the due perfrmance of the secured liabilities. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Jan. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Jan. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of charge
    Erstellt am 12. Jan. 2000
    Geliefert am 20. Jan. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a term loan facility dated 1 october 1999
    Kurze Angaben
    The borrower with full title guarantee and as continuing security for the secured liabilities by way of first fixed security all the rights and benefits under the custody agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Jan. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Jan. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of charge
    Erstellt am 01. Okt. 1999
    Geliefert am 12. Okt. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the term loan facility the guarantee the pledge agreement an any other document pursuant to which the company owes any obligation to the chargee from time to time
    Kurze Angaben
    All the company's rights and benefits under the custody agreement, all right title and interest in and to the charged securities and all monies derived therefrom and all of the company's right title benefit and interest in and to the ocwen bda limited account together with floating charge all present and future undertakings assets and rights not charged by way of fixed charge. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Okt. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Jan. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Pledge agreement
    Erstellt am 01. Okt. 1999
    Geliefert am 12. Okt. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies and obligations (whether actual or contingent, present or future) of the company to the chargee under the term loan facility, the guarantee and the deed of charge.
    Kurze Angaben
    The pledgor pledged the charged securities and any cash balances standing from time to time to the credit of the collateral account.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Okt. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Jan. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of charge
    Erstellt am 11. Juni 1999
    Geliefert am 25. Juni 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All obligations of the company to the chargee under the secured term loan facility dated 4TH december 1998 and the finance documents
    Kurze Angaben
    All the borrowers rights and benefits under the custody agreement, the coupon securities and all sums payable in respect of the coupon securities. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Juni 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Jan. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Pledge agreement
    Erstellt am 11. Juni 1999
    Geliefert am 25. Juni 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All obligations (whether actual or contingent, present or future) of the company to the chargee under (a) a secured term loan facility dated 4TH december 1998 and a deed of charge dated 4TH december 1998; and (b) the finance documents
    Kurze Angaben
    The pldgor pledged the charged assets to the pledgee,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Juni 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Jan. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of charge
    Erstellt am 04. Dez. 1998
    Geliefert am 18. Dez. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All obligations of the company to the chargee under the secured term loan facility dated 4TH december 1998
    Kurze Angaben
    All the borrowers rights and benefits under the custody agreement, the charged securities and all sums payable in respect of the charged securities. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Dez. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Jan. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat IGROUP BDA LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    20. Feb. 2018Beginn der Liquidation
    23. Nov. 2018Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Sean Kenneth Croston
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praktiker
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0