INDUSTRIOUS LEASEBACKS LIMITED

INDUSTRIOUS LEASEBACKS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameINDUSTRIOUS LEASEBACKS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03677203
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von INDUSTRIOUS LEASEBACKS LIMITED?

    • (7020) /

    Wo befindet sich INDUSTRIOUS LEASEBACKS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Copse Cottage Hunninhgam
    House Farm Hunningham
    CV33 9EW Leamington Spa
    Warwickshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von INDUSTRIOUS LEASEBACKS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    LEASEBACK LIMITED13. März 200013. März 2000
    SAVILLE GORDON PROPERTY SERVICES LIMITED13. Jan. 199913. Jan. 1999
    BOARDTRADE LIMITED02. Dez. 199802. Dez. 1998

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von INDUSTRIOUS LEASEBACKS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2007

    Welche sind die letzten Einreichungen für INDUSTRIOUS LEASEBACKS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    2 SeitenDS01

    legacy

    6 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007

    8 SeitenAA

    legacy

    6 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006

    10 SeitenAA

    legacy

    6 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2005

    10 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    6 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2004

    8 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    6 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288c

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2003

    10 SeitenAA

    Gesellschaftsvertrag und Satzung

    14 SeitenMA

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Satzung und/oder Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    legacy

    1 Seiten225

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2003

    13 SeitenAA

    legacy

    6 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    7 Seiten288a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2002

    14 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten88(2)R

    Wer sind die Geschäftsführer von INDUSTRIOUS LEASEBACKS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    MELIA, Ian Charles
    3 The Oaks
    Downs Avenue
    KT18 5HH Epsom
    Surrey
    Sekretär
    3 The Oaks
    Downs Avenue
    KT18 5HH Epsom
    Surrey
    British36647460001
    CAREY, Roger William
    Instow
    Burtons Way
    HP8 4BP Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Instow
    Burtons Way
    HP8 4BP Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish6069370001
    KEOGAN, John Stephen Philip
    Fox Cottage
    Market Square Kineton
    CV35 0LP Warwick
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    Fox Cottage
    Market Square Kineton
    CV35 0LP Warwick
    Warwickshire
    EnglandBritish60874620002
    MELIA, Ian Charles
    3 The Oaks
    Downs Avenue
    KT18 5HH Epsom
    Surrey
    Geschäftsführer
    3 The Oaks
    Downs Avenue
    KT18 5HH Epsom
    Surrey
    UkBritish36647460001
    EDWARDS, John William
    The Garden House Wolverton Road
    Norton Lindsey
    CV35 8LJ Warwickshire
    Sekretär
    The Garden House Wolverton Road
    Norton Lindsey
    CV35 8LJ Warwickshire
    British44610010001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Bevollmächtigter Sekretär
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ALEXANDER, Mark Henry Campbell
    Perrymill Farm
    Inkberrow
    WR7 4JQ Worcester
    Geschäftsführer
    Perrymill Farm
    Inkberrow
    WR7 4JQ Worcester
    United KingdomBritish60875240001
    SAVILLE, David John
    Avonside
    Grange Road Bidford On Avon
    B50 4BY Alcester
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    Avonside
    Grange Road Bidford On Avon
    B50 4BY Alcester
    Warwickshire
    British90607320001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Hat INDUSTRIOUS LEASEBACKS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 10. Dez. 2002
    Geliefert am 20. Dez. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the borrower (as defined) and the company to all or any of the secured parties (as defined) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H land and buildings on the west side of droitwich road worcester t/n HW26994 and f/h land on the north east side of graiseley hill, land and buildings on the south west side of graiseley hill and land lying to the south east of penn road wolverhampton west midlands t/n's WM465148, WM590384 and WM590391. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Morgan Stanley Mortgage Servicing Limited (The "Security Trustee")
    Transaktionen
    • 20. Dez. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage
    Erstellt am 13. Apr. 2000
    Geliefert am 14. Apr. 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee arising under clause 12 of a transfer of the property charged
    Kurze Angaben
    F/H property k/a land on the west side of droitwich road worcestershire t/n HW26994.
    Berechtigte Personen
    • Metal Castings Limited
    Transaktionen
    • 14. Apr. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage
    Erstellt am 13. Apr. 2000
    Geliefert am 14. Apr. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land on the north east side of graisley hill wolverhampton.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Apr. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Dez. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 13. Apr. 2000
    Geliefert am 14. Apr. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land and buildings on the west side of droitich road worcester. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Apr. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Dez. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 13. Apr. 2000
    Geliefert am 14. Apr. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land and buildings on the south west side of graveley hill and south east side of penn road wolverhampton. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Apr. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Dez. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 20. März 2000
    Geliefert am 27. März 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land on the north west side of spring road smethwick t/nos: WM489299, WM151113. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. März 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Dez. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture deed
    Erstellt am 09. Aug. 1999
    Geliefert am 24. Aug. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Aug. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Dez. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0