SOUTHERN CROSS HOME PROPERTIES LIMITED

SOUTHERN CROSS HOME PROPERTIES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameSOUTHERN CROSS HOME PROPERTIES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03679340
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von SOUTHERN CROSS HOME PROPERTIES LIMITED?

    • Sonstige menschliche Gesundheitsaktivitäten (86900) / Gesundheits- und Sozialwesen

    Wo befindet sich SOUTHERN CROSS HOME PROPERTIES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von SOUTHERN CROSS HOME PROPERTIES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    HIGHFIELD HOME PROPERTIES LIMITED04. Dez. 199804. Dez. 1998

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SOUTHERN CROSS HOME PROPERTIES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2010

    Welche sind die letzten Einreichungen für SOUTHERN CROSS HOME PROPERTIES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Beendigung der Bestellung von Francis Declan Finbar Tempany Mccormack als Sekretär am 09. Okt. 2012

    1 SeitenTM02

    Ernennung von Mr David Charles Lovett als Direktor am 31. Aug. 2012

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Timothy James Bolot als Geschäftsführer am 31. Aug. 2012

    1 SeitenTM01

    Mitteilung über den Abschluss des freiwilligen Vergleichs

    6 Seiten1.4

    Mitteilung an den Unternehmensregister über den Inkrafttreten des freiwilligen Vergleichs

    4 Seiten1.1

    Jahresrückblick erstellt bis 04. Dez. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital17. Dez. 2011

    Kapitalaufstellung am 17. Dez. 2011

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Beendigung der Bestellung von William James Buchan als Geschäftsführer am 15. Nov. 2011

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von David Andrew Smith als Geschäftsführer am 01. Nov. 2011

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Stephen Jonathan Taylor als Direktor am 26. Okt. 2011

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Timothy James Bolot als Direktor am 26. Okt. 2011

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Francis Declan Finbar Tempany Mccormack als Sekretär

    1 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von William Mcleish als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2010

    25 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Richard Midmer als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr David Andrew Smith als Direktor

    2 SeitenAP01

    Jahresrückblick erstellt bis 04. Dez. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01

    Beschlüsse

    Resolutions
    3 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Enter agreement 14/05/2010
    RES13

    Beendigung der Bestellung von Kamma Foulkes als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 27. Sept. 2009

    25 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Janette Malham als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 04. Dez. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01

    Beendigung der Bestellung von Philip Whitaker als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Wer sind die Geschäftsführer von SOUTHERN CROSS HOME PROPERTIES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    LOVETT, David Charles
    The Grange
    SW19 4PS London
    17
    England
    England
    Geschäftsführer
    The Grange
    SW19 4PS London
    17
    England
    England
    United KingdomBritish34419700002
    TAYLOR, Stephen Jonathan
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Geschäftsführer
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish163496070001
    JOYCE, Meriel Lucy Ann
    21 Easter Steil
    EH10 5XE Edinburgh
    Sekretär
    21 Easter Steil
    EH10 5XE Edinburgh
    British16385330010
    KAUL, Sheila
    35 Princes Court
    HA9 7JJ Wembley
    Middlesex
    Sekretär
    35 Princes Court
    HA9 7JJ Wembley
    Middlesex
    British70194600001
    MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Sekretär
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    158661850001
    MCLEISH, William David
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Sekretär
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    British168970640001
    HBJ SECRETARIAL LIMITED
    19 Ainslie Place
    EH3 6AU Edinburgh
    Bevollmächtigter Sekretär
    19 Ainslie Place
    EH3 6AU Edinburgh
    900015110001
    BOLOT, Timothy James
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Geschäftsführer
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish107837080002
    BUCHAN, William James
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Geschäftsführer
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    EnglandBritish79917240001
    COLVIN, William
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    Geschäftsführer
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    United KingdomBritish51697890003
    COLVIN, William
    1 Patterdale
    Coldharbour Road
    KT14 6JN West Byfleet
    Surrey
    Geschäftsführer
    1 Patterdale
    Coldharbour Road
    KT14 6JN West Byfleet
    Surrey
    United KingdomBritish51697890001
    FINNIS, Pam
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Geschäftsführer
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish133719530001
    FOULKES, Kamma
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Geschäftsführer
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish111188390002
    GROOMBRIDGE, Kevin John
    51 Old Croft Road
    ST17 0NL Stafford
    Geschäftsführer
    51 Old Croft Road
    ST17 0NL Stafford
    EnglandBritish105722880001
    HAINES, Ellen
    8 Jackdaw Lane
    WR9 7HE Droitwich
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    8 Jackdaw Lane
    WR9 7HE Droitwich
    Worcestershire
    British89071020002
    HEAPS, Ann
    8 Oakwood Close
    BL8 1DD Bury
    Lancashire
    Geschäftsführer
    8 Oakwood Close
    BL8 1DD Bury
    Lancashire
    British124068050001
    JOYCE, Anthony
    Gibliston Farmhouse
    Colinsburgh
    KY9 1JS Leven
    Fife
    Geschäftsführer
    Gibliston Farmhouse
    Colinsburgh
    KY9 1JS Leven
    Fife
    ScotlandBritish95693160002
    JOYCE, Martin Patrick
    La Rue A
    St Peter Port
    GY1 1QG Guernsey
    Geschäftsführer
    La Rue A
    St Peter Port
    GY1 1QG Guernsey
    United KingdomBritish27130160009
    JOYCE, Meriel Lucy Ann
    21 Easter Steil
    EH10 5XE Edinburgh
    Geschäftsführer
    21 Easter Steil
    EH10 5XE Edinburgh
    British16385330010
    LOCK, Jason David
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    Geschäftsführer
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    EnglandBritish144822040001
    MACINTOSH, Michael
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Geschäftsführer
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish137864880001
    MALHAM, Janette
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Geschäftsführer
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish91088900004
    MALHAM, Janette
    The Limekilns
    9a Elm Grove
    TS26 8LZ Hartlepool
    Geschäftsführer
    The Limekilns
    9a Elm Grove
    TS26 8LZ Hartlepool
    EnglandBritish91088900003
    MALHAM, Janette
    The Limekilns
    9a Elm Grove
    TS26 8LZ Hartlepool
    Geschäftsführer
    The Limekilns
    9a Elm Grove
    TS26 8LZ Hartlepool
    EnglandBritish91088900003
    MCKEEVER, Pauline Ann
    40 Pine Place
    G5 0BX Glasgow
    Geschäftsführer
    40 Pine Place
    G5 0BX Glasgow
    BritainBritish91521130001
    MCKEEVER, Pauline Ann
    40 Pine Place
    G5 0BX Glasgow
    Geschäftsführer
    40 Pine Place
    G5 0BX Glasgow
    BritainBritish91521130001
    MCKEEVER, Pauline Ann
    40 Pine Place
    G5 0BX Glasgow
    Geschäftsführer
    40 Pine Place
    G5 0BX Glasgow
    BritainBritish91521130001
    MIDMER, Richard Neil
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Geschäftsführer
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    EnglandBritish110640170001
    MILLOY, Alastair Harvey
    Flat 1/1 Camphill House
    Queens Park
    G41 2DX Glasgow
    Lanarkshire
    Geschäftsführer
    Flat 1/1 Camphill House
    Queens Park
    G41 2DX Glasgow
    Lanarkshire
    British69398880001
    MURPHY, John
    4 Lochend Road
    KA10 6JJ Troon
    Geschäftsführer
    4 Lochend Road
    KA10 6JJ Troon
    United KingdomBritish26177180004
    MURPHY, John
    21 Montgreenan View
    KA13 7NL Kilwinning
    Ayrshire
    Geschäftsführer
    21 Montgreenan View
    KA13 7NL Kilwinning
    Ayrshire
    British26177180002
    POYNTON, Ellen
    Whiteoaks
    10 St Richards Close, Wychbold
    WR9 7PP Droitwich
    Geschäftsführer
    Whiteoaks
    10 St Richards Close, Wychbold
    WR9 7PP Droitwich
    United KingdomBritish89071020004
    PRESTON, Mary
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Geschäftsführer
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish124068010001
    RUTTER, Christopher
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    Geschäftsführer
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    British103588940001
    SCOTT, Philip Henry
    The Old Vicarage
    Newgate
    DL12 8NW Barnard Castle
    County Durham
    Geschäftsführer
    The Old Vicarage
    Newgate
    DL12 8NW Barnard Castle
    County Durham
    EnglandBritish174231320001

    Hat SOUTHERN CROSS HOME PROPERTIES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Supplemental debenture
    Erstellt am 21. Apr. 2005
    Geliefert am 06. Mai 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the f/h l/h property of the land adjoining brooklands nursing and residential home, springfield road, springfield park, grimsby, north east lincolnshire and all buildings, fixtures and fittings and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No 10 Limited
    Transaktionen
    • 06. Mai 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 28. Mai 2003
    Geliefert am 14. Juni 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    The deposit, all interest, the deposit account and the deposit balance. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No.5 Limited
    Transaktionen
    • 14. Juni 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 28. Mai 2003
    Geliefert am 30. Mai 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    All right title estate and other interests of the company in the l/h premises situate at summerhill mansion nursing home, 22 chaplin close, salford, greater manchester, M6 8FW. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No. 5 Limited
    Transaktionen
    • 30. Mai 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 12. Mai 2003
    Geliefert am 20. Mai 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The tenant with full title guarantee charges to the landlord 1. the deposit 2. all interest 3. the deposit account, and 4. the deposit balance. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No. 3 Limited
    Transaktionen
    • 20. Mai 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Apr. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 12. Mai 2003
    Geliefert am 15. Mai 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage l/h oakland nursing and residential home 134 kenyon lane moston manchester. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No.3 Limited
    Transaktionen
    • 15. Mai 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Apr. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 04. März 2003
    Geliefert am 08. März 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    The deposit, all interest, the deposit account and the deposit balance. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No.5 Limited
    Transaktionen
    • 08. März 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 04. März 2003
    Geliefert am 07. März 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H premises callands nursing home, callands road, callands, warrington. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No. 5 Limited
    Transaktionen
    • 07. März 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit
    Erstellt am 21. Feb. 2003
    Geliefert am 28. Feb. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The deposit, the interest, the deposit account and the deposit balance. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No 5 Limited
    Transaktionen
    • 28. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 21. Feb. 2003
    Geliefert am 26. Feb. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H premises newlands nursing home, 122 heaton moor road, heaton moor, stockport, cheshire. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No. 5 Limited
    Transaktionen
    • 26. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 22. Jan. 2003
    Geliefert am 08. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The deposit being the sum of £25,578 all interest the deposit account being an interest bearing account specifically designated "sunningdale lodge nursing home deposit account" and the deposit balance being the amount from time to time standing to the credit of the deposit account. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No.3 Limited
    Transaktionen
    • 08. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Apr. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 22. Jan. 2003
    Geliefert am 30. Jan. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The deposit (£26,100),the deposit balance,all interest and the deposit account,all terms as defined. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No.3 Limited
    Transaktionen
    • 30. Jan. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Apr. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 22. Jan. 2003
    Geliefert am 28. Jan. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage the l/h property k/a sunningdale nursing and residential home, dene road, halliwell dene, hexham, northumberland, NE46 1HW,. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No.3 Limited
    Transaktionen
    • 28. Jan. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Apr. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 22. Jan. 2003
    Geliefert am 28. Jan. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage the l/h property k/a sunningdale lodge care home, dene road, halliwell dene, hexham, northumberland, NE46 1HW,. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No.3 Limited
    Transaktionen
    • 28. Jan. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Apr. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 22. Jan. 2003
    Geliefert am 28. Jan. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The tenant with full title guarantee charges to the landlord the deposit,all interest,the deposit account and the deposit balance. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No.5 Limited
    Transaktionen
    • 28. Jan. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 22. Jan. 2003
    Geliefert am 28. Jan. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The tenant with full title guarantee charges to the landlord the deposit,all interest,the deposit account and the deposit balance. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No.5 Limited
    Transaktionen
    • 28. Jan. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 22. Jan. 2003
    Geliefert am 28. Jan. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The l/h premises k/a hebburn court nursing and residentail home witty avenue hebburn tyne & wear together with all buildings structures fixtures and fittings (including trade) and fixed plant and machinery. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No.5 Limited
    Transaktionen
    • 28. Jan. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 22. Jan. 2003
    Geliefert am 28. Jan. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The l/h premises k/a fell house nursing home albion terrace springwell village gateshead together with all buildings structures fixtures and fittings (including trade) and fixed plant and machinery. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No.5 Limited
    Transaktionen
    • 28. Jan. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 22. Jan. 2003
    Geliefert am 28. Jan. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The l/h premises k/a throckley nursing and residential home ponteland road throckley tyne & wear together with all buildings, structures, fixtures and fittings (including trade) and fixed plant and machinery. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No 5 Limited
    Transaktionen
    • 28. Jan. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 22. Jan. 2003
    Geliefert am 28. Jan. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The l/h premises k/a ashington grange and moorhouse farm nursing and residential home ashington northumberland together with buildings structures fixtures and fittings (including trade) and fixed plant and machinery thereon. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No.5 Limited
    Transaktionen
    • 28. Jan. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 20. Jan. 2003
    Geliefert am 24. Jan. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H premises oakland nursing and residential home, oakwood house, bury road, rochdale, lancashire. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No. 10 Limited
    Transaktionen
    • 24. Jan. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 20. Jan. 2003
    Geliefert am 23. Jan. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The deposit being the sum of £21,096.00 all interest the deposit account being an interest bearing account specifically designated "oaklands nursing & residential home (rochdale) limited deposit account" and the deposit balance being the amount from time to time standing to the credit of the deposit account. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No.10 Limited
    Transaktionen
    • 23. Jan. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 15. Jan. 2003
    Geliefert am 18. Jan. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No. 5 Limited
    Transaktionen
    • 18. Jan. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 15. Jan. 2003
    Geliefert am 18. Jan. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The deposit (£31,050.00),all interest,the deposit account and the deposit balance,all terms as defined; see form 395 for details. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No.5 Limited
    Transaktionen
    • 18. Jan. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 18. Dez. 2002
    Geliefert am 27. Dez. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All right title interests of the company in leasehold premises situate at defoe court nursing and residential home defoe crescent newton aycliffe county durham DL5 4JP. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No. 10 Limited
    Transaktionen
    • 27. Dez. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 18. Dez. 2002
    Geliefert am 27. Dez. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All right title estate and other interests of the company in leasehold premises situate at ridgeway nursing and residential home front street station town wingate county durham TS28 5DP. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No. 10 Limited
    Transaktionen
    • 27. Dez. 2002Registrierung einer Belastung (395)

    Hat SOUTHERN CROSS HOME PROPERTIES LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    20. Juni 2012Datum der Sitzung zur Genehmigung des CVA
    20. Aug. 2012Datum des Abschlusses oder der Beendigung des CVA
    Freiwillige Unternehmenssanierung (CVA)
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Howard Smith
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    Praktiker
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0