CROWNHILL CONSTRUCTION LIMITED

CROWNHILL CONSTRUCTION LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCROWNHILL CONSTRUCTION LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03682231
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CROWNHILL CONSTRUCTION LIMITED?

    • Sonstiger Einzelhandel mit neuen Waren in Fachgeschäften (ausgenommen Kunstgalerien und Augenoptiker) (47789) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen
    • Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich CROWNHILL CONSTRUCTION LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Unit 1 Castleworks Podmore Street
    Off Macintyre Street
    ST6 2EZ Stoke-On-Trent
    Staffordshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CROWNHILL CONSTRUCTION LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2012

    Welche sind die letzten Einreichungen für CROWNHILL CONSTRUCTION LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Verzichtserklärung auf herrenlose Güter

    1 SeitenBONA

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ2

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde ausgesetzt

    1 SeitenDISS16(SOAS)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde ausgesetzt

    1 SeitenDISS16(SOAS)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt

    1 SeitenDISS40

    Jahresrückblick erstellt bis 11. Dez. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital02. Mai 2014

    Kapitalaufstellung am 02. Mai 2014

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2012

    4 SeitenAA

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2011

    4 SeitenAA

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2010

    4 SeitenAA

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2009

    4 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 11. Dez. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Beendigung der Bestellung von Gail Dunlop als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 11. Dez. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt

    1 SeitenDISS40

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt

    1 SeitenDISS40

    Jahresrückblick erstellt bis 11. Dez. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt

    1 SeitenDISS40

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Tuscany House Beata Road Chesterton Newcastle Staffordshire ST5 7UT England* am 24. Sept. 2010

    1 SeitenAD01

    Ernennung von Mr Brian John Dunlop als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name

    Beschluss zur Änderung der Firma am 12. Aug. 2010

    RES15

    Hinweis auf Namensänderung

    2 SeitenCONNOT

    Wer sind die Geschäftsführer von CROWNHILL CONSTRUCTION LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    DUNLOP, Brian John
    Podmore Street
    Off Macintyre Street
    ST6 2EZ Stoke-On-Trent
    Unit 1 Castleworks
    Staffordshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Podmore Street
    Off Macintyre Street
    ST6 2EZ Stoke-On-Trent
    Unit 1 Castleworks
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish28141770001
    BUTLER, Philip
    45 Folley Road
    Ackleton
    WV6 7JL Wolverhampton
    Sekretär
    45 Folley Road
    Ackleton
    WV6 7JL Wolverhampton
    British62187880001
    CHANDLER, Kim
    49 Deans Croft
    SG3 6BD Knebworth
    Hertfordshire
    Sekretär
    49 Deans Croft
    SG3 6BD Knebworth
    Hertfordshire
    British43091760001
    DUFFY, Jeremy David Stuart
    Parkside Lodge
    Ivetsey Road
    ST19 9QP Wheaton Aston
    Staffordshire
    Sekretär
    Parkside Lodge
    Ivetsey Road
    ST19 9QP Wheaton Aston
    Staffordshire
    British85314100001
    JACKSON, Mickhala Marcia
    7 Oak Drive
    Scholar Green
    ST7 3LY Stoke On Trent
    Staffordshire
    Sekretär
    7 Oak Drive
    Scholar Green
    ST7 3LY Stoke On Trent
    Staffordshire
    British78133050003
    CLOVERPARK MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    The Brampton
    ST5 0TE Newcastle-Under-Lyme
    Staffordshire
    Sekretär
    The Brampton
    ST5 0TE Newcastle-Under-Lyme
    Staffordshire
    91972280001
    TEMPLE SECRETARIES LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Bevollmächtigter Sekretär
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001120001
    BUTLER, Philip
    45 Folley Road
    Ackleton
    WV6 7JL Wolverhampton
    Geschäftsführer
    45 Folley Road
    Ackleton
    WV6 7JL Wolverhampton
    British62187880001
    DUFFY, Jeremy David Stuart
    Parkside Lodge
    Ivetsey Road
    ST19 9QP Wheaton Aston
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Parkside Lodge
    Ivetsey Road
    ST19 9QP Wheaton Aston
    Staffordshire
    British85314100001
    DUNLOP, Daniel John
    45 The Avenue
    EN6 1ED Potters Bar
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    45 The Avenue
    EN6 1ED Potters Bar
    Hertfordshire
    United KingdomBritish89161160001
    DUNLOP, Gail Deborah
    Podmore Street
    Off Macintyre Street
    ST6 2EZ Stoke-On-Trent
    Unit 1 Castleworks
    Staffordshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Podmore Street
    Off Macintyre Street
    ST6 2EZ Stoke-On-Trent
    Unit 1 Castleworks
    Staffordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish2464520001
    PAGETT, Michael Dennis
    Beata Road
    Chesterton
    ST5 7UT Newcastle
    Tuscany House
    Staffordshire
    England
    Geschäftsführer
    Beata Road
    Chesterton
    ST5 7UT Newcastle
    Tuscany House
    Staffordshire
    England
    EnglandBritish70944940002
    COMPANY DIRECTORS LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001110001

    Hat CROWNHILL CONSTRUCTION LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 01. Feb. 2008
    Geliefert am 08. Feb. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    23 shirburn road leek staffordshire t/no SF263178.
    Berechtigte Personen
    • Derbyshire Building Society
    Transaktionen
    • 08. Feb. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Feb. 2008
    Geliefert am 08. Feb. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    12 beech bank off beech lane macclesfield cheshire t/n's CH177386 CH388231 CH2008142 and CH214576.
    Berechtigte Personen
    • Derbyshire Building Society
    Transaktionen
    • 08. Feb. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Feb. 2008
    Geliefert am 08. Feb. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Plot 5 abbeyfields abbots road leek staffordshire t/n SF488145.
    Berechtigte Personen
    • Derbyshire Building Society
    Transaktionen
    • 08. Feb. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Feb. 2008
    Geliefert am 08. Feb. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Plot 4 abbeyfields abbots road leek staffordshire t/n SF488145.
    Berechtigte Personen
    • Derbyshire Building Society
    Transaktionen
    • 08. Feb. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Feb. 2008
    Geliefert am 08. Feb. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The bunting kingsley staffordshire t/n SF321769.
    Berechtigte Personen
    • Derbyshire Building Society
    Transaktionen
    • 08. Feb. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 13. Juli 2007
    Geliefert am 18. Juli 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a 23 shirburn road leek staffordshire t/no SF263178. By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels.
    Berechtigte Personen
    • Aib Group (UK) PLC
    Transaktionen
    • 18. Juli 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 18. Mai 2007
    Geliefert am 22. Mai 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H 6 the bunting kingsley staffordshire t/n SF321769. By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels.
    Berechtigte Personen
    • Aib Group (UK) PLC
    Transaktionen
    • 22. Mai 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 17. Jan. 2007
    Geliefert am 27. Jan. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a 12 beech bank macclesfield cheshire and adjoining land t/nos CH177386, CH388231 and CH214576 together with the f/h land on the north side of beech bank macclesfield t/no CH208142. By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels.
    Berechtigte Personen
    • Aib Group (UK) PLC
    Transaktionen
    • 27. Jan. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 17. Juni 2005
    Geliefert am 18. Juni 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a land and buildings on the east side of abbotts road, leek t/no SF488145. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Aib Group (UK) PLC
    Transaktionen
    • 18. Juni 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 08. Sept. 2004
    Geliefert am 29. Sept. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land and buidlings on the east side of abbotts road leek staffordshire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Sept. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Juni 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 23. Aug. 2002
    Geliefert am 04. Sept. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land on the north side of mormacot grange road meir stoke-on-trent t/n SF433492 and SF430846. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Sept. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Juni 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 10. Jan. 2002
    Geliefert am 30. Apr. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £150,000 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Land on the north side of normacot grange road, meir, stoke-on-trent.
    Berechtigte Personen
    • Nicholas Yiannis
    Transaktionen
    • 30. Apr. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Juni 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 23. Mai 1999
    Geliefert am 28. Mai 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Mai 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Juni 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0