ABA HOLDINGS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | ABA HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03686406 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ABA HOLDINGS LIMITED?
- Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich ABA HOLDINGS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Off Edge Station Approach CF64 3EE Penarth Vale Of Glamorgan United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ABA HOLDINGS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| BASTON HOLDINGS LIMITED | 21. Dez. 1998 | 21. Dez. 1998 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ABA HOLDINGS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Apr. 2019 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ABA HOLDINGS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Verzichtserklärung auf herrenlose Güter | 1 Seiten | BONA | ||
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||
Ungeprüfter Jahresabschluss, gekürzt, bis 30. Apr. 2019 | 10 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 21. Dez. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Apr. 2018 | 13 Seiten | AA | ||
Beendigung der Bestellung von Joanna Elisabeth Baston als Geschäftsführer am 19. Juli 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||
Erfüllung der Belastung 036864060015 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||
Erfüllung der Belastung 036864060016 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||
Erfüllung der Belastung 036864060017 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||
**Ein Teil des Eigentums oder Unternehmens wurde aus der Belastung entlassen ** 036864060014 | 2 Seiten | MR05 | ||
Ernennung von Mr Alexander Simon Washington Baston als Direktor am 01. März 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||
Geänderte vollständige Konten mit voller Befreiung erstellt bis 30. Apr. 2017 | 15 Seiten | AAMD | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 21. Dez. 2017 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Apr. 2017 | 16 Seiten | AA | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Pod 8, Avon House Stanwell Road Penarth South Glamorgan CF64 2EZ zum Off Edge Station Approach Penarth Vale of Glamorgan CF64 3EE am 10. Apr. 2017 | 1 Seiten | AD01 | ||
Eintragung der Belastung 036864060019, erstellt am 23. März 2017 | 5 Seiten | MR01 | ||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Jan. 2017 bis 30. Apr. 2017 | 1 Seiten | AA01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 21. Dez. 2016 mit Aktualisierungen | 6 Seiten | CS01 | ||
Eintragung der Belastung 036864060018, erstellt am 29. Dez. 2016 | 5 Seiten | MR01 | ||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. Jan. 2016 | 5 Seiten | AA | ||
Eintragung der Belastung 036864060017, erstellt am 07. Sept. 2016 | 21 Seiten | MR01 | ||
Eintragung der Belastung 036864060015, erstellt am 07. Sept. 2016 | 25 Seiten | MR01 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von ABA HOLDINGS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCANLAN, Fenella | Sekretär | Station Approach CF64 3EE Penarth Off Edge Vale Of Glamorgan United Kingdom | 192396120001 | |||||||
| BASTON, Alexander Simon Washington | Geschäftsführer | Station Approach CF64 3EE Penarth Off Edge Vale Of Glamorgan United Kingdom | United Kingdom | British | 243779910001 | |||||
| BASTON, Simon Malcolm | Geschäftsführer | Station Approach CF64 3EE Penarth Off Edge Vale Of Glamorgan United Kingdom | Wales | British | 61867410011 | |||||
| ATTWELL THOMAS, Christopher Paul | Sekretär | 34 William Belcher Drive CF3 0NZ Cardiff South Glamorgan | British | 90363590001 | ||||||
| BASTON, Simon Malcolm | Sekretär | Orchard Cottage, Fontygary Road Rhoose CF62 3DU Barry Vale Of Glamorgan | British | 61867410001 | ||||||
| DAVIES, Mandy Irene | Sekretär | Stanwell Road CF64 2EZ Penarth Pod 8, Avon House South Glamorgan Wales | 158166880001 | |||||||
| WATERS, Jonathan Stewart | Sekretär | 6 Summerland Close Llandough CF64 2QA Penarth Vale Of Glamorgan | British | 51179490001 | ||||||
| WATERS, Jonathan Stewart | Sekretär | 56 Cardiff Road Penygwasi CF72 8DH Llantrisant Pontyclun | British | 51179490006 | ||||||
| SECRETARIAL APPOINTMENTS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 16 Churchill Way CF10 2DX Cardiff | 900017270001 | |||||||
| BASTON, Elaine | Geschäftsführer | Cowbridge Road CF62 4LE St Athan Ty Canrif South Glamorgan | Wales | British | 131972610001 | |||||
| BASTON, Joanna Elisabeth | Geschäftsführer | Station Approach CF64 3EE Penarth Off Edge Vale Of Glamorgan United Kingdom | Wales | British | 45974110011 | |||||
| BASTON, Joanna Elisabeth | Geschäftsführer | 5652 Eagle Harbour Road West Vancouver Vancouver British Columbia V7w Ip5 Canada | Canada | British | 45974110008 | |||||
| BASTON, Malcolm Clifford | Geschäftsführer | Ty-Canrif Cowbridge Road, St Athan CF62 4LE Barry | Wales | British | 117574540001 | |||||
| CORPORATE APPOINTMENTS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 16 Churchill Way CF10 2DX Cardiff | 900017260001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ABA HOLDINGS LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört |
|---|---|---|---|
| Mr Simon Malcolm Baston | 30. Juni 2016 | Station Approach CF64 3EE Penarth Off Edge Vale Of Glamorgan United Kingdom | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: Wales | |||
Arten der Kontrolle
| |||
| Mrs Joanna Elisabeth Baston | 30. Juni 2016 | Station Approach CF64 3EE Penarth Off Edge Vale Of Glamorgan United Kingdom | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: Wales | |||
Arten der Kontrolle
| |||
Hat ABA HOLDINGS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 23. März 2017 Geliefert am 28. März 2017 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung Jennings porthcawl CF36 3YR registered with title number CYM691039. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 29. Dez. 2016 Geliefert am 30. Dez. 2016 | Ausstehend | ||
Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 07. Sept. 2016 Geliefert am 13. Sept. 2016 | Vollständig erfüllt | ||
Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 07. Sept. 2016 Geliefert am 10. Sept. 2016 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung L/H the custom house porthcawl bridgend. Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 07. Sept. 2016 Geliefert am 10. Sept. 2016 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung L/H the jenning swarehouse porthcawl bridgend. Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 21. Aug. 2014 Geliefert am 04. Sept. 2014 | Ausstehend | ||
Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 05. Okt. 2011 Geliefert am 06. Okt. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 02. Apr. 2008 Geliefert am 04. Apr. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Unit 6, crichton house mount stuart sq. Cardiff assigns the goodwill of all businesses, from time to time carried on at the property, with the benefit of all authorisations, permits, registration certificates or licences of any kind, also by way of fixed charge the equipment & goods (if any) & all other fixtures, fittings, plant & machinery & by way of floating charge on other moveable plant, machinery, furniture, equipment, goods & other effects which are from time to time on the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 13. Juni 2006 Geliefert am 15. Juni 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The property k/a 7 crichton house, mount stuart square, cardiff bay. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 20. Jan. 2006 Geliefert am 25. Jan. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben The property known as loft 3.19 castle buildings castle street swansea. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 28. Nov. 2005 Geliefert am 01. Dez. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Unit 10 crichton house mount stuart square cardiff. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 28. Nov. 2005 Geliefert am 01. Dez. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Flat 1 victoria house tudor street cardiff t/n CYM126841. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 28. Nov. 2005 Geliefert am 01. Dez. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Flat 2 victoria house tudor street cardiff t/n CYM126832. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 28. Nov. 2005 Geliefert am 01. Dez. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben The property known as loft 3 city lofts crwys road cathays cardiff t/n CYM233325. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 29. Apr. 2005 Geliefert am 11. Mai 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Loft 3 city lofts crwys road cathays cardiff fixed charge over all rental income and the proceeds of sale of any lease of the property. Floating charge over the undertaking all property assets and rights of the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 02. Mai 2003 Geliefert am 17. Mai 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben By way of legal mortgage the l/h property k/a flat 1 victoria house tudor street cardiff part f/h t/no WA256095. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 02. Mai 2003 Geliefert am 17. Mai 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property flat 2 victoria house, tudor street, cardiff part of f/h t/n WA256095. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 11. Nov. 2002 Geliefert am 21. Nov. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 6 castle lofts castle street swansea SA1 1HY. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 10. Aug. 2000 Geliefert am 18. Aug. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0