ABC BUSES LIMITED
Überblick
Unternehmensname | ABC BUSES LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 03686935 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ABC BUSES LIMITED?
- (6021) /
Wo befindet sich ABC BUSES LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | C/O Stagecoach Services Ltd Daw Bank SK3 0DY Stockport Cheshire |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ABC BUSES LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
ALTERMETAL LIMITED | 22. Dez. 1998 | 22. Dez. 1998 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ABC BUSES LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Apr. 2010 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ABC BUSES LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 22. Dez. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Apr. 2010 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Michael John Vaux am 10. Okt. 2009 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 22. Dez. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Apr. 2009 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Leslie Brian Warneford am 01. Nov. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Colin Brown am 15. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Michael John Vaux am 07. Okt. 2009 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2008 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2007 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2006 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 225 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Juli 2005 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 225 |
Wer sind die Geschäftsführer von ABC BUSES LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAUX, Michael John | Sekretär | 10 Dunkeld Road PH1 5TW Perth Stagecoach Group Plc Perthshire United Kingdom | British | 137383880001 | ||||||
BROWN, Colin | Geschäftsführer | 10 Dunkeld Road PH1 5TW Perth Stagecoach Group Plc Perthshire United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 85970020003 | ||||
WARNEFORD, Leslie Brian | Geschäftsführer | 10 Dunkeld Road PH1 5TW Perth Stagecoach Group Plc Perthshire United Kingdom | United Kingdom | British | Managing Director | 49771140004 | ||||
GRANT, Graham John | Sekretär | 189 Liverpool Road L31 2LY Lydiate Merseyside | British | Company Director | 109725610001 | |||||
OSBORNE, Paul Anthony | Sekretär | 14 Bentfield Close CH63 8NB Wirral Merseyside | British | Finance Director | 91745910001 | |||||
WHITNALL, Alan Leonard | Sekretär | 25 Millhill Drive Greenloaning FK15 0LS Dunblane Perthshire | British | Company Secretary | 54184420002 | |||||
BALLARD CAMPBELL & PARTNERS LIMITED | Sekretär | Portland Tower Partland Street M1 3LF Manchester Greater Manchester | 90505790001 | |||||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
BRADY, Dominic | Geschäftsführer | 54 High Street Hale Village L24 4AF Liverpool Merseyside | Uk | British | Company Director | 125406360001 | ||||
CAMPBELL, Iain Fraser | Geschäftsführer | 432 Chorley New Road BL1 5BA Bolton Lancashire | United Kingdom | British | Company Director | 110946500001 | ||||
GRANT, Graham John | Geschäftsführer | 189 Liverpool Road L31 2LY Lydiate Merseyside | United Kingdom | British | Company Director | 109725610001 | ||||
GRANT, Jeffrey James | Geschäftsführer | 52 Dowhills Road Blundellsands L23 8SW Liverpool | British | Company Director | 62383270001 | |||||
OSBORNE, Paul Anthony | Geschäftsführer | 14 Bentfield Close CH63 8NB Wirral Merseyside | British | Finance Director | 91745910001 | |||||
INSTANT COMPANIES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Hat ABC BUSES LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Erstellt am 12. Juni 2003 Geliefert am 20. Juni 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 12. Juni 2003 Geliefert am 18. Juni 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Chattel mortgage | Erstellt am 23. Apr. 1999 Geliefert am 28. Apr. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £745,000 and all other sums due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben 2 x leyland atlantean registration no's cbv 3055 and gfv 151W; 2 x optare delta registration no's J800 abc and L700 abc; mercedes 709D mid registration no. J55 abc (for details of further vehicles charged please see form 395). see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 28. Feb. 1999 Geliefert am 05. März 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0