HENLEY AND MAYFAIR INVESTMENTS LIMITED

HENLEY AND MAYFAIR INVESTMENTS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameHENLEY AND MAYFAIR INVESTMENTS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03692067
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von HENLEY AND MAYFAIR INVESTMENTS LIMITED?

    • Kauf und Verkauf eigener Immobilien (68100) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich HENLEY AND MAYFAIR INVESTMENTS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Chisbridge Farm Chisbridge Lane
    Frieth Road
    SL7 2HS Marlow
    Buckinghamshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von HENLEY AND MAYFAIR INVESTMENTS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    SEFCROWN LIMITED05. Jan. 199905. Jan. 1999

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HENLEY AND MAYFAIR INVESTMENTS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Jan. 2015

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für HENLEY AND MAYFAIR INVESTMENTS LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für HENLEY AND MAYFAIR INVESTMENTS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresrückblick erstellt bis 05. Jan. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital14. Jan. 2016

    Kapitalaufstellung am 14. Jan. 2016

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Jan. 2015

    7 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 05. Jan. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital07. Jan. 2015

    Kapitalaufstellung am 07. Jan. 2015

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Jan. 2014

    7 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 05. Jan. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital28. Jan. 2014

    Kapitalaufstellung am 28. Jan. 2014

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt

    1 SeitenAD03

    Änderung der Details des Direktors für Mr. Roger Guy Smee am 14. Juni 2013

    2 SeitenCH01

    Die Adresse der Registerinspektion wurde vom Crazies Hall Crazies Hill Wargrave Reading Berkshire RG10 8LY United Kingdom geändert

    1 SeitenAD02

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Jan. 2013

    7 SeitenAA

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Crazies Hall Crazies Hill Reading Berkshire RG10 8LY United Kingdom* am 06. Aug. 2013

    1 SeitenAD01

    Jahresrückblick erstellt bis 05. Jan. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Jan. 2012

    8 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 05. Jan. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Jan. 2011

    8 SeitenAA

    Die Adresse der Registerinspektion wurde vom Kilnbrook House Rose Kiln Lane Reading Berkshire RG2 0BY United Kingdom geändert

    1 SeitenAD02

    Geänderte Geschäftsanschrift vom , Kilnbrook House Rose Kiln Lane, Reading, Berkshire, RG2 0BY, United Kingdom am 31. Mai 2011

    1 SeitenAD01

    Jahresrückblick erstellt bis 05. Jan. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Jan. 2010

    9 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 05. Jan. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Die Adresse der Registerinspektion wurde vom Kilnbrook House Rose Kiln Lane Reading Berkshire RG2 0BY United Kingdom geändert

    1 SeitenAD02

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt

    1 SeitenAD03

    Die Adresse der Registerinspektion wurde geändert

    1 SeitenAD02

    Wer sind die Geschäftsführer von HENLEY AND MAYFAIR INVESTMENTS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    JONES, William Quentin
    15 Crowsley Road
    Lower Shiplake
    RG9 3JU Henley On Thames
    Oxfordshire
    Sekretär
    15 Crowsley Road
    Lower Shiplake
    RG9 3JU Henley On Thames
    Oxfordshire
    BritishSurveyor28918420001
    SMEE, Roger Guy
    Chisbridge Lane
    Frieth Road
    SL7 2HS Marlow
    Chisbridge Farm
    Buckinghamshire
    England
    Geschäftsführer
    Chisbridge Lane
    Frieth Road
    SL7 2HS Marlow
    Chisbridge Farm
    Buckinghamshire
    England
    EnglandBritishSurveyor29088830010
    BHARDWAJ, Ashok
    47-49 Green Lane
    HA6 3AE Northwood
    Middlesex
    Bevollmächtigter Sekretär
    47-49 Green Lane
    HA6 3AE Northwood
    Middlesex
    British900010640001
    LIBBY, Keith Burton
    54
    Great Somerford
    SN15 5EL Chippenham
    Wiltshire
    Sekretär
    54
    Great Somerford
    SN15 5EL Chippenham
    Wiltshire
    BritishSurveyor66206600003
    DOYLE, Mark Kenneth
    2 Settrington Road
    SW6 3BA London
    Geschäftsführer
    2 Settrington Road
    SW6 3BA London
    BritishProperty Developer68480350004
    HODGSON, Frank
    7 Broadbent Street
    Mayfair
    W1K 3EF London
    Mayfair Chambers
    Geschäftsführer
    7 Broadbent Street
    Mayfair
    W1K 3EF London
    Mayfair Chambers
    United KingdomBritishProperty Developer108232260001
    LIBBY, Keith Burton
    54
    Great Somerford
    SN15 5EL Chippenham
    Wiltshire
    Geschäftsführer
    54
    Great Somerford
    SN15 5EL Chippenham
    Wiltshire
    BritishSurveyor66206600003
    PATTERSON, Anthony James
    67 Grosvenor Street
    W1X 9DB London
    Geschäftsführer
    67 Grosvenor Street
    W1X 9DB London
    BritishSolicitor66526110002
    BHARDWAJ CORPORATE SERVICES LIMITED
    47-49 Green Lane
    HA6 3AE Northwood
    Middlesex
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    47-49 Green Lane
    HA6 3AE Northwood
    Middlesex
    900010630001

    Hat HENLEY AND MAYFAIR INVESTMENTS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 07. März 2003
    Geliefert am 18. März 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage over all that l/h property k/a 10 west london studios 402-405 fulham road hammersmith and fulham london SW6 1HP t/no NGL128716. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 18. März 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 12. Juni 2002
    Geliefert am 14. Juni 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The l/h property k/a flat 8 2ND floor, aden house, 107 earls court road, london W8, t/n LN213957, including all and singular fixed machinery, buildings, erections and other fixtures and fittings now erected on or affixed to the land comprised in the charge.
    Berechtigte Personen
    • Wintrust Securities Limited
    Transaktionen
    • 14. Juni 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of release and subsitution
    Erstellt am 10. Mai 2002
    Geliefert am 24. Mai 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage over all that l/h property known as second floor flat 62A kensington mansions trebovir road london SW5 9TD t/n NGL287552 by way of fixed charge over all buildings and other structures on and items fixed to the property by way of fixed legal charge over any goodwill relating to the property by way of fixed charge over all plant machinery and other chattels attached to the property by way of floating charge over all unattached plant machinery chattels and goods by way of legal assignment the rental sums. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 24. Mai 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 16. Apr. 2002
    Geliefert am 26. Apr. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The l/h property k/a 542C kings road, kensington, london SW10 0UB t/no. BGL28433. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 26. Apr. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 16. Jan. 2002
    Geliefert am 23. Jan. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a 9 garrick house, carrington street, westminster, london t/no. NGL182258. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 23. Jan. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Nov. 2001
    Geliefert am 05. Dez. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property known as flat 96 pinehurst court colville gardens london W11 title number NGL286694. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 05. Dez. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 11. Mai 2001
    Geliefert am 15. Mai 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage all that l/h property k/a third floor flat 3, 58 nevern square, london SW5 t/n NGL372828. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 15. Mai 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 12. Apr. 2001
    Geliefert am 20. Apr. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a flat g 144 cromwell road london - NGL431655. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 20. Apr. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 29. Jan. 2001
    Geliefert am 02. Feb. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/Hold property known as 62A kensington mansions,trebovir rd,london SW5; t/no ngl 287552.. fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 02. Feb. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 29. Sept. 2000
    Geliefert am 04. Okt. 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H flat 7 arden house 107 earl's court road london W8 t/no.NGL93766. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 04. Okt. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Sept. 2000
    Geliefert am 13. Sept. 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that l/h property k/a flat 5 arden house 107 earl's court london t/n NGL324501. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 13. Sept. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 09. Feb. 2000
    Geliefert am 22. Feb. 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 22. Feb. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 09. Feb. 2000
    Geliefert am 22. Feb. 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a flat 3,61 warwick road london SW5 all buildings and other structures goodwill relating to the property plant machinery and other chattels by way of assignment the rental sums the proceeds of any claim under any insurance policy. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 22. Feb. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 09. Feb. 2000
    Geliefert am 22. Feb. 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a flat 1 61 warwick road london SW5 all buildings and other structures goodwill by way of assignment the rental sums the proceeds of any claim under any insurance. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 22. Feb. 2000Registrierung einer Belastung (395)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0