DB VANTAGE (UK) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | DB VANTAGE (UK) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03692643 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von DB VANTAGE (UK) LIMITED?
- Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen
Wo befindet sich DB VANTAGE (UK) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 15 Canada Square E14 5GL London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von DB VANTAGE (UK) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| CREGGS INVESTMENTS LIMITED | 31. Dez. 1998 | 31. Dez. 1998 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von DB VANTAGE (UK) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2014 |
Welche sind die letzten Einreichungen für DB VANTAGE (UK) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 6 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 12. Okt. 2017 | 6 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Winchester House 1 Great Winchester Street London EC2N 2DB zum 15 Canada Square London E14 5GL am 09. Nov. 2016 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 2 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 17. Juni 2016
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mr Darren Hackett als Direktor am 01. Okt. 2013 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Jan. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Adam Paul Rutherford als Sekretär am 14. Aug. 2015 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Jan. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Verschiedenes S.519 compant act 2006 | 2 Seiten | MISC | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | 2 Seiten | AUD | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Jan. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr David Kenyon Thomas am 24. Feb. 2014 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Ms Joanne Louise Bagshaw als Sekretär | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Jan. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von DB VANTAGE (UK) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAGSHAW, Joanne Louise | Sekretär | 1 Great Winchester Street EC2N 2DB London Winchester House United Kingdom | 180380380001 | |||||||
| BARTLETT, Andrew William | Sekretär | 1 Great Winchester Street EC2N 2DB London Winchester House | British | 73852930003 | ||||||
| CLONEY, Ross Daniel | Geschäftsführer | 1 Great Winchester Street EC2N 2DB London Winchester House United Kingdom | United Kingdom | British | 130485060002 | |||||
| HACKETT, Darren | Geschäftsführer | 1 Great Winchester Street EC2N 2DB London Winchester House United Kingdom | United Kingdom | British | 197625000001 | |||||
| THOMAS, David Kenyon | Geschäftsführer | 1 Great Winchester Street EC2N 2DB London Winchester House England England | United Kingdom | British | 59397060006 | |||||
| BARTLETT, Andrew William | Sekretär | 22 Arlington Avenue N1 7AX London | British | 73852930001 | ||||||
| BURTON, Jennifer Sandra | Sekretär | 39b Butler Avenue HA1 4EJ West Harrow Middlesex | British | 100622570001 | ||||||
| CLARK, Giles Sebastian | Sekretär | 37 Durnsford Avenue Wimbledon Park SW19 8BH London | British | 38517290002 | ||||||
| FLETCHER, Edward Michael | Sekretär | 3 Aldrich Terrace SW18 3PU Earlsfield | British | 78572640002 | ||||||
| NAUGHTON-DOE, Andrew Henry John | Sekretär | 128 Raleigh Road TW13 4LP Feltham Middlesex | British | 48257810001 | ||||||
| PRESTON, Stuart | Sekretär | 19 Sunlight Close SW19 8TG London | British | 67543580001 | ||||||
| RUTHERFORD, Adam Paul | Sekretär | 1 Great Winchester Street EC2N 2DB London Winchester House | British | 70451850004 | ||||||
| BERRY, John Charles | Geschäftsführer | 12 Leacroft Avenue SW12 8NF Balham London | New Zealander | 56358020004 | ||||||
| BERRY, John Charles | Geschäftsführer | 42 Honeywell Road Clapham SW11 6EF London | New Zealander | 56358020003 | ||||||
| BLASE, Steven Wim | Geschäftsführer | 26 Coleherne Court The Little Boltons SW5 0DL London | Dutch | 56358060001 | ||||||
| BURKE, Peter Robert | Geschäftsführer | 11 Belvedere Grove Wimbledon SW19 7RQ London | Uk | British | 106485040001 | |||||
| CROSS, James Stephen | Geschäftsführer | 44 Romney Drive BR1 2TE Bromley Kent | England | British | 31485080001 | |||||
| GASSON, Thomas | Geschäftsführer | 133 Fleet Street EC4A 2BB London Peterbrough Court United Kingdom | British | 134233280001 | ||||||
| MACFARLANE, Stuart Edward | Geschäftsführer | 6 Lynmouth Road East Finchley N2 9LS London | Australian | 125721120002 | ||||||
| MCGIDDY, Mark Andrew | Geschäftsführer | Great Winchester Street EC2N 2DB London Winchester House 1 | Australian | 114990900003 | ||||||
| PRESS, Matthew | Geschäftsführer | 106 Ledbury Road W11 2AH London | Australian | 104610910001 | ||||||
| ROUGH, Christopher | Geschäftsführer | Great Winchester Street EC2N 2DB London Winchester House 1 | British | 77807760004 | ||||||
| SHORT, Edward Francis Germor | Geschäftsführer | 3 Coulter Road W6 0BJ London | England | British | 70996680002 | |||||
| SIVANITHY, Rajanbabu | Geschäftsführer | 1 Great Winchester Street EC2N 2DB London Winchester House | United Kingdom | British | 63268810003 | |||||
| VASUDEVA, Nicholas Shashi | Geschäftsführer | 57 Linden Gardens W2 4HJ London Flat 1 | British/Australian | 79508880002 |
Hat DB VANTAGE (UK) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Pledge agreement | Erstellt am 05. Jan. 2006 Geliefert am 16. Jan. 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from deutsche bank ag, the company and db vanquish (UK) limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All right title and interest of the company in and to the euroclear entitlements. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Pledge agreement | Erstellt am 05. Jan. 2006 Geliefert am 16. Jan. 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from deutsche bank ag, the company and db vanquish (UK) limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All right title and interest of the company in and to the euroclear entitlements. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security document | Erstellt am 04. Jan. 2006 Geliefert am 16. Jan. 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All its present and future right title and interest in and to the assigned contract including all moneys payable and any claims awards and judgements in connection with the assigned contract and by way of first fixed charge the bank account. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security document | Erstellt am 04. Jan. 2006 Geliefert am 16. Jan. 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All its present and future right title and interest in and to the assigned contract including all moneys payable and any claims awards and judgements in connection with the assigned contract and by way of first fixed charge the bank account. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Pledge agreement | Erstellt am 07. Jan. 2005 Geliefert am 24. Jan. 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The euroclear entitlements. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Pledge agreement | Erstellt am 07. Jan. 2005 Geliefert am 24. Jan. 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The euroclear entitlements. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security document | Erstellt am 06. Jan. 2005 Geliefert am 24. Jan. 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee (the beneficiary) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The assigned contract. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security document | Erstellt am 06. Jan. 2005 Geliefert am 24. Jan. 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee (the beneficiary) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The assigned contract. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Pledge agreement | Erstellt am 02. Juli 2004 Geliefert am 15. Juli 2004 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due to the beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The assigned contract including all moneys payable and any claims awards and judgements under or in connection with the assigned contract and the bank account. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Pledge agreement | Erstellt am 19. März 2004 Geliefert am 02. Apr. 2004 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from deutsche, the company or db vanquish to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All right title and interest of the company in and to the euroclear entitlements. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security document | Erstellt am 18. März 2004 Geliefert am 02. Apr. 2004 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All right title and interest in and to the assigned contract dated 18 march 2004. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A pledge agreement | Erstellt am 01. Apr. 2003 Geliefert am 15. Apr. 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All right title and interest in and to the euroclear entitlements. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Pledge agreement | Erstellt am 01. Apr. 2003 Geliefert am 15. Apr. 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All security assets held deposited or standing to the credit of the account (as defined). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat DB VANTAGE (UK) LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0