FRANKLYN INVESTMENTS LIMITED

FRANKLYN INVESTMENTS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameFRANKLYN INVESTMENTS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03701173
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von FRANKLYN INVESTMENTS LIMITED?

    • Hotels und ähnliche Unterkünfte (55100) / Gastgewerbe

    Wo befindet sich FRANKLYN INVESTMENTS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    20 Crown Passage
    Pall Mall
    SW1Y 6PP London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von FRANKLYN INVESTMENTS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    GOLDLOCK INVESTMENTS LTD26. Jan. 199926. Jan. 1999

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von FRANKLYN INVESTMENTS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2017

    Welche sind die letzten Einreichungen für FRANKLYN INVESTMENTS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Bestätigungserklärung erstellt am 26. Jan. 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Sept. 2017

    9 SeitenAA

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 31. März 2017 bis 30. Sept. 2017

    1 SeitenAA01

    Bestätigungserklärung erstellt am 26. Jan. 2017 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Erfüllung der Belastung 037011730007 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 037011730008 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 037011730009 vollständig

    4 SeitenMR04

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2016

    11 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 26. Jan. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital28. Jan. 2016

    Kapitalaufstellung am 28. Jan. 2016

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2015

    7 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 26. Jan. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital20. Feb. 2015

    Kapitalaufstellung am 20. Feb. 2015

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2014

    6 SeitenAA

    Erfüllung der Belastung 2 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 6 vollständig

    4 SeitenMR04

    Jahresrückblick erstellt bis 26. Jan. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital17. Feb. 2014

    Kapitalaufstellung am 17. Feb. 2014

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Erfüllung der Belastung 5 vollständig

    4 SeitenMR04

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2013

    6 SeitenAA

    Eintragung der Belastung 037011730008

    43 SeitenMR01

    Eintragung der Belastung 037011730009

    36 SeitenMR01

    Eintragung der Belastung 037011730007

    33 SeitenMR01

    Jahresrückblick erstellt bis 26. Jan. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2012

    6 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von FRANKLYN INVESTMENTS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    READ, Laurence John
    27 Mount Park Road
    Ealing
    W5 2RS London
    Sekretär
    27 Mount Park Road
    Ealing
    W5 2RS London
    BritishCompany Director6994820001
    MILLER, David Francis Stuart
    20 Crown Passage
    Pall Mall
    SW1 London
    Geschäftsführer
    20 Crown Passage
    Pall Mall
    SW1 London
    EnglandIrishCompany Director37800460001
    MILLER, Elizabeth Ann
    20 Crown Passage
    SW1Y 6PP London
    Geschäftsführer
    20 Crown Passage
    SW1Y 6PP London
    EnglandBritishCompany Director67516780003
    DOSHI, Jaswantrai
    120 High Street
    HA8 7EL Edgware
    Middlesex
    Sekretär
    120 High Street
    HA8 7EL Edgware
    Middlesex
    BritishAccountant84366510001
    MANDERS, Brian David Richard
    10 Priors Hill
    SG5 3QA Hitchin
    Hertfordshire
    Sekretär
    10 Priors Hill
    SG5 3QA Hitchin
    Hertfordshire
    BritishAccountant31370530001
    FORM 10 SECRETARIES FD LTD
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    Bevollmächtigter Sekretär
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    900014000001
    JEFFREY MANAGEMENT LIMITED
    120 High Street
    HA8 7EL Edgware
    Middlesex
    Sekretär
    120 High Street
    HA8 7EL Edgware
    Middlesex
    26360100001
    GAL, Anthony
    44 Knyveton Road
    BH1 3QX Bournemouth
    Dorset
    Geschäftsführer
    44 Knyveton Road
    BH1 3QX Bournemouth
    Dorset
    United KingdomHungarianBusinessman75165180001
    SANGHVI, Jayantkumar Bhagwanji
    Suite 6g
    1 Britannia House, Leagrave Road
    LU3 1RJ Luton
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    Suite 6g
    1 Britannia House, Leagrave Road
    LU3 1RJ Luton
    Bedfordshire
    BritishAccountant37201270004
    FORM 10 DIRECTORS FD LTD
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    900013990001
    JEFFREY MANAGEMENT LIMITED
    120 High Street
    HA8 7EL Edgware
    Middlesex
    Geschäftsführer
    120 High Street
    HA8 7EL Edgware
    Middlesex
    26360100001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei FRANKLYN INVESTMENTS LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Mr David Francis Miller
    20 Crown Passage
    Pall Mall
    SW1Y 6PP London
    01. Juni 2016
    20 Crown Passage
    Pall Mall
    SW1Y 6PP London
    Nein
    Nationalität: Irish
    Staatsangehörigkeit: England
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hat das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über das Unternehmen auszuüben oder übt diese tatsächlich aus.

    Hat FRANKLYN INVESTMENTS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 29. Nov. 2013
    Geliefert am 13. Dez. 2013
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Dez. 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 09. Nov. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 29. Nov. 2013
    Geliefert am 13. Dez. 2013
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    F/H 30-32 west hill road, west cliff, bournemouth, dorset t/no DT128079 and DT302205. Notification of addition to or amendment of charge.
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Dez. 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 09. Nov. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 29. Nov. 2013
    Geliefert am 07. Dez. 2013
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Dez. 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 09. Nov. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 01. Dez. 2005
    Geliefert am 07. Dez. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 07. Dez. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Okt. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Dez. 2005
    Geliefert am 07. Dez. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a the connaught hotel 30 west hill road bournemouth t/n DT128079. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 07. Dez. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Jan. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Dez. 2005
    Geliefert am 07. Dez. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a the sun court hotel 32 west hill road bournemouth t/n DT302205. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 07. Dez. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Jan. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 10. Okt. 2003
    Geliefert am 22. Okt. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a 32 west hill road, bournemouth t/no DT302205. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 22. Okt. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Jan. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 14. Mai 1999
    Geliefert am 25. Mai 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/Hold property - connaught court hotel,30 west hill rd,bournemouth. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 25. Mai 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Okt. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 14. Mai 1999
    Geliefert am 19. Mai 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 19. Mai 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Jan. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0