FRANKLYN INVESTMENTS LIMITED
Überblick
Unternehmensname | FRANKLYN INVESTMENTS LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 03701173 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von FRANKLYN INVESTMENTS LIMITED?
- Hotels und ähnliche Unterkünfte (55100) / Gastgewerbe
Wo befindet sich FRANKLYN INVESTMENTS LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 20 Crown Passage Pall Mall SW1Y 6PP London |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von FRANKLYN INVESTMENTS LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
GOLDLOCK INVESTMENTS LTD | 26. Jan. 1999 | 26. Jan. 1999 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von FRANKLYN INVESTMENTS LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2017 |
Welche sind die letzten Einreichungen für FRANKLYN INVESTMENTS LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 26. Jan. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Sept. 2017 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 31. März 2017 bis 30. Sept. 2017 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 26. Jan. 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 037011730007 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 037011730008 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 037011730009 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2016 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 26. Jan. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2015 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 26. Jan. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2014 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 2 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 6 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 26. Jan. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Erfüllung der Belastung 5 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2013 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Eintragung der Belastung 037011730008 | 43 Seiten | MR01 | ||||||||||
Eintragung der Belastung 037011730009 | 36 Seiten | MR01 | ||||||||||
Eintragung der Belastung 037011730007 | 33 Seiten | MR01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 26. Jan. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2012 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von FRANKLYN INVESTMENTS LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
READ, Laurence John | Sekretär | 27 Mount Park Road Ealing W5 2RS London | British | Company Director | 6994820001 | |||||
MILLER, David Francis Stuart | Geschäftsführer | 20 Crown Passage Pall Mall SW1 London | England | Irish | Company Director | 37800460001 | ||||
MILLER, Elizabeth Ann | Geschäftsführer | 20 Crown Passage SW1Y 6PP London | England | British | Company Director | 67516780003 | ||||
DOSHI, Jaswantrai | Sekretär | 120 High Street HA8 7EL Edgware Middlesex | British | Accountant | 84366510001 | |||||
MANDERS, Brian David Richard | Sekretär | 10 Priors Hill SG5 3QA Hitchin Hertfordshire | British | Accountant | 31370530001 | |||||
FORM 10 SECRETARIES FD LTD | Bevollmächtigter Sekretär | 39a Leicester Road Salford M7 4AS Manchester Lancashire | 900014000001 | |||||||
JEFFREY MANAGEMENT LIMITED | Sekretär | 120 High Street HA8 7EL Edgware Middlesex | 26360100001 | |||||||
GAL, Anthony | Geschäftsführer | 44 Knyveton Road BH1 3QX Bournemouth Dorset | United Kingdom | Hungarian | Businessman | 75165180001 | ||||
SANGHVI, Jayantkumar Bhagwanji | Geschäftsführer | Suite 6g 1 Britannia House, Leagrave Road LU3 1RJ Luton Bedfordshire | British | Accountant | 37201270004 | |||||
FORM 10 DIRECTORS FD LTD | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 39a Leicester Road Salford M7 4AS Manchester Lancashire | 900013990001 | |||||||
JEFFREY MANAGEMENT LIMITED | Geschäftsführer | 120 High Street HA8 7EL Edgware Middlesex | 26360100001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei FRANKLYN INVESTMENTS LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört |
---|---|---|---|
Mr David Francis Miller | 01. Juni 2016 | 20 Crown Passage Pall Mall SW1Y 6PP London | Nein |
Nationalität: Irish Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
|
Hat FRANKLYN INVESTMENTS LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Erstellt am 29. Nov. 2013 Geliefert am 13. Dez. 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 29. Nov. 2013 Geliefert am 13. Dez. 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung F/H 30-32 west hill road, west cliff, bournemouth, dorset t/no DT128079 and DT302205. Notification of addition to or amendment of charge. Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 29. Nov. 2013 Geliefert am 07. Dez. 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Notification of addition to or amendment of charge. Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 01. Dez. 2005 Geliefert am 07. Dez. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 01. Dez. 2005 Geliefert am 07. Dez. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a the connaught hotel 30 west hill road bournemouth t/n DT128079. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 01. Dez. 2005 Geliefert am 07. Dez. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a the sun court hotel 32 west hill road bournemouth t/n DT302205. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 10. Okt. 2003 Geliefert am 22. Okt. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Property k/a 32 west hill road, bournemouth t/no DT302205. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 14. Mai 1999 Geliefert am 25. Mai 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/Hold property - connaught court hotel,30 west hill rd,bournemouth. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 14. Mai 1999 Geliefert am 19. Mai 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0