CPI COX & WYMAN LTD
Überblick
| Unternehmensname | CPI COX & WYMAN LTD |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03705748 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CPI COX & WYMAN LTD?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich CPI COX & WYMAN LTD?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 8 Springfield Close Ovington NE42 6WZ Prudhoe Northumberland |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CPI COX & WYMAN LTD?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| COX & WYMAN LIMITED | 09. Aug. 1999 | 09. Aug. 1999 |
| PITCOMP 183 LIMITED | 02. Feb. 1999 | 02. Feb. 1999 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CPI COX & WYMAN LTD?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2014 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für CPI COX & WYMAN LTD?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für CPI COX & WYMAN LTD?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 02. Feb. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2014 | 23 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * Cardiff Road Reading Berkshire RG1 8EX* am 13. März 2014 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 07. März 2014
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 02. Feb. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Francois Golicheff als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 10 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 9 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2013 | 24 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 02. Feb. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2012 | 22 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 02. Feb. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2011 | 22 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Matthew William Robson als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael Williams als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 02. Feb. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2010 | 22 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Michael Owen Williams als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Pierre Catte als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CPI COX & WYMAN LTD?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBSON, Matthew William | Sekretär | Reivers Springfield Close NE42 6EL Ovington Northumberland | British | 93423100001 | ||||||
| ROBSON, Matthew William | Geschäftsführer | Springfield Close Ovington NE42 6EL Prudhoe Reivers Northumberland England | England | British | 93423100001 | |||||
| BRIDGE, Philip | Sekretär | 2 Sycamore Leys MK18 2RH Steeple Claydon Buckinghamshire | British | 89576500001 | ||||||
| CARLOT, Michel | Sekretär | 14 Bis Rue De La Voute Paris FOREIGN 75012 France | French | 65557480001 | ||||||
| LOUSSIER, Julien | Sekretär | 59 Rue Jouffroy D'Abbans FOREIGN 75017 Paris France | French | 89031330001 | ||||||
| PITSEC LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 47 Castle Street RG1 7SR Reading Berkshire | 900005210001 | |||||||
| BOVARD, Timothy Landon | Geschäftsführer | 7 Boulevard Anatole France FOREIGN Boulogne 92100 France | British | 101457350001 | ||||||
| CARLOT, Michel | Geschäftsführer | 14 Bis Rue De La Voute Paris FOREIGN 75012 France | French | 65557480001 | ||||||
| CATTE, Pierre Francois | Geschäftsführer | Bis Rue De La Tour 75016 Paris 62 France | France | French | 165234830001 | |||||
| DANIELS, James Alfred | Geschäftsführer | Uplands 200 Bush Road Cuxton ME2 1HE Rochester Kent | England | British | 7562960001 | |||||
| DE BARDIES, Thierry | Geschäftsführer | 8 Rue Du Belvedere 92100 Boulogne FOREIGN Paris France | French | 68371900001 | ||||||
| GOLICHEFF, Francois Jacques Pierre | Geschäftsführer | Cardiff Road RG1 8EX Reading Cox & Wyman House Berkshire | France | French | 146651780001 | |||||
| KELLEY, Kevin Paul | Geschäftsführer | 2 Russett Way Kings Hill ME19 4F West Malling Kent | Usa | 123972060001 | ||||||
| LOUSSIER, Julien | Geschäftsführer | 59 Rue Jouffroy D'Abbans FOREIGN 75017 Paris France | French | 89031330001 | ||||||
| PALFRAMAN, Peter | Geschäftsführer | Larchwood Claverton Down Road BA2 7AE Bath Avon | United Kingdom | British | 46419220001 | |||||
| ROBSON, Matthew William | Geschäftsführer | Reivers Springfield Close NE42 6EL Ovington Northumberland | England | British | 93423100001 | |||||
| WHITE, Christopher Duncan | Geschäftsführer | 1 Copley Court Hanham BS15 3SH Bristol South Gloucestershire | England | British | 73695700001 | |||||
| WILLIAMS, Michael Owen | Geschäftsführer | Fisher Green Binfield RG42 4EQ Bracknell 1 Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 198947630001 | |||||
| CASTLE NOTORNIS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 47 Castle Street RG1 7SR Reading Berkshire | 900005200001 |
Hat CPI COX & WYMAN LTD Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Confirmatory guarantee & debenture | Erstellt am 10. Dez. 2009 Geliefert am 19. Dez. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 30. Sept. 2005 Geliefert am 11. Okt. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Factory and offices cardiff road reading berkshire t/n BK61084 BK64069 BK256584,. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 17. Mai 2002 Geliefert am 29. Mai 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies or liabilities due or to become due from any charging company or any other obligor to the chargee as security agent and trustee for itself and the other secured parties (the "security agent") on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental debenture | Erstellt am 20. Dez. 2000 Geliefert am 09. Jan. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All obligations owing to the secured parties or to the security agent on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 29. Sept. 2000 Geliefert am 13. Okt. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The payment and discharge of all the secured obligations (as defined) due from the borrowers (as defined) to the chargee under or pursuant to the facility documents (as defined) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 11. Juli 2000 Geliefert am 12. Juli 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed charge on purchased debts which fail to vest | Erstellt am 11. Juli 2000 Geliefert am 12. Juli 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee whether arising under an agreement for the purchase of debts or otherwise | |
Kurze Angaben By way of fixed equitable charge all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts between the security holder and the company (including the associated rights relating thereto) which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed charge on purchased debts which fail to vest | Erstellt am 08. Mai 2000 Geliefert am 16. Mai 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee whether arising under the agreement (as defined) or otherwise | |
Kurze Angaben By way of fixed equitable charge all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts between the security holder and the company which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 08. Mai 2000 Geliefert am 16. Mai 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0