CPI COX & WYMAN LTD

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCPI COX & WYMAN LTD
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03705748
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CPI COX & WYMAN LTD?

    • Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften

    Wo befindet sich CPI COX & WYMAN LTD?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    8 Springfield Close
    Ovington
    NE42 6WZ Prudhoe
    Northumberland
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von CPI COX & WYMAN LTD?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    COX & WYMAN LIMITED09. Aug. 199909. Aug. 1999
    PITCOMP 183 LIMITED02. Feb. 199902. Feb. 1999

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CPI COX & WYMAN LTD?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2014

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für CPI COX & WYMAN LTD?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für CPI COX & WYMAN LTD?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresrückblick erstellt bis 02. Feb. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital02. Feb. 2015

    Kapitalaufstellung am 02. Feb. 2015

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2014

    23 SeitenAA

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Cardiff Road Reading Berkshire RG1 8EX* am 13. März 2014

    1 SeitenAD01

    Kapitalaufstellung am 07. März 2014

    • Kapital: GBP 1
    4 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenSH20

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Jahresrückblick erstellt bis 02. Feb. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Beendigung der Bestellung von Francois Golicheff als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Erfüllung der Belastung 10 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 9 vollständig

    4 SeitenMR04

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2013

    24 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 02. Feb. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2012

    22 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 02. Feb. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2011

    22 SeitenAA

    Ernennung von Mr Matthew William Robson als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Michael Williams als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 02. Feb. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2010

    22 SeitenAA

    Ernennung von Mr Michael Owen Williams als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Pierre Catte als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Wer sind die Geschäftsführer von CPI COX & WYMAN LTD?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    ROBSON, Matthew William
    Reivers
    Springfield Close
    NE42 6EL Ovington
    Northumberland
    Sekretär
    Reivers
    Springfield Close
    NE42 6EL Ovington
    Northumberland
    British93423100001
    ROBSON, Matthew William
    Springfield Close
    Ovington
    NE42 6EL Prudhoe
    Reivers
    Northumberland
    England
    Geschäftsführer
    Springfield Close
    Ovington
    NE42 6EL Prudhoe
    Reivers
    Northumberland
    England
    EnglandBritish93423100001
    BRIDGE, Philip
    2 Sycamore Leys
    MK18 2RH Steeple Claydon
    Buckinghamshire
    Sekretär
    2 Sycamore Leys
    MK18 2RH Steeple Claydon
    Buckinghamshire
    British89576500001
    CARLOT, Michel
    14 Bis Rue De La Voute
    Paris
    FOREIGN 75012 France
    Sekretär
    14 Bis Rue De La Voute
    Paris
    FOREIGN 75012 France
    French65557480001
    LOUSSIER, Julien
    59 Rue Jouffroy D'Abbans
    FOREIGN 75017 Paris
    France
    Sekretär
    59 Rue Jouffroy D'Abbans
    FOREIGN 75017 Paris
    France
    French89031330001
    PITSEC LIMITED
    47 Castle Street
    RG1 7SR Reading
    Berkshire
    Bevollmächtigter Sekretär
    47 Castle Street
    RG1 7SR Reading
    Berkshire
    900005210001
    BOVARD, Timothy Landon
    7 Boulevard Anatole France
    FOREIGN Boulogne
    92100
    France
    Geschäftsführer
    7 Boulevard Anatole France
    FOREIGN Boulogne
    92100
    France
    British101457350001
    CARLOT, Michel
    14 Bis Rue De La Voute
    Paris
    FOREIGN 75012 France
    Geschäftsführer
    14 Bis Rue De La Voute
    Paris
    FOREIGN 75012 France
    French65557480001
    CATTE, Pierre Francois
    Bis Rue De La Tour
    75016 Paris
    62
    France
    Geschäftsführer
    Bis Rue De La Tour
    75016 Paris
    62
    France
    FranceFrench165234830001
    DANIELS, James Alfred
    Uplands 200 Bush Road
    Cuxton
    ME2 1HE Rochester
    Kent
    Geschäftsführer
    Uplands 200 Bush Road
    Cuxton
    ME2 1HE Rochester
    Kent
    EnglandBritish7562960001
    DE BARDIES, Thierry
    8 Rue Du Belvedere
    92100 Boulogne
    FOREIGN Paris
    France
    Geschäftsführer
    8 Rue Du Belvedere
    92100 Boulogne
    FOREIGN Paris
    France
    French68371900001
    GOLICHEFF, Francois Jacques Pierre
    Cardiff Road
    RG1 8EX Reading
    Cox & Wyman House
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Cardiff Road
    RG1 8EX Reading
    Cox & Wyman House
    Berkshire
    FranceFrench146651780001
    KELLEY, Kevin Paul
    2 Russett Way
    Kings Hill
    ME19 4F West Malling
    Kent
    Geschäftsführer
    2 Russett Way
    Kings Hill
    ME19 4F West Malling
    Kent
    Usa123972060001
    LOUSSIER, Julien
    59 Rue Jouffroy D'Abbans
    FOREIGN 75017 Paris
    France
    Geschäftsführer
    59 Rue Jouffroy D'Abbans
    FOREIGN 75017 Paris
    France
    French89031330001
    PALFRAMAN, Peter
    Larchwood
    Claverton Down Road
    BA2 7AE Bath
    Avon
    Geschäftsführer
    Larchwood
    Claverton Down Road
    BA2 7AE Bath
    Avon
    United KingdomBritish46419220001
    ROBSON, Matthew William
    Reivers
    Springfield Close
    NE42 6EL Ovington
    Northumberland
    Geschäftsführer
    Reivers
    Springfield Close
    NE42 6EL Ovington
    Northumberland
    EnglandBritish93423100001
    WHITE, Christopher Duncan
    1 Copley Court
    Hanham
    BS15 3SH Bristol
    South Gloucestershire
    Geschäftsführer
    1 Copley Court
    Hanham
    BS15 3SH Bristol
    South Gloucestershire
    EnglandBritish73695700001
    WILLIAMS, Michael Owen
    Fisher Green
    Binfield
    RG42 4EQ Bracknell
    1
    Berkshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Fisher Green
    Binfield
    RG42 4EQ Bracknell
    1
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish198947630001
    CASTLE NOTORNIS LIMITED
    47 Castle Street
    RG1 7SR Reading
    Berkshire
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    47 Castle Street
    RG1 7SR Reading
    Berkshire
    900005200001

    Hat CPI COX & WYMAN LTD Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Confirmatory guarantee & debenture
    Erstellt am 10. Dez. 2009
    Geliefert am 19. Dez. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC, Paris Branch as Security Agent and as Agent for the Secured Parties (The Security Agent)
    Transaktionen
    • 19. Dez. 2009Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 21. Dez. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 30. Sept. 2005
    Geliefert am 11. Okt. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Factory and offices cardiff road reading berkshire t/n BK61084 BK64069 BK256584,. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC Paris Branch as Security Agent and as Agent for the Securedparties (The Security Agent)
    Transaktionen
    • 11. Okt. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Dez. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 17. Mai 2002
    Geliefert am 29. Mai 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies or liabilities due or to become due from any charging company or any other obligor to the chargee as security agent and trustee for itself and the other secured parties (the "security agent") on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 29. Mai 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Nov. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 20. Dez. 2000
    Geliefert am 09. Jan. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All obligations owing to the secured parties or to the security agent on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 09. Jan. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Nov. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 29. Sept. 2000
    Geliefert am 13. Okt. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The payment and discharge of all the secured obligations (as defined) due from the borrowers (as defined) to the chargee under or pursuant to the facility documents (as defined)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC,as Security Trustee for the Secured Parties (As Defined)
    Transaktionen
    • 13. Okt. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Nov. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 11. Juli 2000
    Geliefert am 12. Juli 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Fmn Financial Limited
    Transaktionen
    • 12. Juli 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Jan. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest
    Erstellt am 11. Juli 2000
    Geliefert am 12. Juli 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee whether arising under an agreement for the purchase of debts or otherwise
    Kurze Angaben
    By way of fixed equitable charge all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts between the security holder and the company (including the associated rights relating thereto) which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason.
    Berechtigte Personen
    • Fmn Financial Limited
    Transaktionen
    • 12. Juli 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Jan. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest
    Erstellt am 08. Mai 2000
    Geliefert am 16. Mai 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee whether arising under the agreement (as defined) or otherwise
    Kurze Angaben
    By way of fixed equitable charge all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts between the security holder and the company which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason.
    Berechtigte Personen
    • Fortis Bank Sa-N.V.
    Transaktionen
    • 16. Mai 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Jan. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 08. Mai 2000
    Geliefert am 16. Mai 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Fortis Bank Sa-N.V.
    Transaktionen
    • 16. Mai 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Jan. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0