WATERS RETAIL LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameWATERS RETAIL LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03716100
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von WATERS RETAIL LIMITED?

    • (5010) /
    • (5020) /
    • (5030) /

    Wo befindet sich WATERS RETAIL LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    c/o ZOLFO COOPER
    The Zenith Building
    Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von WATERS RETAIL LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    W WATERS & SONS LTD10. März 199910. März 1999
    WATERS (1896) LIMITED19. Feb. 199919. Feb. 1999

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WATERS RETAIL LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2009

    Welche sind die letzten Einreichungen für WATERS RETAIL LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    12 Seiten4.72

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 04. Okt. 2012

    14 Seiten2.24B

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    1 Seiten2.34B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 04. Apr. 2012

    13 Seiten2.24B

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    1 SeitenF2.18

    Vorschlag des Verwalters

    49 Seiten2.17B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    32 Seiten2.16B

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Waters Retail Lyon Way St Albans Hertfordshire AL4 0LQ am 12. Okt. 2011

    2 SeitenAD01

    Jahresrückblick erstellt bis 19. Feb. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital29. März 2011

    Kapitalaufstellung am 29. März 2011

    • Kapital: GBP 4,800,000
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr John Robert Hannah am 19. Feb. 2011

    2 SeitenCH01

    Beendigung der Bestellung von Darren Payne als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Register(s) wurden an die Geschäftsanschrift verlegt

    1 SeitenAD04

    Ernennung von Mark Frank Jenkins als Direktor

    3 SeitenAP01

    legacy

    5 SeitenMG01

    Jahresrückblick erstellt bis 19. Feb. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt

    1 SeitenAD03

    Die Adresse der Registerinspektion wurde geändert

    1 SeitenAD02

    Änderung der Details des Sekretärs für Mr John Robert Hannah am 19. Feb. 2010

    1 SeitenCH03

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009

    20 SeitenAA

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008

    19 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    5 Seiten395

    legacy

    3 Seiten395

    Wer sind die Geschäftsführer von WATERS RETAIL LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    HANNAH, John Robert
    c/o Zolfo Cooper
    Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    The Zenith Building
    Sekretär
    c/o Zolfo Cooper
    Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    The Zenith Building
    British138883780001
    HANNAH, John Robert
    c/o Zolfo Cooper
    Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    The Zenith Building
    Geschäftsführer
    c/o Zolfo Cooper
    Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    The Zenith Building
    United KingdomBritish138883780001
    JENKINS, Mark Frank
    c/o Zolfo Cooper
    Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    The Zenith Building
    Geschäftsführer
    c/o Zolfo Cooper
    Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    The Zenith Building
    UkBritish93204480001
    COOK, Roger Daniel
    Bell House
    29 Church Road Totternhoe
    LU6 1RE Dunstable
    Bedfordshire
    Sekretär
    Bell House
    29 Church Road Totternhoe
    LU6 1RE Dunstable
    Bedfordshire
    British141282680001
    VARNEY, Peter Reginald
    Thornemill House
    Ninfield Road Lunsford Cross
    TN39 5JR Bexhill On Sea
    East Sussex
    Sekretär
    Thornemill House
    Ninfield Road Lunsford Cross
    TN39 5JR Bexhill On Sea
    East Sussex
    British68629570001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Bevollmächtigter Sekretär
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    COMBER, David Cyril
    45 Mill Road
    Sharnbrook
    MK44 1NX Bedford
    Bedfordshire
    England
    Geschäftsführer
    45 Mill Road
    Sharnbrook
    MK44 1NX Bedford
    Bedfordshire
    England
    British60898610001
    COOK, Roger Daniel
    Bell House
    29 Church Road Totternhoe
    LU6 1RE Dunstable
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    Bell House
    29 Church Road Totternhoe
    LU6 1RE Dunstable
    Bedfordshire
    British141282680001
    HESLOP, David Christopher
    Burford Lodge
    Church Road
    TN6 1BL Crowborough
    East Sussex
    Geschäftsführer
    Burford Lodge
    Church Road
    TN6 1BL Crowborough
    East Sussex
    United KingdomBritish18365540002
    ISHIKAWA, Masashi
    2 Julians Way
    TN13 2PE Sevenoaks
    Kent
    Geschäftsführer
    2 Julians Way
    TN13 2PE Sevenoaks
    Kent
    Japanese74123760005
    KATANO, Tomio
    7 Arran Mews
    W5 3PY London
    Geschäftsführer
    7 Arran Mews
    W5 3PY London
    Japanese103307300002
    MURAI, Kenji
    Oakhill Road
    TN13 1AB Sevenoaks
    3 Birch Place
    Kent
    Geschäftsführer
    Oakhill Road
    TN13 1AB Sevenoaks
    3 Birch Place
    Kent
    Japanese117074780002
    OFSTEDAHL, Darryl Bryan
    37 High Road
    Shillington
    SG5 3LL Hitchin
    Hertfordshire
    England
    Geschäftsführer
    37 High Road
    Shillington
    SG5 3LL Hitchin
    Hertfordshire
    England
    Canadian60898890001
    PAYNE, Darren
    Ledborough Gate
    HP9 2DQ Beaconsfield
    Wakehurst Lodge
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Ledborough Gate
    HP9 2DQ Beaconsfield
    Wakehurst Lodge
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish138883790002
    SHIBATA, Ichiro
    17 The Dene
    TN13 1PB Sevenoaks
    Kent
    Geschäftsführer
    17 The Dene
    TN13 1PB Sevenoaks
    Kent
    British103307260001
    VARNEY, Peter Reginald
    Thornemill House
    Ninfield Road Lunsford Cross
    TN39 5JR Bexhill On Sea
    East Sussex
    Geschäftsführer
    Thornemill House
    Ninfield Road Lunsford Cross
    TN39 5JR Bexhill On Sea
    East Sussex
    British68629570001
    VILTON, John Philip
    Carrigans
    16 New Road
    AL6 0AG Welwyn
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Carrigans
    16 New Road
    AL6 0AG Welwyn
    Hertfordshire
    British17532180003

    Hat WATERS RETAIL LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    General charge
    Erstellt am 08. Juli 2010
    Geliefert am 13. Juli 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the company's assets of whatsoever nature wheresoever both situated both present and future including uncalled capital see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Volkswagen Bank Gmbh Trading as Volkswagen Bank United Kingdom Branch
    Transaktionen
    • 13. Juli 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    Deed of charge over credit balances
    Erstellt am 21. Juli 2009
    Geliefert am 29. Juli 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) & the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon. It also creates an assignment by the chargor for the purposes of & to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) & interest thereon barclays bank PLC re waters retail limited business premium account, account number 43403173.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Juli 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 13. Juli 2009
    Geliefert am 23. Juli 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent & trustee for the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Psa Wholesale Limited
    Transaktionen
    • 23. Juli 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Charge on new and used motor vehicles
    Erstellt am 17. Nov. 2006
    Geliefert am 21. Nov. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of first floating charge all such of the present and future property and assets of the borrower,all new and used mazda motor vehicles that are funded and/or supplied by fce,first fixed charge all proceeds of sale or other dispostion of any of the motor vehicles. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Fce Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Nov. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Feb. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Jan. 2002
    Geliefert am 05. Feb. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of first legal mortgage land and premises at 802-808 green lanes, winchmore hill, enfield, london N21 2SA, title numbers EGL333448 and EGL313673 and all buildings, fixed plant and machinery thereon and all rights, easements and privileges relating thereto.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Psa Wholesale Limited
    Transaktionen
    • 05. Feb. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Juni 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Rental deposit deed
    Erstellt am 27. Juli 2001
    Geliefert am 03. Aug. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease
    Kurze Angaben
    The deposit account referred to in the deed and all money withdrawn from it pursuant to the deed (the initial amount deposited is £12,000).
    Berechtigte Personen
    • Vittoria Nina Cox
    Transaktionen
    • 03. Aug. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Nov. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 22. Apr. 1999
    Geliefert am 27. Apr. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Apr. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Nov. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 08. März 1999
    Geliefert am 13. März 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company,formerly known as waters (1896) limited,to the chargee or peugeot motor company PLC on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land and buildings at aero garage,comet way,hatfield; t/no HD347108; all buildings,fixtures,fixed plant/machinery thereon with all rights,easements/privileges thereto; the benefit of all contracts/warranties thereto and all moneys from time to time payable under any contracts/policies of insurance. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Psa Wholesale Limited
    Transaktionen
    • 13. März 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Juni 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 08. März 1999
    Geliefert am 13. März 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company,formerly known as waters (1896) limited,to the chargee or peugeot motor company PLC on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land/blds at west herts toyota,water end,hemel hempstead; t/no hd 246151; all buildings,fixed plant machinery and fixtures thereon with all related rights thereto; the benefit of all contracts/warranties and all moneys payable under any contracts/policies of insurance. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Psa Wholesale Limited
    Transaktionen
    • 13. März 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Dez. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 08. März 1999
    Geliefert am 13. März 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company,formerly known as waters (1896) limited,to the chargee or peugeot motor company PLC on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land/blds at 58-60 st andrew street,hertford; t/no hd 206810; all buildings,fixtures,plant/machinery thereon together with all related rights thereto; the benefit of all contracts/warranties and all moneys payable under any contracts/policies of insurance. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Psa Wholesale Limited
    Transaktionen
    • 13. März 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Dez. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 08. März 1999
    Geliefert am 13. März 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company,formerly known as waters (1896) limited,to the chargee or peugeot motor company PLC on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land/blds at waters garage,3/9 north rd,hertford; t/no HD207906 with all buildings,fixtures,plant/machinery thereon and all rights thereto; the benefit of all contracts and warranties and all moneys payable under any contracts or policies of insurance. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Psa Wholesale Limited
    Transaktionen
    • 13. März 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Dez. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 08. März 1999
    Geliefert am 13. März 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company,formerly known as waters (1896) limited,to the chargee or peugeot motor company PLC on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land/blds at 29 burrowfield welwyn garden city; t/no hd 158149; all buildings,fixtures,plant,machinery thereon and all rights thereto; benefit of all contracts and all moneys payable from time to time under any contracts or policies of insurance.
    Berechtigte Personen
    • Psa Wholesale Limited
    Transaktionen
    • 13. März 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Dez. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 08. März 1999
    Geliefert am 13. März 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company,formerly known as waters (1896) limited,to the chargee or peugeot motor company PLC on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land/blds at coachfields,fiddle bridge lane,hatfield; t/no HD316382; all buildings,fixtures,plant/machinery thereon and all rights,easements,benefit of all contracts/warranties thereto; all moneys payable from time to time under any contracts or policies of insurance.
    Berechtigte Personen
    • Psa Wholesale Limited
    Transaktionen
    • 13. März 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Apr. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 08. März 1999
    Geliefert am 13. März 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company,formerly known as waters (1896) limited,to the chargee or peugeot motor company PLC on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land/blds at 12 harpsfield broadway,comet way,hatfield; t/no HD13725; all buildings,fixtures,fixed plant/machinery thereon and all rights thereto; the benefit of all contracts and all moneys payable under contracts or policies of insurance. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Psa Wholesale Limited
    Transaktionen
    • 13. März 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Nov. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Used vehicle charge
    Erstellt am 08. März 1999
    Geliefert am 13. März 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company,formerly known as waters (1896) limited,to either psa wholesale limited or peugeot motor company PLC under any agreement on any account whatsoever and under this charge
    Kurze Angaben
    All rights,title and interest of the dealer in and to the insurances and moneys anmd any return of premiums thereof; all stocks of used vehicles. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Psa Wholesale Limited
    Transaktionen
    • 13. März 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Juli 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 08. März 1999
    Geliefert am 13. März 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company,formerly known as waters (1896) limited,to the chargee or peugeot motor company PLC under any agreement or this debenture on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Psa Wholesale Limited
    Transaktionen
    • 13. März 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Apr. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat WATERS RETAIL LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    05. Okt. 2011Beginn der Verwaltung
    04. Okt. 2012Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Anne Clare O'Keefe
    The Zenith Building 26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Praktiker
    The Zenith Building 26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Charles Peter Holder
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praktiker
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Kevin James Coates
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praktiker
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    2
    DatumTyp
    04. Okt. 2012Beginn der Liquidation
    05. Okt. 2013Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Anne Clare O'Keefe
    The Zenith Building 26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Praktiker
    The Zenith Building 26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Charles Peter Holder
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praktiker
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Kevin James Coates
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praktiker
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0