ISOFT GROUP (UK) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameISOFT GROUP (UK) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03716736
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von ISOFT GROUP (UK) LIMITED?

    • Beratung im Bereich Informationstechnologie (62020) / Information und Kommunikation
    • Sonstige Informationsdienstleistungen im Bereich Informationstechnologie (62090) / Information und Kommunikation

    Wo befindet sich ISOFT GROUP (UK) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    KROLL ADVISORY LTD
    The Shard 32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von ISOFT GROUP (UK) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    ISOFT GROUP LIMITED01. Sept. 201101. Sept. 2011
    ISOFT GROUP PLC19. Juli 199919. Juli 1999
    PINCO 1179 LIMITED22. Feb. 199922. Feb. 1999

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ISOFT GROUP (UK) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2021

    Welche sind die letzten Einreichungen für ISOFT GROUP (UK) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    11 SeitenLIQ13

    Beendigung der Bestellung von Christopher Neal Halbard als Geschäftsführer am 01. Apr. 2023

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Steven James Turpie als Geschäftsführer am 15. Juli 2022

    1 SeitenTM01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    6 SeitenLIQ01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 31. Mai 2022

    LRESSP

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Royal Pavilion Wellesley Road Aldershot Hampshire GU11 1PZ zum The Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG am 15. Juni 2022

    2 SeitenAD01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2021

    23 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 22. Feb. 2022 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Kapitalaufstellung am 13. Dez. 2021

    • Kapital: GBP 1.1
    5 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenSH20

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 16. Sept. 2021

    • Kapital: GBP 1.1
    3 SeitenSH01

    Änderung der Details des Direktors für Steven James Turpie am 28. Apr. 2021

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Christopher Neal Halbard am 31. März 2021

    2 SeitenCH01

    Bestätigungserklärung erstellt am 22. Feb. 2021 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Change of details for Csc Computer Sciences International Operations Limited as a person with significant control on 01. Apr. 2020

    2 SeitenPSC05

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2020

    21 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Andrea Fiumicelli als Geschäftsführer am 31. Mai 2020

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Tina Anne Gough als Geschäftsführer am 07. Apr. 2020

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Christopher Neal Halbard als Direktor am 07. Apr. 2020

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Steven James Turpie als Direktor am 04. März 2020

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Maruf Ahmad Majed als Geschäftsführer am 26. Feb. 2020

    1 SeitenTM01

    Wer sind die Geschäftsführer von ISOFT GROUP (UK) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    WOODFINE, Michael Charles
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    The Shard
    Sekretär
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    The Shard
    British183106810001
    WOODFINE, Michael Charles
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    The Shard
    Geschäftsführer
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    The Shard
    EnglandBritish208597210001
    CRYNE, Patrick
    The Tannery
    Town Lane
    SK14 6HQ Charlesworth
    Cheshire
    Sekretär
    The Tannery
    Town Lane
    SK14 6HQ Charlesworth
    Cheshire
    British58894020001
    EDELMAN, Howard Todd
    Elizabeth Bay Road
    2011 Elizabeth Bay
    84/108
    Nsw
    Australia
    Sekretär
    Elizabeth Bay Road
    2011 Elizabeth Bay
    84/108
    Nsw
    Australia
    Australian126124430005
    GRAY, David William Hart
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    Sekretär
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    British177358270001
    HILL, Teifion Mark
    59 Hill Top Avenue
    Cheadle Hulme
    SK8 7HZ Stockport
    Cheshire
    Sekretär
    59 Hill Top Avenue
    Cheadle Hulme
    SK8 7HZ Stockport
    Cheshire
    British100105520001
    WHISTON, Timothy Andrew
    Boothshill Farm
    Booths Lane
    WA13 0PF Lymm
    Cheshire
    Sekretär
    Boothshill Farm
    Booths Lane
    WA13 0PF Lymm
    Cheshire
    British69575560002
    WILSON, Gareth Antony
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    Sekretär
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    162049470001
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    Bevollmächtigter Sekretär
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    900013300001
    ADAMS, Stuart Malcolm
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandAustralian183104980001
    AP GWILYM, Eurfyl, Dr
    12 Ty Draw Road
    CF23 5HA Cardiff
    Geschäftsführer
    12 Ty Draw Road
    CF23 5HA Cardiff
    United KingdomBritish74774890003
    COHEN, Gary Michael
    178 Hopetoun Avenue,
    Watsons Bay
    Nsw 2030
    Australia
    Geschäftsführer
    178 Hopetoun Avenue,
    Watsons Bay
    Nsw 2030
    Australia
    AustraliaAustralian125992970001
    CRYNE, Patrick
    The Tannery
    Town Lane
    SK14 6HQ Charlesworth
    Cheshire
    Geschäftsführer
    The Tannery
    Town Lane
    SK14 6HQ Charlesworth
    Cheshire
    EnglandBritish58894020001
    DICKENS, Roger Joseph
    6 Woodbourne Road
    Edgbaston
    B15 3QH Birmingham
    West Midlands
    Geschäftsführer
    6 Woodbourne Road
    Edgbaston
    B15 3QH Birmingham
    West Midlands
    British63562150001
    DIGBY LORD JONES OF BIRMINGHAM
    58 Elizabeth Court
    NW1 6EJ London
    Geschäftsführer
    58 Elizabeth Court
    NW1 6EJ London
    British88447680001
    FIUMICELLI, Andrea
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    ItalyItalian135619020001
    GOUGH, Tina Anne
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United KingdomBritish229756300001
    GRAHAM, Stephen Paul
    Brackenridge
    Mereside Road
    WA16 6QR Mere
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Brackenridge
    Mereside Road
    WA16 6QR Mere
    Cheshire
    United KingdomBritish97528710001
    GRAY, David William Hart
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish224241390001
    GULLAN, Alan Graham Hugh
    The Ridgeway
    TN10 4NJ Tonbridge
    55
    Kent
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    The Ridgeway
    TN10 4NJ Tonbridge
    55
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritish51122700007
    HALBARD, Christopher Neal
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    The Shard
    Geschäftsführer
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    The Shard
    United KingdomBritish152748570001
    HANDLEY, John Martin
    Mintz Cottage
    Cakebole, Chaddesley Corbett
    DY10 4RF Kidderminster
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    Mintz Cottage
    Cakebole, Chaddesley Corbett
    DY10 4RF Kidderminster
    Worcestershire
    EnglandBritish75640920001
    HENRY, William Patrick
    9 Grafton Road
    GL50 2ET Cheltenham
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    9 Grafton Road
    GL50 2ET Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandAmerican119049370001
    JAMES, Gavin Keith, Mr.
    Camelford
    Bradcutts Lane
    SL6 9AA Cookham Dean
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Camelford
    Bradcutts Lane
    SL6 9AA Cookham Dean
    Berkshire
    EnglandBritish44173560008
    KERN, Rene
    36 Butternut Hollow Road
    Greenwich
    Connecticut 06830
    Usa
    Geschäftsführer
    36 Butternut Hollow Road
    Greenwich
    Connecticut 06830
    Usa
    German89259110001
    KUMAR, Ravi
    14 Parkham Close
    Daisy Hill Westhaughton
    BL5 2GT Bolton
    Lancashire
    Geschäftsführer
    14 Parkham Close
    Daisy Hill Westhaughton
    BL5 2GT Bolton
    Lancashire
    British101025710001
    LEVER, Kenneth
    Beechwood House
    Old Long Grove, Seer Green
    HP9 2QH Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Beechwood House
    Old Long Grove, Seer Green
    HP9 2QH Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British50134030002
    LORIA, Giovanni
    One Pancras Square
    Kings Cross
    N1C 4AG London
    Csc
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    One Pancras Square
    Kings Cross
    N1C 4AG London
    Csc
    United Kingdom
    EnglandBritish134764880002
    MACKAY, James Gordon
    Daventry Road
    OX16 3JT Banbury
    Isoft Group Plc
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Daventry Road
    OX16 3JT Banbury
    Isoft Group Plc
    Oxfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish178097680001
    MAJED, Maruf Ahmad
    One Pancras Square
    King's Cross
    N1C 4AG London
    Dxc
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    One Pancras Square
    King's Cross
    N1C 4AG London
    Dxc
    United Kingdom
    SingaporeAmerican245085610001
    MOORE, Christopher Edward
    Fanthill Hayway Lane
    Hook Norton
    OX15 5QJ Banbury
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Fanthill Hayway Lane
    Hook Norton
    OX15 5QJ Banbury
    Oxfordshire
    EnglandBritish34428100003
    RICHARDS, Paul
    The Barn Green Lane
    South Newington
    OX15 4JH Banbury
    Geschäftsführer
    The Barn Green Lane
    South Newington
    OX15 4JH Banbury
    United KingdomBritish126777780001
    SERIES, Ronald Charles
    Daventry Road
    OX16 3JT Banbury
    Isoft
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Daventry Road
    OX16 3JT Banbury
    Isoft
    Oxfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish118534550001
    STEVENS, Adrian Charles
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritish76964750002
    THOMSON, Andrew James Edward
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritish147270780001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ISOFT GROUP (UK) LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Wellesley Road
    GU11 1P2 Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    06. Okt. 2016
    Wellesley Road
    GU11 1P2 Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformPrivate Company Limited By Shares
    RegistrierungslandEngland & Wales
    RechtsgrundlageUnited Kingdom
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer07073279
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für ISOFT GROUP (UK) LIMITED?

    Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss
    Benachrichtigt amAufgehört amErklärung
    22. Feb. 201705. Okt. 2016Das Unternehmen weiß oder hat Grund zu der Annahme, dass es eine registrierungspflichtige Person in Bezug auf das Unternehmen gibt, hat diese jedoch nicht identifiziert.

    Hat ISOFT GROUP (UK) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    English law governed supplemental security agreement
    Erstellt am 23. Nov. 2010
    Geliefert am 30. Nov. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    First fixed charge all of its rights title and interest in respect of any security account and any amount standing to the credit of any security account see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Nov. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 01. Aug. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Supplemental security agreement
    Erstellt am 24. März 2010
    Geliefert am 31. März 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All estates or interests in the leasehold property, all buildings, erections and fixtures and the benefit of any covenants see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 31. März 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 01. Aug. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Security agreement
    Erstellt am 30. Dez. 2009
    Geliefert am 18. Jan. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All f/h and l/h property,all equipment and fixed assets,all shares,all other stocks debentures,bonds,warrants,coupons or other securities see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (The Security Agreement)
    Transaktionen
    • 18. Jan. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 01. Aug. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Security agreement
    Erstellt am 30. Dez. 2009
    Geliefert am 13. Jan. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All f/h and l/h property,all equipment and fixed assets,all shares,all other stocks debentures,bonds,warrants,coupons or other securities see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (The Security Agent)
    Transaktionen
    • 13. Jan. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 01. Aug. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    A supplemental security agreement
    Erstellt am 14. Feb. 2008
    Geliefert am 19. Feb. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each borrower and each target guarantor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H property k/a 300 longbarn boulevard birchwood warrington t/no CH348589. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Abn Amro Bank N.V., London Branch as Agent and Trustee for the Secured Parties (The Securityagent)
    Transaktionen
    • 19. Feb. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. März 2008
    • 16. Jan. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    A security agreement
    Erstellt am 30. Okt. 2007
    Geliefert am 14. Nov. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each borrower and each target guarantor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Abn Amro Bank N.V, London Branch (The Security Agent)
    Transaktionen
    • 14. Nov. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Jan. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    A security agreement
    Erstellt am 30. Okt. 2007
    Geliefert am 14. Nov. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each borrower and each target guarantor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Abn Amro Bank N.V, London Branch (The Security Agent)
    Transaktionen
    • 14. Nov. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Jan. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Omnibus guarantee and set-off agreement
    Erstellt am 24. Aug. 2006
    Geliefert am 31. Aug. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Any sums or sums standing to the credit if any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 31. Aug. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Apr. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 30TH january 2003
    Erstellt am 13. Apr. 2006
    Geliefert am 28. Apr. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Apr. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Nov. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 29. Apr. 2004
    Geliefert am 07. Mai 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the parent company, any chargor or any of the parent company's subsidiaries to the finance parties or any of them and such other banks or financial institutions under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Agent and Security Trustee
    Transaktionen
    • 07. Mai 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Okt. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Security assignment
    Erstellt am 02. Mai 2003
    Geliefert am 14. Mai 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All right title benefit and interest under or arising out of or in respect of supply agreements between the company and its customers. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hanover Asset Finance Limited
    Transaktionen
    • 14. Mai 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. März 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Security assignment
    Erstellt am 30. Apr. 2003
    Geliefert am 14. Mai 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All of its right title benefit and interest, present and future, whether proprietary contractual or otherwise under or arising out of or in respect of supply agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hanover Asset Finance Limited
    Transaktionen
    • 14. Mai 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. März 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Security assignment
    Erstellt am 28. Apr. 2003
    Geliefert am 14. Mai 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All of its right title benefit and interest, present and future, whether proprietary contractual or otherwise under or arising out of or in respect of supply agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hanover Asset Finance Limited
    Transaktionen
    • 14. Mai 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. März 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Set-off agreement
    Erstellt am 30. Jan. 2003
    Geliefert am 19. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The companies agree that the bank may at any time and from time to time combine or consolidate all or any of the then existing accounts of the companies with all or any of the liabilities of the companies or any of them to the bank under the ancillary facilities and/or set-off and transfer any sum or sums standing to the credit of one or more of such accounts. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Aug. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Security assignment
    Erstellt am 07. Nov. 2002
    Geliefert am 14. Nov. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All of its right title benefit and interest present and future under or arising out of or in respect of supply agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hanover Asset Finance Limited
    Transaktionen
    • 14. Nov. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. März 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 30. Juli 2002
    Geliefert am 20. Aug. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All money,obligations and liabilities due or to become due from each chargor to the chargee and to the lenders (or any of them) in any currency under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Including (I) suite 306,bridgewater house,58-60 whitworth street,manchester; (ii) suite 202,bridgewater house,58-60 whitworth street,manchester; (iii) units 2.01-2.05 faraday wharf aston science park,holt street,birmingham; see form 395 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC,as Security Trustee
    Transaktionen
    • 20. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Aug. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage of a life policy
    Erstellt am 27. März 2000
    Geliefert am 05. Apr. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All money including bonuses that has accrued or may become payale under the policy. The benefit of all options and rights given to the company in connection with the policy and all the companys rights and interest in the policy.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Apr. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Aug. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortagage of a life policy
    Erstellt am 27. März 2000
    Geliefert am 05. Apr. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All money including bonuses that has accrued or may become payale under the policy. The benefit of all options and righhts given to the company in connection with the policy and all the companys rights and interest in the policy.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Apr. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Aug. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 21. Juni 1999
    Geliefert am 24. Juni 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Juni 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Aug. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat ISOFT GROUP (UK) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    31. Mai 2022Beginn der Liquidation
    06. Sept. 2023Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Edward Robert Bines
    Kroll Advisory Ltd The Shard 32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Praktiker
    Kroll Advisory Ltd The Shard 32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Paul David Williams
    The Shard, 32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Praktiker
    The Shard, 32 London Bridge Street
    SE1 9SG London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0