ISOFT GROUP (UK) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | ISOFT GROUP (UK) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03716736 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ISOFT GROUP (UK) LIMITED?
- Beratung im Bereich Informationstechnologie (62020) / Information und Kommunikation
- Sonstige Informationsdienstleistungen im Bereich Informationstechnologie (62090) / Information und Kommunikation
Wo befindet sich ISOFT GROUP (UK) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | KROLL ADVISORY LTD The Shard 32 London Bridge Street SE1 9SG London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ISOFT GROUP (UK) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| ISOFT GROUP LIMITED | 01. Sept. 2011 | 01. Sept. 2011 |
| ISOFT GROUP PLC | 19. Juli 1999 | 19. Juli 1999 |
| PINCO 1179 LIMITED | 22. Feb. 1999 | 22. Feb. 1999 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ISOFT GROUP (UK) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2021 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ISOFT GROUP (UK) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 11 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Christopher Neal Halbard als Geschäftsführer am 01. Apr. 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Steven James Turpie als Geschäftsführer am 15. Juli 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 6 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Royal Pavilion Wellesley Road Aldershot Hampshire GU11 1PZ zum The Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG am 15. Juni 2022 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2021 | 23 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 22. Feb. 2022 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 13. Dez. 2021
| 5 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 16. Sept. 2021
| 3 Seiten | SH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Steven James Turpie am 28. Apr. 2021 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Christopher Neal Halbard am 31. März 2021 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 22. Feb. 2021 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Change of details for Csc Computer Sciences International Operations Limited as a person with significant control on 01. Apr. 2020 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2020 | 21 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrea Fiumicelli als Geschäftsführer am 31. Mai 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Tina Anne Gough als Geschäftsführer am 07. Apr. 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Christopher Neal Halbard als Direktor am 07. Apr. 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Steven James Turpie als Direktor am 04. März 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Maruf Ahmad Majed als Geschäftsführer am 26. Feb. 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ISOFT GROUP (UK) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOODFINE, Michael Charles | Sekretär | 32 London Bridge Street SE1 9SG London The Shard | British | 183106810001 | ||||||
| WOODFINE, Michael Charles | Geschäftsführer | 32 London Bridge Street SE1 9SG London The Shard | England | British | 208597210001 | |||||
| CRYNE, Patrick | Sekretär | The Tannery Town Lane SK14 6HQ Charlesworth Cheshire | British | 58894020001 | ||||||
| EDELMAN, Howard Todd | Sekretär | Elizabeth Bay Road 2011 Elizabeth Bay 84/108 Nsw Australia | Australian | 126124430005 | ||||||
| GRAY, David William Hart | Sekretär | Wellesley Road GU11 1PZ Aldershot Royal Pavilion Hampshire United Kingdom | British | 177358270001 | ||||||
| HILL, Teifion Mark | Sekretär | 59 Hill Top Avenue Cheadle Hulme SK8 7HZ Stockport Cheshire | British | 100105520001 | ||||||
| WHISTON, Timothy Andrew | Sekretär | Boothshill Farm Booths Lane WA13 0PF Lymm Cheshire | British | 69575560002 | ||||||
| WILSON, Gareth Antony | Sekretär | Wellesley Road GU11 1PZ Aldershot Royal Pavilion Hampshire United Kingdom | 162049470001 | |||||||
| PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 41 Park Square LS1 2NS Leeds | 900013300001 | |||||||
| ADAMS, Stuart Malcolm | Geschäftsführer | Wellesley Road GU11 1PZ Aldershot Royal Pavilion Hampshire United Kingdom | England | Australian | 183104980001 | |||||
| AP GWILYM, Eurfyl, Dr | Geschäftsführer | 12 Ty Draw Road CF23 5HA Cardiff | United Kingdom | British | 74774890003 | |||||
| COHEN, Gary Michael | Geschäftsführer | 178 Hopetoun Avenue, Watsons Bay Nsw 2030 Australia | Australia | Australian | 125992970001 | |||||
| CRYNE, Patrick | Geschäftsführer | The Tannery Town Lane SK14 6HQ Charlesworth Cheshire | England | British | 58894020001 | |||||
| DICKENS, Roger Joseph | Geschäftsführer | 6 Woodbourne Road Edgbaston B15 3QH Birmingham West Midlands | British | 63562150001 | ||||||
| DIGBY LORD JONES OF BIRMINGHAM | Geschäftsführer | 58 Elizabeth Court NW1 6EJ London | British | 88447680001 | ||||||
| FIUMICELLI, Andrea | Geschäftsführer | Wellesley Road GU11 1PZ Aldershot Royal Pavilion Hampshire United Kingdom | Italy | Italian | 135619020001 | |||||
| GOUGH, Tina Anne | Geschäftsführer | Wellesley Road GU11 1PZ Aldershot Royal Pavilion Hampshire | United Kingdom | British | 229756300001 | |||||
| GRAHAM, Stephen Paul | Geschäftsführer | Brackenridge Mereside Road WA16 6QR Mere Cheshire | United Kingdom | British | 97528710001 | |||||
| GRAY, David William Hart | Geschäftsführer | Wellesley Road GU11 1PZ Aldershot Royal Pavilion Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 224241390001 | |||||
| GULLAN, Alan Graham Hugh | Geschäftsführer | The Ridgeway TN10 4NJ Tonbridge 55 Kent United Kingdom | England | British | 51122700007 | |||||
| HALBARD, Christopher Neal | Geschäftsführer | 32 London Bridge Street SE1 9SG London The Shard | United Kingdom | British | 152748570001 | |||||
| HANDLEY, John Martin | Geschäftsführer | Mintz Cottage Cakebole, Chaddesley Corbett DY10 4RF Kidderminster Worcestershire | England | British | 75640920001 | |||||
| HENRY, William Patrick | Geschäftsführer | 9 Grafton Road GL50 2ET Cheltenham Gloucestershire | England | American | 119049370001 | |||||
| JAMES, Gavin Keith, Mr. | Geschäftsführer | Camelford Bradcutts Lane SL6 9AA Cookham Dean Berkshire | England | British | 44173560008 | |||||
| KERN, Rene | Geschäftsführer | 36 Butternut Hollow Road Greenwich Connecticut 06830 Usa | German | 89259110001 | ||||||
| KUMAR, Ravi | Geschäftsführer | 14 Parkham Close Daisy Hill Westhaughton BL5 2GT Bolton Lancashire | British | 101025710001 | ||||||
| LEVER, Kenneth | Geschäftsführer | Beechwood House Old Long Grove, Seer Green HP9 2QH Beaconsfield Buckinghamshire | British | 50134030002 | ||||||
| LORIA, Giovanni | Geschäftsführer | One Pancras Square Kings Cross N1C 4AG London Csc United Kingdom | England | British | 134764880002 | |||||
| MACKAY, James Gordon | Geschäftsführer | Daventry Road OX16 3JT Banbury Isoft Group Plc Oxfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 178097680001 | |||||
| MAJED, Maruf Ahmad | Geschäftsführer | One Pancras Square King's Cross N1C 4AG London Dxc United Kingdom | Singapore | American | 245085610001 | |||||
| MOORE, Christopher Edward | Geschäftsführer | Fanthill Hayway Lane Hook Norton OX15 5QJ Banbury Oxfordshire | England | British | 34428100003 | |||||
| RICHARDS, Paul | Geschäftsführer | The Barn Green Lane South Newington OX15 4JH Banbury | United Kingdom | British | 126777780001 | |||||
| SERIES, Ronald Charles | Geschäftsführer | Daventry Road OX16 3JT Banbury Isoft Oxfordshire United Kingdom | England | British | 118534550001 | |||||
| STEVENS, Adrian Charles | Geschäftsführer | Wellesley Road GU11 1PZ Aldershot Royal Pavilion Hampshire United Kingdom | England | British | 76964750002 | |||||
| THOMSON, Andrew James Edward | Geschäftsführer | Wellesley Road GU11 1PZ Aldershot Royal Pavilion Hampshire United Kingdom | England | British | 147270780001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ISOFT GROUP (UK) LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dxc Uk International Operations Limited | 06. Okt. 2016 | Wellesley Road GU11 1P2 Aldershot Royal Pavilion Hampshire United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für ISOFT GROUP (UK) LIMITED?
| Benachrichtigt am | Aufgehört am | Erklärung |
|---|---|---|
| 22. Feb. 2017 | 05. Okt. 2016 | Das Unternehmen weiß oder hat Grund zu der Annahme, dass es eine registrierungspflichtige Person in Bezug auf das Unternehmen gibt, hat diese jedoch nicht identifiziert. |
Hat ISOFT GROUP (UK) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| English law governed supplemental security agreement | Erstellt am 23. Nov. 2010 Geliefert am 30. Nov. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben First fixed charge all of its rights title and interest in respect of any security account and any amount standing to the credit of any security account see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental security agreement | Erstellt am 24. März 2010 Geliefert am 31. März 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All estates or interests in the leasehold property, all buildings, erections and fixtures and the benefit of any covenants see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security agreement | Erstellt am 30. Dez. 2009 Geliefert am 18. Jan. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All f/h and l/h property,all equipment and fixed assets,all shares,all other stocks debentures,bonds,warrants,coupons or other securities see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security agreement | Erstellt am 30. Dez. 2009 Geliefert am 13. Jan. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All f/h and l/h property,all equipment and fixed assets,all shares,all other stocks debentures,bonds,warrants,coupons or other securities see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A supplemental security agreement | Erstellt am 14. Feb. 2008 Geliefert am 19. Feb. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each borrower and each target guarantor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben L/H property k/a 300 longbarn boulevard birchwood warrington t/no CH348589. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A security agreement | Erstellt am 30. Okt. 2007 Geliefert am 14. Nov. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each borrower and each target guarantor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A security agreement | Erstellt am 30. Okt. 2007 Geliefert am 14. Nov. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each borrower and each target guarantor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Omnibus guarantee and set-off agreement | Erstellt am 24. Aug. 2006 Geliefert am 31. Aug. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Any sums or sums standing to the credit if any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 30TH january 2003 | Erstellt am 13. Apr. 2006 Geliefert am 28. Apr. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 29. Apr. 2004 Geliefert am 07. Mai 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the parent company, any chargor or any of the parent company's subsidiaries to the finance parties or any of them and such other banks or financial institutions under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security assignment | Erstellt am 02. Mai 2003 Geliefert am 14. Mai 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All right title benefit and interest under or arising out of or in respect of supply agreements between the company and its customers. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security assignment | Erstellt am 30. Apr. 2003 Geliefert am 14. Mai 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All of its right title benefit and interest, present and future, whether proprietary contractual or otherwise under or arising out of or in respect of supply agreements. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security assignment | Erstellt am 28. Apr. 2003 Geliefert am 14. Mai 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All of its right title benefit and interest, present and future, whether proprietary contractual or otherwise under or arising out of or in respect of supply agreements. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Set-off agreement | Erstellt am 30. Jan. 2003 Geliefert am 19. Feb. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The companies agree that the bank may at any time and from time to time combine or consolidate all or any of the then existing accounts of the companies with all or any of the liabilities of the companies or any of them to the bank under the ancillary facilities and/or set-off and transfer any sum or sums standing to the credit of one or more of such accounts. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security assignment | Erstellt am 07. Nov. 2002 Geliefert am 14. Nov. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All of its right title benefit and interest present and future under or arising out of or in respect of supply agreements. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 30. Juli 2002 Geliefert am 20. Aug. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All money,obligations and liabilities due or to become due from each chargor to the chargee and to the lenders (or any of them) in any currency under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Including (I) suite 306,bridgewater house,58-60 whitworth street,manchester; (ii) suite 202,bridgewater house,58-60 whitworth street,manchester; (iii) units 2.01-2.05 faraday wharf aston science park,holt street,birmingham; see form 395 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage of a life policy | Erstellt am 27. März 2000 Geliefert am 05. Apr. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All money including bonuses that has accrued or may become payale under the policy. The benefit of all options and rights given to the company in connection with the policy and all the companys rights and interest in the policy. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortagage of a life policy | Erstellt am 27. März 2000 Geliefert am 05. Apr. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All money including bonuses that has accrued or may become payale under the policy. The benefit of all options and righhts given to the company in connection with the policy and all the companys rights and interest in the policy. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 21. Juni 1999 Geliefert am 24. Juni 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat ISOFT GROUP (UK) LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0