GREER PHARMACY GROUP LIMITED

GREER PHARMACY GROUP LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameGREER PHARMACY GROUP LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03720540
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von GREER PHARMACY GROUP LIMITED?

    • Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften

    Wo befindet sich GREER PHARMACY GROUP LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    1 Thane Road West
    NG2 3AA Nottingham
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von GREER PHARMACY GROUP LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    HANDFORE LTD25. Feb. 199925. Feb. 1999

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GREER PHARMACY GROUP LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2013

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für GREER PHARMACY GROUP LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für GREER PHARMACY GROUP LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    4 SeitenDS01

    Jahresrückblick erstellt bis 25. Feb. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital27. Feb. 2014

    Kapitalaufstellung am 27. Feb. 2014

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2013

    3 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 25. Feb. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2012

    3 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 25. Feb. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2011

    9 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Christopher Giles als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Mark Francis Muller als Direktor

    3 SeitenAP01

    Jahresrückblick erstellt bis 25. Feb. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2010

    10 SeitenAA

    Ernennung von David Charles Geoffrey Foster als Direktor

    3 SeitenAP01

    Ernennung von David Charles Geoffrey Foster als Sekretär

    3 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Mark Muller als Sekretär

    2 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Christopher Aylward als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 25. Feb. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01

    Beendigung der Bestellung von Patricia Kennerley als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Christopher Aylward als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Mark Muller als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Ernennung von Christopher James Giles als Direktor

    3 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Mark Muller als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten403a

    Wer sind die Geschäftsführer von GREER PHARMACY GROUP LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    FOSTER, David Charles Geoffrey
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    D90
    Sekretär
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    D90
    British150376400001
    FOSTER, David Charles Geoffrey
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    D90
    Geschäftsführer
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    D90
    EnglandBritish52040210004
    MULLER, Mark Francis, Mr.
    1 Thane Road West
    NG2 3AA Nottingham
    D90
    Geschäftsführer
    1 Thane Road West
    NG2 3AA Nottingham
    D90
    United KingdomBritish63620010002
    ELFORD, Keith Ernest
    33 Foot Wood Crescent
    Shawclough
    OL12 6PB Rochdale
    Lancashire
    Sekretär
    33 Foot Wood Crescent
    Shawclough
    OL12 6PB Rochdale
    Lancashire
    British9146900001
    GREER, Richard David
    Sidebank House
    Holmfirth Road Greenfield
    OL3 7NL Oldham
    Lancashire
    Sekretär
    Sidebank House
    Holmfirth Road Greenfield
    OL3 7NL Oldham
    Lancashire
    British63038770002
    GREER, Richard David
    Pinfold Farm Cottage Knowl Top Lane
    Uppermill
    OL3 6LQ Oldham
    Sekretär
    Pinfold Farm Cottage Knowl Top Lane
    Uppermill
    OL3 6LQ Oldham
    British63038770001
    MULLER, Mark Francis, Mr.
    Elm Lodge
    15 Oaken Coppice
    KT21 1DL Ashtead
    Surrey
    Sekretär
    Elm Lodge
    15 Oaken Coppice
    KT21 1DL Ashtead
    Surrey
    British63620010002
    FORM 10 SECRETARIES FD LTD
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    Bevollmächtigter Sekretär
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    900014000001
    AYLWARD, Christopher David
    Buchan Cottage
    2 Cheapside
    GU21 4JG Horsell
    Woking
    Geschäftsführer
    Buchan Cottage
    2 Cheapside
    GU21 4JG Horsell
    Woking
    United KingdomBritish59741430002
    ELFORD, Keith Ernest
    33 Foot Wood Crescent
    Shawclough
    OL12 6PB Rochdale
    Lancashire
    Geschäftsführer
    33 Foot Wood Crescent
    Shawclough
    OL12 6PB Rochdale
    Lancashire
    British9146900001
    GILES, Christopher James
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    D90
    Geschäftsführer
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    D90
    EnglandBritish149729660001
    GREER, Janette
    Sidebank House
    Holmfirth Road Greenfield
    OL3 7NL Oldham
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Sidebank House
    Holmfirth Road Greenfield
    OL3 7NL Oldham
    Lancashire
    British63038660002
    GREER, Richard David
    Sidebank House
    Holmfirth Road Greenfield
    OL3 7NL Oldham
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Sidebank House
    Holmfirth Road Greenfield
    OL3 7NL Oldham
    Lancashire
    British63038770002
    KENNERLEY, Patricia Diane
    D90
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    Geschäftsführer
    D90
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    Great BritainBritish110727230002
    MULLER, Mark Francis, Mr.
    Elm Lodge
    15 Oaken Coppice
    KT21 1DL Ashtead
    Surrey
    Geschäftsführer
    Elm Lodge
    15 Oaken Coppice
    KT21 1DL Ashtead
    Surrey
    United KingdomBritish63620010002
    FORM 10 DIRECTORS FD LTD
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    900013990001

    Hat GREER PHARMACY GROUP LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 31. März 2007
    Geliefert am 07. Apr. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    50/50A queen street great harwood. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 07. Apr. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Sept. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 07. Jan. 2002
    Geliefert am 12. Jan. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a 32 peel street marsden west yorkshire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 12. Jan. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Juli 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Dez. 2001
    Geliefert am 15. Dez. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a 103 main street bingley west yorkshire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 15. Dez. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Sept. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Dez. 2001
    Geliefert am 15. Dez. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a 29 (b) park road bingley west yorkshire and 1 bradley street bingley west yorkshire (ground floor and basement). By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 15. Dez. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Sept. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 02. Okt. 2001
    Geliefert am 04. Okt. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage beacon road pharmacy 311 beacon road horton bank top wibsey bradford. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 04. Okt. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Sept. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 02. Okt. 2001
    Geliefert am 04. Okt. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage medwell jackson pharmacy 38 new line greengates bradford. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 04. Okt. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Sept. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 02. Juli 2001
    Geliefert am 05. Juli 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a 33 the cross lymm cheshire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 05. Juli 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Sept. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Mai 2001
    Geliefert am 03. Mai 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H building and shop with t/no;-WYK325102. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 03. Mai 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Sept. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Juni 2000
    Geliefert am 04. Juli 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a 350 grimshaw lane middleton junction manchester M24 2AU. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 04. Juli 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Sept. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Juni 2000
    Geliefert am 07. Juni 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H premises k/a the pharmacy at rawdon surgery rawdon leeds.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 07. Juni 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Sept. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 20. März 2000
    Geliefert am 23. März 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    70-72 galloway lane pudsey west yorkshire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 23. März 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Sept. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 31. März 1999
    Geliefert am 08. Apr. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 08. Apr. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Sept. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0