PARK VILLA LIMITED
Überblick
Unternehmensname | PARK VILLA LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 03722372 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von PARK VILLA LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
- Pflegeheime (86102) / Gesundheits- und Sozialwesen
Wo befindet sich PARK VILLA LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Connaught House 850 The Crescent CO4 9QB Colchester Essex |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Gesch äftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PARK VILLA LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2011 |
Welche sind die letzten Einreichungen für PARK VILLA LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2011 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. März 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Jonathan David Calow als Sekretär am 08. Dez. 2011 | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Care Uk Services Ltd als Sekretär am 08. Dez. 2011 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
second-filing-of-form-with-form-type | 5 Seiten | RP04 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2010 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. März 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Michael Robert Parish am 10. Aug. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 12 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 12 Seiten | MG01 | ||||||||||
legacy | 28 Seiten | MG01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2009 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Richard Jackson als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Douglas Umbers als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Christopher Robert Brown als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Dr Alison Jane Rose-Quirie als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. März 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Care Uk Services Ltd am 01. März 2010 | 2 Seiten | CH04 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Michael Robert Parish am 26. Feb. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Douglas Umbers am 26. Feb. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von PARK VILLA LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALOW, Jonathan David | Sekretär | Connaught House 850 The Crescent CO4 9QB Colchester Essex | 165501290001 | |||||||||||
BROWN, Christopher Robert | Geschäftsführer | Connaught House 850 The Crescent CO4 9QB Colchester Essex | England | British | Accountant | 138821850001 | ||||||||
HUMPHREYS, Paul Justin | Geschäftsführer | Connaught House 850 The Crescent CO4 9QB Colchester Essex | United Kingdom | British | Director | 33223550003 | ||||||||
PARISH, Michael Robert | Geschäftsführer | Connaught House 850 The Crescent CO4 9QB Colchester Essex | England | British | Director | 78828750003 | ||||||||
ROSE-QUIRIE, Alison Jane, Dr | Geschäftsführer | Connaught House 850 The Crescent CO4 9QB Colchester Essex | England | British | Company Director | 190407640001 | ||||||||
BOOTES, Sarah Louise | Sekretär | 254 Park Lane SK11 8AA Macclesfield Cheshire | British | 59475010003 | ||||||||||
HUMPHREYS, Paul Justin | Sekretär | Hall Barn Creeting Hall Farm Creeting Saint Peter IP6 8QZ Ipswich Suffolk | British | Director | 33223550003 | |||||||||
CARE UK SERVICES LTD | Sekretär | 850 The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Connaught House Essex United Kingdom |
| 125241530002 | ||||||||||
TEMPLE SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 788-790 Finchley Road NW11 7TJ London | 900001120001 | |||||||||||
HIBELL, Joyce Muriel | Geschäftsführer | 46 Ryles Park Road SK11 8AL Macclesfield Cheshire | England | British | Director Of Operations | 63127380002 | ||||||||
HIBELL, Wayne | Geschäftsführer | 46 Ryles Park Road SK11 8AL Macclesfield Cheshire | United Kingdom | British | Director | 59474700003 | ||||||||
JACKSON, Richard Nicholas | Geschäftsführer | Connaught House 850 The Crescent CO4 9QB Colchester Essex | United Kingdom | British | Company Director | 123356300001 | ||||||||
PRESTON, John | Geschäftsführer | Wishing Well Cottage Maldon Road Heckfordbridge CO3 0SP Colchester Essex | British | Company Director | 123356340001 | |||||||||
UMBERS, Douglas | Geschäftsführer | Connaught House 850 The Crescent CO4 9QB Colchester Essex | United Kingdom | British | Company Director | 90541690001 | ||||||||
COMPANY DIRECTORS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 788-790 Finchley Road NW11 7TJ London | 900001110001 |
Hat PARK VILLA LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Erstellt am 21. Juli 2010 Geliefert am 26. Juli 2010 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
The supplemental legal charge | Erstellt am 21. Juli 2010 Geliefert am 26. Juli 2010 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any charging company or any obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Park villa macclesfield propriertor-park villa limited t/no:CH181466TOGETHER with all buildings and fixtures (including trade fixtures) on the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 16. März 2007 Geliefert am 04. Apr. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 22. Sept. 2006 Geliefert am 29. Sept. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 04. Feb. 2000 Geliefert am 18. Feb. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Park villa park lane macclesfield cheshire t/no: CH181466. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 28. Jan. 2000 Geliefert am 07. Feb. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0