CORUS FINANCE LIMITED
Überblick
Unternehmensname | CORUS FINANCE LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 03731221 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CORUS FINANCE LIMITED?
- Sonstige Nebentätigkeiten im Finanz- und Versicherungswesen n.n.a. (66190) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Wo befindet sich CORUS FINANCE LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 30 Millbank London SW1P 4WY |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CORUS FINANCE LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
CORUS FINANCE PLC | 02. Nov. 1999 | 02. Nov. 1999 |
BSKH FINANCE PLC | 16. Juli 1999 | 16. Juli 1999 |
BSKH LIMITED | 01. Juni 1999 | 01. Juni 1999 |
TRUSHELFCO (NO.2493) LIMITED | 11. März 1999 | 11. März 1999 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CORUS FINANCE LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2012 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CORUS FINANCE LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Allison Leigh Scandrett als Direktor am 08. Aug. 2012 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Donald Kenneth Grierson als Geschäftsführer am 08. Aug. 2012 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 10. Aug. 2012
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2012 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Syed Anwar Hasan als Geschäftsführer am 02. Juli 2012 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 11. März 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2011 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von British Steel Directors (Nominees) Limited als Direktor | 2 Seiten | AP02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Paul Strickland als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 11. März 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2010 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 16 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 11. März 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2009 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2008 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 225 |
Wer sind die Geschäftsführer von CORUS FINANCE LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCANDRETT, Allison Leigh | Sekretär | Warren Road Colliers Wood SW19 2HY London 67 | British | 1037770001 | ||||||||||
SCANDRETT, Allison Leigh | Geschäftsführer | 30 Millbank London SW1P 4WY | England | British | Company Secretary | 1037770001 | ||||||||
BRITISH STEEL DIRECTORS (NOMINEES) LIMITED | Geschäftsführer | Millbank SW1P 4WY London 30 England |
| 57383920004 | ||||||||||
REEVES, Richard John | Sekretär | 221 Vicarage Hill SS7 1PG Benfleet Essex | British | Company Secretary | 34078540001 | |||||||||
TRUSEC LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 35 Basinghall Street EC2V 5DB London | 900007200001 | |||||||||||
BURKE, Rosemary Helen | Geschäftsführer | 10a Eccleston Square SW1V 1NP London | United Kingdom | British | Director | 91233080001 | ||||||||
GRIERSON, Donald Kenneth | Geschäftsführer | The Abbey Park Lane St Briavels GL15 6QX Lydney | United Kingdom | British | Accountant | 62124790002 | ||||||||
GRIERSON, Donald Kenneth | Geschäftsführer | The Abbey Park Lane St Briavels GL15 6QX Lydney | United Kingdom | British | Accountant | 62124790002 | ||||||||
HASAN, Syed Anwar | Geschäftsführer | 6 Richmond Bridge Mansions Willoughby Road TW1 2QJ Twickenham Middlesex | England | Indian | Managing Director | 64485620001 | ||||||||
KENNY, Martina Marie | Geschäftsführer | 52 Kensington Hall Gardens Beaumont Avenue W14 9LT London | Irish | Solicitor | 66353090001 | |||||||||
LLOYD, David Michael | Geschäftsführer | Willow House Eaton Park Road KT11 2JH Cobham Surrey | British | Executive Director Finance | 64431570006 | |||||||||
RENNOCKS, John Leonard | Geschäftsführer | Crown Acre Queens Drive Oxshott KT22 0PB Leatherhead Surrey | United Kingdom | British | Executive Director | 34515140014 | ||||||||
ROWE, Drusilla Charlotte Jane | Geschäftsführer | Flat E 13 Saint Georges Drive SW1V 4DJ London | British | Solicitor | 77049790002 | |||||||||
STERN, Robert Charles | Geschäftsführer | 16 Porchester Terrace W2 3TL London | England | British | Solicitor | 109330920001 | ||||||||
STRICKLAND, Paul Rodger | Geschäftsführer | 29 Lewes Road RH17 7SP Haywards Heath West Sussex | England | British | Accountant | 63469710004 | ||||||||
ZUERCHER, Eleanor Jane | Geschäftsführer | 14 St Marys Court Tingewick MK18 4RE Buckingham Buckinghamshire | British | Company Secretary | 61053330001 |
Hat CORUS FINANCE LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Erstellt am 31. Juli 2003 Geliefert am 11. Aug. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the security agent or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By first floating charge the undertaking property and assets from time to time both present and future. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Second supplemental trust deed dated 15TH september 1999 supplemental to the trust deed dated 19TH july 1991 (the original trust deed) as amended by a first supplemental trust deed dated 16TH january 1997 and actually effective and | Erstellt am 23. Sept. 1999 Geliefert am 30. Sept. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The payment to the chargee ("the trustee") of the principal amount of the £150,000,000 11 1/2 per cent. Debenture stock 2016 of the company constituted bt the trust deed, the premium (if any) and interest thereon and all other moneys expressed to be secured under the trust deed including, inter alia, any costs incurred by "the trustee" in insuring any part of the company's premises or other costs in respect of which "the trustee" or any receiver is indemnified under the terms of the trust deed | |
Kurze Angaben By way of floating charge by way of specific charge the capital redemption fund which will arise from the payments to be made by the company (subject as provided in the trust deed) on 20TH july in each of the years from and including 2007 to and including 2016 t or to the order of the trustees to such account with such london clearing bank as the trustee may specify of any amount equal to 5 per cent. Of the original nominal amount of the stock to be applied by the company in the redemption of the stock ("the capital redemption fund"). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0