HARMONY PUB COMPANY TRADING LIMITED

HARMONY PUB COMPANY TRADING LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameHARMONY PUB COMPANY TRADING LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03732095
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von HARMONY PUB COMPANY TRADING LIMITED?

    • Einzelhandel mit Getränken in spezialisierten Geschäften (47250) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen
    • Gaststätten und Bars (56302) / Gastgewerbe
    • Vermietung und Verpachtung von Immobilien von Wohnungsbaugesellschaften (68201) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich HARMONY PUB COMPANY TRADING LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von HARMONY PUB COMPANY TRADING LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    HERITAGE PUB COMPANY TRADING LIMITED15. Apr. 200315. Apr. 2003
    ATLASWAY 1 LTD12. März 199912. März 1999

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HARMONY PUB COMPANY TRADING LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis01. Juni 2013

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für HARMONY PUB COMPANY TRADING LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für HARMONY PUB COMPANY TRADING LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    9 Seiten4.71

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 18. Mai 2015

    8 Seiten4.68

    Beendigung der Bestellung von Glenn Pearson als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Andrew Clifford als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Kevin Georgel als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * 150 Aldersgate Street London EC1A 4EJ* am 05. Juni 2014

    2 SeitenAD01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    2 Seiten600

    Insolvenzbeschluss

    Resolution insolvency:business of liquidator
    1 SeitenLIQ MISC RES

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren

    LRESSP

    Erfüllung der Belastung 037320950009 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 037320950010 vollständig

    1 SeitenMR04

    Jahresrückblick erstellt bis 12. März 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital12. März 2014

    Kapitalaufstellung am 12. März 2014

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Beendigung der Bestellung von Jonathan Paveley als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 01. Juni 2013

    13 SeitenAA

    Gesellschaftsvertrag und Satzung

    10 SeitenMEM/ARTS

    Beschlüsse

    Resolutions
    3 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Ermächtigung zum Erwerb einer bestimmten Anzahl von Aktien

    RES09
    incorporation

    Beschluss zur Satzung und/oder Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    Eintragung der Belastung 037320950010

    53 SeitenMR01

    Eintragung der Belastung 037320950009

    87 SeitenMR01

    Jahresrückblick erstellt bis 12. März 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    8 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 26. Mai 2012

    14 SeitenAA

    legacy

    6 SeitenMG02

    legacy

    5 SeitenMG02

    Änderung der Details des Direktors für Glenn Pearson am 28. Sept. 2012

    2 SeitenCH01

    Wer sind die Geschäftsführer von HARMONY PUB COMPANY TRADING LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    A G SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Sekretär
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    90084920001
    GROSS, Milton
    86 Filey Avenue
    N16 6JJ London
    Sekretär
    86 Filey Avenue
    N16 6JJ London
    Usa2986750004
    INGHAM, Michael Harry Peter
    3 Lauriston Road
    Wimbledon
    SW19 4TJ London
    Sekretär
    3 Lauriston Road
    Wimbledon
    SW19 4TJ London
    British2739650001
    NIEDERMAN, Rivka
    Jessam Avenue
    E5 9DU London
    30
    Sekretär
    Jessam Avenue
    E5 9DU London
    30
    British113503670001
    FORM 10 SECRETARIES FD LTD
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    Bevollmächtigter Sekretär
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    900014000001
    BROWN, Aaron Maxwell
    11 Carlyle Close
    N2 0QU London
    Geschäftsführer
    11 Carlyle Close
    N2 0QU London
    American98928830001
    CLIFFORD, Andrew Francis James
    Steam Mill Business Centre
    Steam Mill Street
    CH3 5AN Chester
    Suite H3
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Steam Mill Business Centre
    Steam Mill Street
    CH3 5AN Chester
    Suite H3
    United Kingdom
    EnglandBritish119327230001
    D'ARCY, Lynne
    5 Winwick Park Avenue
    WA2 8XB Warrington
    Cheshire
    Geschäftsführer
    5 Winwick Park Avenue
    WA2 8XB Warrington
    Cheshire
    United KingdomBritish106840540001
    FINNEY, Francis John
    Summers End
    8 Weaverlake
    DE13 8AD Yoxall
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Summers End
    8 Weaverlake
    DE13 8AD Yoxall
    Staffordshire
    EnglandBritish89286280002
    GEORGEL, Kevin Roger
    Steam Mill Street
    CH3 5AN Chester
    Suite H3 Steam Mill Business Centre
    Geschäftsführer
    Steam Mill Street
    CH3 5AN Chester
    Suite H3 Steam Mill Business Centre
    United KingdomBritish153480970001
    GROSS, Milton
    86 Filey Avenue
    N16 6JJ London
    Geschäftsführer
    86 Filey Avenue
    N16 6JJ London
    Usa2986750004
    HARRISON, David John
    Main Street
    Winster
    DE4 2DH Matlock
    The Archway
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    Main Street
    Winster
    DE4 2DH Matlock
    The Archway
    Derbyshire
    United KingdomBritish62175190001
    LANDESBERG, Alan
    Allingham Court
    44 The Bishops Avenue Hampstead
    N2 OBA London
    Flat 3,
    Geschäftsführer
    Allingham Court
    44 The Bishops Avenue Hampstead
    N2 OBA London
    Flat 3,
    EnglandBritish142883260001
    LANDESBERG, Gary Mitchell
    122 Wigmore Street
    W1U 3RX London
    Geschäftsführer
    122 Wigmore Street
    W1U 3RX London
    United KingdomBritish54137480002
    O'NEILL, John
    Westbourne
    Gorse Bank Lane, Baslow
    DE45 1SG Bakewell
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    Westbourne
    Gorse Bank Lane, Baslow
    DE45 1SG Bakewell
    Derbyshire
    British89254470001
    PAVELEY, Jonathan David, Dr
    Steam Mill Street
    CH3 5AN Chester
    Suite H3 Steam Mill Business Centre
    Geschäftsführer
    Steam Mill Street
    CH3 5AN Chester
    Suite H3 Steam Mill Business Centre
    United KingdomBritish100582600002
    PEARSON, Glenn
    Steam Mill Business Centre
    Steam Mill Street
    CH3 5AN Chester
    Suite H3
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Steam Mill Business Centre
    Steam Mill Street
    CH3 5AN Chester
    Suite H3
    United Kingdom
    United KingdomBritish123243570001
    PERCY, Andrew Graeme
    5 Carlton Avenue
    SK9 4EP Wilmslow
    Cheshire
    Geschäftsführer
    5 Carlton Avenue
    SK9 4EP Wilmslow
    Cheshire
    British53017070002
    ROSENBERG, David
    Green Verges
    Priory Drive
    HA7 3HL Stanmore
    Middlesex
    Geschäftsführer
    Green Verges
    Priory Drive
    HA7 3HL Stanmore
    Middlesex
    EnglandBritish2541410004
    ROSENBERG, Elliot Simon
    Brooklands 33 Linksway
    HA6 2XA Northwood
    Middlesex
    Geschäftsführer
    Brooklands 33 Linksway
    HA6 2XA Northwood
    Middlesex
    EnglandBritish2541420006
    SCHREIBER, David
    143 Upper Clapton Road
    E5 9DB London
    Geschäftsführer
    143 Upper Clapton Road
    E5 9DB London
    EnglandBritish75594970001
    SCHREIBER, Jacob
    10 Gilda Crescent
    N16 6JP London
    Geschäftsführer
    10 Gilda Crescent
    N16 6JP London
    United KingdomBritish67574090001
    SMALLEY, Timothy John
    Chivers Road
    CM15 0LG Stondon Massey
    Stondon Place
    Essex
    Geschäftsführer
    Chivers Road
    CM15 0LG Stondon Massey
    Stondon Place
    Essex
    United KingdomBritish102593650002
    WILSON, Hugh Wingate
    The Home Farm
    Fenton Road Stubton
    NG23 5DB Newark
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    The Home Farm
    Fenton Road Stubton
    NG23 5DB Newark
    Nottinghamshire
    British89126810001
    FORM 10 DIRECTORS FD LTD
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    900013990001

    Hat HARMONY PUB COMPANY TRADING LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 27. Juni 2013
    Geliefert am 12. Juli 2013
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Admiral Taverns Bidco Limited
    Transaktionen
    • 12. Juli 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 15. Mai 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 27. Juni 2013
    Geliefert am 09. Juli 2013
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • U.S. Bank Trustees Limited (As Security Agent and Trustee for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 09. Juli 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 16. Mai 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 17. Nov. 2009
    Geliefert am 02. Dez. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC in Its Capacity as Security Trustee
    Transaktionen
    • 02. Dez. 2009Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 27. Dez. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 17. Nov. 2009
    Geliefert am 02. Dez. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of first legal mortgage the original property: and all estates or interests in f/h, l/h or commonhold property and which is owned by the chargor as at the date of the debenture, and in each case, all premises and fixtures on such property for the time being. By way of fixed charge all other estates or interests in f/h, l/h or commonhold property: the proceeds of sale of its secured property and all licences to enter on or use any secured property see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Admiral Taverns Bidco Limited
    Transaktionen
    • 02. Dez. 2009Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 27. Dez. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 30. Jan. 2009
    Geliefert am 07. Feb. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 07. Feb. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Dez. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 24. Juli 2007
    Geliefert am 04. Aug. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Irish Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 04. Aug. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Dez. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 24. Juli 2007
    Geliefert am 02. Aug. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 02. Aug. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Dez. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 08. Aug. 2005
    Geliefert am 13. Aug. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Irish Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 13. Aug. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Sept. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment of keyman
    Erstellt am 24. Nov. 2003
    Geliefert am 25. Nov. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The policies, all sums assured by them and all bonuses and benefits which may arise under them and the company's whole right title and interest in the policy no's 0102078318, 0102078318 and 0102077781. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 25. Nov. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Juli 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 15. Apr. 2003
    Geliefert am 19. Apr. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 19. Apr. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Juli 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat HARMONY PUB COMPANY TRADING LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    19. Mai 2014Beginn der Liquidation
    15. Juni 2016Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Colin Peter Dempster
    Ten George Street
    EH2 2DZ Edinburgh
    Praktiker
    Ten George Street
    EH2 2DZ Edinburgh
    Derek Hyslop
    10 George Street
    EH2 2DZ Edinburgh
    Praktiker
    10 George Street
    EH2 2DZ Edinburgh

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0