MOTORHOUSE 2000 LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | MOTORHOUSE 2000 LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03732320 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von MOTORHOUSE 2000 LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich MOTORHOUSE 2000 LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Stanley House 27 Wellington Road Bilston WV14 6AH Wolverhampton West Midlands |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von MOTORHOUSE 2000 LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| PIPEDATA LIMITED | 12. März 1999 | 12. März 1999 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MOTORHOUSE 2000 LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für MOTORHOUSE 2000 LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 12. März 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 12. März 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 12. März 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Ms Thelma Anne Murrall am 18. Nov. 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 12. März 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 12. März 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für ein mittelständisches Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. Dez. 2013 bis 30. Dez. 2013 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 12. März 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 21 Seiten | AA | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 9 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 3 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 13 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 4 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * Motorhouse Watling Street Cannock Staffordshire WS11 1SL United Kingdom* am 25. Juni 2013 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 12. März 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein mittelständisches Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von MOTORHOUSE 2000 LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOWEN, Christopher Neville | Geschäftsführer | 27 Wellington Road Bilston WV14 6AH Wolverhampton Stanley House West Midlands England | South Africa | British | 113116280002 | |||||
| MURRALL, Thelma Anne | Geschäftsführer | 27 Wellington Road Bilston WV14 6AH Wolverhampton Stanley House West Midlands England | England | British | 9389870002 | |||||
| ALLEN, Ian | Sekretär | 11 Moor Hall Drive Four Oaks B75 6LP Sutton Coldfield West Midlands | British | 23075570001 | ||||||
| SMITH, Paul Lester | Sekretär | 81 Lower Street Tettenhall WV6 9LN Wolverhampton West Midlands | British | 36016370001 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| ALLEN, Ian | Geschäftsführer | 11 Moor Hall Drive Four Oaks B75 6LP Sutton Coldfield West Midlands | England | British | 23075570001 | |||||
| BUTTERLEY, Stephen Jon | Geschäftsführer | Newland Way Stapeley CW5 7JH Nantwich 17 Cheshire | British | 125761930001 | ||||||
| HASSALL, Stuart Joseph | Geschäftsführer | 7 Bank Top Cottages Birchin Lane CW5 6LB Nantwich Cheshire | British | 67406110001 | ||||||
| MURRALL, Alan Robert | Geschäftsführer | Lock Cottage Queens Road Calf Heath WV10 7DT Wolverhampton West Midlands | British | 5305500001 | ||||||
| SMITH, Paul Lester | Geschäftsführer | 81 Lower Street Tettenhall WV6 9LN Wolverhampton West Midlands | England | British | 36016370001 | |||||
| WALKER, Carl | Geschäftsführer | 52 Chemet Way WS11 5RK Cannock Staffordshire | British | 118190310001 | ||||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei MOTORHOUSE 2000 LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorhouse (Investment Holdings) Limited | 06. Apr. 2016 | Wellington Road WV14 6AH Bilston Stanley House England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat MOTORHOUSE 2000 LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 08. Dez. 2010 Geliefert am 17. Dez. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 26. Jan. 2010 Geliefert am 29. Jan. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of deposit | Erstellt am 21. Dez. 2006 Geliefert am 04. Jan. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All interest from time to time standing to the credit of an interest bearing account. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of assignment | Erstellt am 20. Juli 2006 Geliefert am 25. Juli 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Full title guarantee its entire right, title and interest in and to the deposit and all rights and benefits accruing to or arising in connection with the deposit. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 21. Dez. 2005 Geliefert am 23. Dez. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The amount from time to time standing to the credit of an account. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignment of keyman life policy | Erstellt am 30. Sept. 2003 Geliefert am 09. Okt. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The policy, all sums assured by it and all bonuses and benefits which mat arise under it and the whole right title and interest present and future in the policy.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignment of keyman life policy | Erstellt am 01. Aug. 2003 Geliefert am 06. Aug. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The life policy of ian allen policy no: X75330613 for the sum of £135,000 with standard life and all sums assured by it and all bonuses and benefits which may arise under it and the whole right title and interest present and future. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 31. Juli 2003 Geliefert am 02. Aug. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 15. Jan. 2001 Geliefert am 25. Jan. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 15. Jan. 2001 Geliefert am 23. Jan. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £1,500,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over all property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital plant machinery vehicles furniture and office equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 15. Jan. 2001 Geliefert am 23. Jan. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £1,500,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over all property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital plant machinery vehicles furniture and office equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 08. Mai 2000 Geliefert am 18. Mai 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 01. Dez. 1999 Geliefert am 08. Dez. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0