MANAGEMENT FACILITIES (NORTHERN) LIMITED
Überblick
Unternehmensname | MANAGEMENT FACILITIES (NORTHERN) LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 03736467 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von MANAGEMENT FACILITIES (NORTHERN) LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich MANAGEMENT FACILITIES (NORTHERN) LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 4th Floor 24 Old Bond Street Mayfair W1S 4AW London United Kingdom |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MANAGEMENT FACILITIES (NORTHERN) LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Apr. 2021 |
Welche sind die letzten Einreichungen für MANAGEMENT FACILITIES (NORTHERN) LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt | 1 Seiten | DISS40 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 19. März 2023 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||
Change of details for Independent Group (Uk) Limited as a person with significant control on 06. Jan. 2023 | 2 Seiten | PSC05 | ||
Beendigung der Bestellung von Rjp Secretaries Limited als Sekretär am 25. Jan. 2023 | 1 Seiten | TM02 | ||
Ernennung von Cossey Cosec Services Limited als Sekretär am 25. Jan. 2023 | 2 Seiten | AP04 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Ground Floor, Egerton House 68 Baker Street Weybridge Surrey KT13 8AL United Kingdom zum 4th Floor 24 Old Bond Street Mayfair London W1S 4AW am 06. Jan. 2023 | 1 Seiten | AD01 | ||
Cessation of Chem-Dry U.K. Limited as a person with significant control on 31. Okt. 2022 | 1 Seiten | PSC07 | ||
Notification of Independent Group (Uk) Limited as a person with significant control on 31. Okt. 2022 | 2 Seiten | PSC02 | ||
Change of details for Gold Round Limited as a person with significant control on 25. Juli 2022 | 2 Seiten | PSC05 | ||
Änderung der Details des Direktors für Gold Round Limited am 25. Juli 2022 | 1 Seiten | CH02 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Apr. 2021 | 6 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 19. März 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Stuart Pace am 21. Juli 2021 | 2 Seiten | CH01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Apr. 2020 | 7 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 19. März 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Change of details for Gold Round Limited as a person with significant control on 18. Apr. 2016 | 2 Seiten | PSC05 | ||
Beendigung der Bestellung von Alan Albert Horton als Geschäftsführer am 30. Juni 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Stuart Pace am 29. Juni 2020 | 2 Seiten | CH01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 19. März 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Apr. 2019 | 7 Seiten | AA | ||
Change of details for Chem-Dry U.K. Limited as a person with significant control on 09. Aug. 2019 | 2 Seiten | PSC05 | ||
Änderung der Details des Sekretärs für Rjp Secretaries Limited am 09. Aug. 2019 | 1 Seiten | CH04 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von MANAGEMENT FACILITIES (NORTHERN) LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSSEY COSEC SERVICES LIMITED | Sekretär | 24 Old Bond Street Mayfair W1S 4AW London 4th Floor United Kingdom |
| 302964180001 | ||||||||||
PACE, Stuart | Geschäftsführer | 24 Old Bond Street Mayfair W1S 4AW London 4th Floor United Kingdom | England | British | Director | 207506130003 | ||||||||
GOLD ROUND LIMITED | Geschäftsführer | 24 Old Bond Street Mayfair W1S 4AW London 4th Floor United Kingdom |
| 149588400001 | ||||||||||
LUTKIN, Wendy Naomi | Sekretär | 4 Parkfield Avenue HU14 3AL North Ferriby East Yorkshire | British | Director | 73437740002 | |||||||||
MAUGHAN, Anna | Sekretär | 404 Chester Road Boldmere B73 5BS Sutton Coldfield | British | 53071850001 | ||||||||||
TAYLOR, Mark Andrew | Sekretär | Springhill 45 Woodland View Barnetby Le Wold DN38 6FE Brigg Lincolnshire | British | 95264700001 | ||||||||||
THOMAS, Caroline Emma Roberts | Sekretär | 5 Broomsleigh Street NW6 1QQ London | British | 154322040001 | ||||||||||
ENERGIZE SECRETARY LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 31 Buxton Road SK2 6LS Stockport Cheshire | 900012910001 | |||||||||||
RJP SECRETARIES LIMITED | Sekretär | 68 Baker Street KT13 8AL Weybridge Ground Floor, Egerton House Surrey United Kingdom |
| 61999120002 | ||||||||||
BELK, Andrew John | Geschäftsführer | Pen Plannau Moelfre SY10 7QL Llansilin North Wales | British | Director | 65603000003 | |||||||||
BELL, Jonathan | Geschäftsführer | Swinemoor Lane HU17 0LS Beverley Colonial House East Yorkshire United Kingdom | England | British | Company Director | 123082590001 | ||||||||
DICKINSON, Louise | Geschäftsführer | Caxton Road Fulwood PR2 9NZ Preston 6 Fulwood Park Lancashire | England | British | Company Director | 139480580001 | ||||||||
HORTON, Alan Albert | Geschäftsführer | 68 Baker Street KT13 8AL Weybridge Ground Floor, Egerton House Surrey United Kingdom | England | British | Company Director | 182208240001 | ||||||||
LEE, Peter Francis | Geschäftsführer | Caxton Road Fulwood PR2 9NZ Preston 6 Fulwood Park Lancashire | United Kingdom | British | Finance Director | 207608120001 | ||||||||
LEES, Stuart | Geschäftsführer | Caxton Road Fulwood PR2 9NZ Preston 6 Fulwood Park Lancashire | England | British | Company Director | 70032700001 | ||||||||
LLOYD-JONES, Andrew Mark | Geschäftsführer | Caxton Road Fulwood PR2 9NZ Preston 6 Fulwood Park Lancashire | England | British | Director | 149155620001 | ||||||||
LUTKIN, Wendy Naomi | Geschäftsführer | 4 Parkfield Avenue HU14 3AL North Ferriby East Yorkshire | England | British | Director | 73437740002 | ||||||||
ROCKETT, Matthew Ian | Geschäftsführer | Trent Walk Welton Grange HU15 1GF Brough 7 East Yorkshire | British | British | Accountant | 146169560001 | ||||||||
SIMPSON DENT, Jonathan | Geschäftsführer | Briar Walk Putney SW15 6UD London 19 | United Kingdom | British | Director | 110396210002 | ||||||||
SMITH, Andrew John | Geschäftsführer | High Street KT7 0SR Thames Ditton 2 A C Court Surrey England | England | British | Director | 207506140001 | ||||||||
SMITH, Andrew John | Geschäftsführer | Swinemoor Lane HU17 0LS Beverley Colonial House East Yorkshire | Uk | British | Director | 149018750001 | ||||||||
TAYLOR, Eloisa Bianca Maria | Geschäftsführer | 45 Woodland View Spring Hill DN38 6FE Barnetby Le Wold South Humberside | British | Director | 73437650002 | |||||||||
TAYLOR, Ian | Geschäftsführer | 4 Parkfield Avenue HU14 3AL North Ferriby East Yorkshirede | England | British | Director | 6673550003 | ||||||||
TAYLOR, Mark Andrew | Geschäftsführer | Westlands Queensgate HU17 8NE Beverley | United Kingdom | British | Director | 95264700003 | ||||||||
TAYLOR, Mark Andrew | Geschäftsführer | Springhill 45 Woodland View Barnetby Le Wold DN38 6FE Brigg Lincolnshire | British | Director | 95264700001 | |||||||||
ENERGIZE DIRECTOR LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 31 Buxton Road SK2 6LS Stockport Cheshire | 900014010001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei MANAGEMENT FACILITIES (NORTHERN) LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Independent Group (Uk) Limited | 31. Okt. 2022 | 24 Old Bond Street Mayfair W1S 4AW London 4th Floor United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Gold Round Limited | 18. Apr. 2016 | 24 Old Bond Street Mayfair W1S 4AW London 4th Floor United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Chem-Dry U.K. Limited | 06. Apr. 2016 | 68 Baker Street KT13 8AL Weybridge Ground Floor, Egerton House Surrey United Kingdom | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Gold Round Limited | 06. Apr. 2016 | 24 Old Bond Street Mayfair W1S 4AW London 5th Floor United Kingdom | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat MANAGEMENT FACILITIES (NORTHERN) LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Erstellt am 01. Sept. 2016 Geliefert am 13. Sept. 2016 | Ausstehend | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 03. Juni 2016 Geliefert am 16. Juni 2016 | Ausstehend | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A composite guarantee and debenture | Erstellt am 31. Jan. 2011 Geliefert am 08. Feb. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A deed of accession to a composite guarantee and debenture dated 26 june 2009 | Erstellt am 31. Jan. 2011 Geliefert am 08. Feb. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 31. Jan. 2011 Geliefert am 03. Feb. 2011 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A composite guarantee and debenture | Erstellt am 31. Juli 2010 Geliefert am 07. Aug. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite guarantee and debenture | Erstellt am 30. Juli 2010 Geliefert am 10. Aug. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the chargor to the beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 30. Juli 2010 Geliefert am 05. Aug. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite guarantee and debenture | Erstellt am 24. Sept. 2009 Geliefert am 14. Okt. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from ingleby (1823) limited to the noteholders on any account whatsoever and all other monies due or to become due from any charging company under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the property and assets, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixed plant & machinery. See image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 24. Sept. 2009 Geliefert am 03. Okt. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite guarantee and debentures | Erstellt am 24. Sept. 2009 Geliefert am 02. Okt. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the note issuer to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0