BIS DATACENTRES LTD
Überblick
| Unternehmensname | BIS DATACENTRES LTD |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03740487 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von BIS DATACENTRES LTD?
- Datenverarbeitung, Hosting und damit verbundene Aktivitäten (63110) / Information und Kommunikation
Wo befindet sich BIS DATACENTRES LTD?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Commodity Quay St Katharine Docks E1W 1AZ London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von BIS DATACENTRES LTD?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| ABOVENET UK LIMITED | 22. März 1999 | 22. März 1999 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BIS DATACENTRES LTD?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2022 |
Welche sind die letzten Einreichungen für BIS DATACENTRES LTD?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2022 | 6 Seiten | AA | ||
Beendigung der Bestellung von Stylianos Karaolis als Geschäftsführer am 11. Mai 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||
Ernennung von Mr David Colin Manuel als Direktor am 11. Mai 2022 | 2 Seiten | AP01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 04. März 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Beendigung der Bestellung von Steven Keith Mitchell als Geschäftsführer am 23. Dez. 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||
Ernennung von Mr Stylianos Karaolis als Direktor am 15. Dez. 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2021 | 6 Seiten | AA | ||
Beendigung der Bestellung von David Michael Howson als Geschäftsführer am 12. Mai 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||
Ernennung von Mr Simon Crawley-Trice als Direktor am 12. Mai 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 04. März 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. März 2020 | 6 Seiten | AA | ||
legacy | 59 Seiten | PARENT_ACC | ||
legacy | 2 Seiten | AGREEMENT2 | ||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE2 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 04. März 2020 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
Ernennung von Mr Matthew Redding als Sekretär am 28. Okt. 2019 | 3 Seiten | AP03 | ||
Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. März 2019 | 7 Seiten | AA | ||
legacy | 48 Seiten | PARENT_ACC | ||
legacy | 2 Seiten | AGREEMENT2 | ||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE2 | ||
Erfüllung der Belastung 037404870007 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von BIS DATACENTRES LTD?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REDDING, Matthew | Sekretär | St Katharine Docks E1W 1AZ London Commodity Quay United Kingdom | 264431440001 | |||||||
| CRAWLEY-TRICE, Simon | Geschäftsführer | St Katharine Docks E1W 1AZ London Commodity Quay | United Kingdom | British | 283625300001 | |||||
| MANUEL, David Colin | Geschäftsführer | St Katharine Docks E1W 1AZ London Commodity Quay | England | British | 78406280002 | |||||
| BOOTH, Andrew | Sekretär | St Katharine Docks E1W 1AZ London Commodity Quay United Kingdom | 177300960001 | |||||||
| DE LISSER, Ferdinand George | Sekretär | 5 The Drive Wimbledon SW20 8TG London | British | 93810330001 | ||||||
| LINTON, Georgina Charmaine | Sekretär | Flat 3, 29 Saint Gabriels Road NW2 4DT London | British | 74271030001 | ||||||
| MCSWEEN, Angus | Sekretär | 5 Ellergreen Road Bearsden G61 2RU Glasgow Scotland | British | 50499250001 | ||||||
| WADLER, Arnold L | Sekretär | 85 School Road East 07746 Marlboro New Jersey Usa | Us | 52556910001 | ||||||
| WEDGE, Andrew Neil | Sekretär | 106 Bushy Park Road TW11 9DL Teddington Middlesex | British | 83050670001 | ||||||
| ABOGADO NOMINEES LIMITED | Sekretär | 100 New Bridge Street EC4V 6JA London | 73539350001 | |||||||
| MD SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | C/0 Mcgrigors Llp 141 Bothwell Street G2 7EQ Glasgow | 900005110001 | |||||||
| BENEDETTO, Gerard | Geschäftsführer | 36 Old Trolly Road 06877 Ridgefield Ct Usa | American | 74339480001 | ||||||
| CHAPMAN, Kirsty | Geschäftsführer | St Katharine Docks E1W 1AZ London Commodity Quay | England | British | 237752510001 | |||||
| DE LISSER, Ferdinand George | Geschäftsführer | The Drive SW20 8TG London 5 England | England | British | 93810330001 | |||||
| DOBBIE, William | Geschäftsführer | 32 Saxe Coburg Place EH3 5BP Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 107339410001 | |||||
| DOWBIGGIN, John | Geschäftsführer | 47 Goodhart Place Limehouse E14 8EQ London | British | 79349610002 | ||||||
| DOWBIGGIN, John Ross | Geschäftsführer | Coulsdon Road Old Coulsdon CR5 2LD Croydon 47 Surrey | United Kingdom | British | 129698260001 | |||||
| GRANT, Anthony Bryce | Geschäftsführer | King William Street EC4R 9AS London 33 England | England | British | 80908880001 | |||||
| HOWE, Adrian Trevor | Geschäftsführer | St Katharine Docks E1W 1AZ London Commodity Quay | England | British | 130448940002 | |||||
| HOWSON, David Michael | Geschäftsführer | St Katharine Docks E1W 1AZ London Commodity Quay | England | British | 224111570002 | |||||
| ING, Michael Andrew | Geschäftsführer | St Katharine Docks E1W 1AZ London Commodity Quay | United Kingdom | British | 199320020001 | |||||
| JOHNS, Peter Michael | Geschäftsführer | 4 Court Royal Mews SO15 2TU Southampton Hampshire | British | 55651330002 | ||||||
| KARAOLIS, Stylianos | Geschäftsführer | St Katharine Docks E1W 1AZ London Commodity Quay | United Kingdom | British | 290867510001 | |||||
| LAY, Randall Robert | Geschäftsführer | 360 Hamilton Avenue White Plains New York 10601 Usa | American | 79348250001 | ||||||
| MCSWEEN, Angus | Geschäftsführer | 5 Ellergreen Road Bearsden G61 2RU Glasgow Scotland | Scotland | British | 50499250001 | |||||
| MILLS, Alastair Richard | Geschäftsführer | St Katherine Docks E1W 1AZ London Commodity Quay United Kingdom | England | British | 108612460002 | |||||
| MITCHELL, Steven Keith | Geschäftsführer | St Katharine Docks E1W 1AZ London Commodity Quay | United Kingdom | British | 166684410001 | |||||
| PYEMONT, Peter David | Geschäftsführer | The Woll TD7 4NY Ashkirk Selkirkshire | Scotland | British | 72248250006 | |||||
| PYEMONT, Samantha | Geschäftsführer | The Woll TD7 4NY Ashkirk Selkirkshire | United Kingdom | British | 117672670001 | |||||
| RAND, David | Geschäftsführer | 15864 Highland Drive San Jose FOREIGN California 95127 Usa | American | 69473610001 | ||||||
| SMITH, Ronald Watson | Geschäftsführer | St Katherine Docks E1W 1AZ London Commodity Quay United Kingdom | England | British | 62182300001 | |||||
| SPAGNOLO, Mark Francis | Geschäftsführer | 360 Hamilton Avenue White Plains New York 10601 Usa | American | 79348190001 | ||||||
| STEINER, Paul, Dr | Geschäftsführer | 3897 Corina Way 94303 Palo Alto California Usa | Austrian | 64092980001 | ||||||
| TANZI, Nicholas Martin | Geschäftsführer | 5 Briscoe Chase 07456 Ringwood New Jersey Usa | American | 74339240001 | ||||||
| TAYLOR, Ian Frederick | Geschäftsführer | 31 Rushenden Furlong LU7 9QX Pitstone Bedfordshire | British | 78598110001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei BIS DATACENTRES LTD?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bis Limited | 06. Apr. 2016 | St Katharine Docks E1W 1AZ London Commodity Quay England | Nein | ||||
| |||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||
Hat BIS DATACENTRES LTD Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 26. Okt. 2015 Geliefert am 26. Okt. 2015 | Vollständig erfüllt | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 26. März 2013 Geliefert am 08. Apr. 2013 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each charging company and each obligor to the chargee and the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 26. März 2013 Geliefert am 08. Apr. 2013 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each charging company and each obligor to the chargee and the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 26. März 2013 Geliefert am 05. Apr. 2013 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 05. Sept. 2007 Geliefert am 12. Sept. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over shares | Erstellt am 15. Nov. 2006 Geliefert am 28. Nov. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £675,000 due or to become due from the company to | |
Kurze Angaben 658,853,300 ordinary b shares and 439,235,500 ordinary a shares in abovenet UK limited. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 20. Juni 2000 Geliefert am 29. Juni 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag Rent service charges insurance premiums or other contribution to the cost of insurance of the premises,outgoings value added tax and other payments payable to or recoverable by east india dock (building two) limited ("the landlord"),or in respect of which the landlord is entitled to be indemnified by abovenet UK limited ("the tenant") under the agreement for lease of even date; claims demands damages losses costs and expenses arising out of or incidental to breach by the tenant of the covenants and conditions in the lease or of obligations in the deed | |
Kurze Angaben The tenant's interest in the interest-bearing account maintained at a UK clearing bank by the landlord in which to hold the sum which the tenant has provided to the landlord to meet liabilities which are for the time being unexpended (the initial sum being £88,125). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0