WORKSPACE 5 LIMITED
Überblick
Unternehmensname | WORKSPACE 5 LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 03741554 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von WORKSPACE 5 LIMITED?
- Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich WORKSPACE 5 LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Canterbury Court Kennington Park 1-3 Brixton Road SW9 6DE London England |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von WORKSPACE 5 LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
INNERSCOPE LIMITED | 26. März 1999 | 26. März 1999 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WORKSPACE 5 LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2016 |
Welche sind die letzten Einreichungen für WORKSPACE 5 LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 21. Feb. 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2016 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Chester House Kennington Park 1-3 Brixton Road London SW9 6DE zum Canterbury Court Kennington Park 1-3 Brixton Road London SW9 6DE am 01. Nov. 2016 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 21. Feb. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2015 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 21. Feb. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2014 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 21. Feb. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2013 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 21. Feb. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2012 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Jameson Paul Hopkins als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Harry Platt als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 21. Feb. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2011 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * Magenta House 85 Whitechapel Road London E1 1DU* am 29. Juli 2011 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 21. Feb. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Graham Colin Clement am 02. März 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Harry Platt am 19. Okt. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2010 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von WORKSPACE 5 LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARFORA, Carmelina | Sekretär | Kennington Park 1-3 Brixton Road SW9 6DE London Canterbury Court England | 150286860001 | |||||||
CLEMETT, Graham Colin | Geschäftsführer | Kennington Park 1-3 Brixton Road SW9 6DE London Canterbury Court England | United Kingdom | British | Director | 123744930001 | ||||
HOPKINS, Jameson Paul | Geschäftsführer | Kennington Park 1-3 Brixton Road SW9 6DE London Canterbury Court England | United Kingdom | British | Director | 79842180002 | ||||
BINNS, Adam | Sekretär | 15 Langhams Way Wargrave RG10 8AX Reading Berkshire | British | Accountant | 113638490001 | |||||
MACDONALD, Iain Graham Ross | Sekretär | 172 White Hill HP5 1AZ Chesham Buckinghamshire | British | Solicitor | 66669510002 | |||||
SAHA, Nirmal Chandra | Sekretär | Sutherland Old Avenue KT13 0PQ Weybridge Surrey | British | 31811850002 | ||||||
TAYLOR, Robert Mark | Sekretär | 15 Hollow Way Lane HP6 6DJ Amersham Buckinghamshire | British | 43039830001 | ||||||
WALDMAN, Matthew | Sekretär | 195 Broomwood Road SW11 6JX London | British | Trainee Solicitor | 64012810001 | |||||
WHALLEY, Amanda | Sekretär | 12 Merchant Court 61 Wapping Wall Wapping E1W 3SD London | British | 124348320001 | ||||||
THE COMPANY REGISTRATION AGENTS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Leonard Street EC2A 4QS London 83 | 900013740001 | |||||||
BAMBER, Claire | Geschäftsführer | 14b Rastell Avenue SW2 4XP London | Irish | Solicitor | 64346470003 | |||||
CARRAGHER, Madeleine | Geschäftsführer | 17 Stadium Street Chelsea SW10 0PU London | British | Chartered Surveyor | 46150230001 | |||||
MARPLES, James Patrick | Geschäftsführer | Churchfield All Saints Lane Sutton Courtenay OX14 4AG Abingdon Oxfordshire | British | Chartered Surveyor | 57707320002 | |||||
PLATT, Harry | Geschäftsführer | Kennington Park 1-3 Brixton Road SW9 6DE London Chester House United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 41914500003 | ||||
PORTER, Alan Redvers | Geschäftsführer | The Clock House Horsham Road Capel RH5 5JJ Dorking Surrey | British | Director | 17838310001 | |||||
TAYLOR, Robert Mark | Geschäftsführer | 15 Hollow Way Lane HP6 6DJ Amersham Buckinghamshire | British | Accountant | 43039830001 | |||||
WALDMAN, Matthew | Geschäftsführer | 195 Broomwood Road SW11 6JX London | British | Trainee Solicitor | 64012810001 | |||||
LUCIENE JAMES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 83 Leonard Street EC2A 4QS London | 900003210001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei WORKSPACE 5 LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Workspace Glebe Limited | 06. Apr. 2016 | Kennington Park 1-3 Brixton Road SW9 6DE London Canterbury Court England | Nein | ||||
| |||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat WORKSPACE 5 LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Supplemental debenture supplemental to a debenture dated 15 july 2002 and | Erstellt am 24. Aug. 2005 Geliefert am 31. Aug. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from an obligor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The new property being the f/h land known as grand union centre north kensington london t/n NGL608575 all buildings and fixtures, and all rights to any proceeds of sale,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Supplemental debenture supplemental to a debenture dated 15 july 2002 and | Erstellt am 18. Aug. 2003 Geliefert am 20. Aug. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from an obligor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Aladdin business centre, long drive, greenford, middlesex t/n MX128991, farnborough business centre, eelmore road, farnborough, GU15 7XA t/n HP354443, romford seedbed centre, davidson way, romford, essex t/n EGL226569 (refer to form 395 for further details). By way of fixed charge all buildings and fixtures, all rights to and interest in any proceeds of sale. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 15. Juli 2002 Geliefert am 25. Juli 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All and any monies obligations and liabilities due or to become due from an obligor to the chargee as security trustee for each of the finance parties (the "security trustee") on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A supplemental debenture made between workspace 3 limited, workspace 4 limited, workspace 5 limited (together the "companies" and each a "company") and westdeutsche landesbank girozentrale | Erstellt am 09. Dez. 1999 Geliefert am 20. Dez. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All obligations and liabilities of each obligor to the finance parties or any of them under each of the finance documents (all defined therein) | |
Kurze Angaben Its right title and interest in all present and future agreements contracts deeds licences undertakings in respect of its mortgaged property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Security agreement made between workspace 1 limited, workspace 3 limited, workspace 4 limited, workspace 5 limited (together the company, the obligors and each a obligor), workspace holdings limited (wh) and westdeutsche landesbank girozentrale (the trustee) | Erstellt am 22. Nov. 1999 Geliefert am 08. Dez. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities of the company to the trustee under each of the finance documents (as defined) | |
Kurze Angaben By way of first fixed charge the investment security accounts which means the investment collection account - account no.8637261 And the investment disbursements account - account no.8632278. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 23. Juli 1999 Geliefert am 06. Aug. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0