7 GLOBAL GROUP LIMITED
Überblick
Unternehmensname | 7 GLOBAL GROUP LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 03747176 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von 7 GLOBAL GROUP LIMITED?
- (7260) /
Wo befindet sich 7 GLOBAL GROUP LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Rsm Tenon 11th Floor 66 Chiltern Street W1U 4JT London |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von 7 GLOBAL GROUP LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
7 HOLDINGS LIMITED | 26. Apr. 2004 | 26. Apr. 2004 |
7 GLOBAL LIMITED | 04. Aug. 2000 | 04. Aug. 2000 |
7 MANAGEMENT SERVICES LIMITED | 07. Apr. 1999 | 07. Apr. 1999 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von 7 GLOBAL GROUP LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2009 |
Welche sind die letzten Einreichungen für 7 GLOBAL GROUP LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 26. Juli 2013 | 13 Seiten | 4.68 | ||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation | 13 Seiten | 4.72 | ||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||
Insolvenzgerichtsbeschluss Court order INSOLVENCY:re oc replacement of liq | 49 Seiten | LIQ MISC OC | ||
Hinweis auf die Einstellung der Tätigkeit als freiwilliger Liquidator | 1 Seiten | 4.40 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Apr. 2013 | 16 Seiten | 4.68 | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 16. Apr. 2012 | 12 Seiten | 2.24B | ||
Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger | 1 Seiten | 2.34B | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 27. Okt. 2011 | 31 Seiten | 2.24B | ||
Vermögensübersicht mit Formular 2.14B | 6 Seiten | 2.16B | ||
Beendigung der Bestellung von William Cooper als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||
Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge | 1 Seiten | F2.18 | ||
Vorschlag des Verwalters | 35 Seiten | 2.17B | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 4 Cartel Business Centre Stroudley Road Basingstoke Hampshire RG24 8FW am 24. Mai 2011 | 2 Seiten | AD01 | ||
Ernennung eines Verwalters | 1 Seiten | 2.12B | ||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||
Rücktritt des Auditors | 2 Seiten | AUD | ||
Beendigung der Bestellung von John Severs als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||
Ernennung von Mr David Smith als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||
Ernennung von Mr Jonathan Bunney als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 18 Seiten | AA | ||
legacy | 5 Seiten | MG01 | ||
Beendigung der Bestellung von Alastair Ferguson als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||
Beendigung der Bestellung von Alastair Ferguson als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von 7 GLOBAL GROUP LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUNNEY, Jonathan | Geschäftsführer | Castle Street L2 4TA Liverpool The Old Bank Of England Building United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 157737540001 | ||||
SMITH, David | Geschäftsführer | Whispering Meadows Sykehouse DN14 9FB Goole The Willow North Humberside United Kingdom | England | British | Director | 61948500006 | ||||
BITHELL, Christopher Luke | Sekretär | 22 Ratcliffe Road Aspull WN2 1YE Wigan Lancashire | British | Consultant | 41672750001 | |||||
FERGUSON, Alastair William | Sekretär | Stroudley Road RG24 8FW Basingstoke 4 Cartel Business Centre Hampshire | 154527730001 | |||||||
HEARN, David Gareth | Sekretär | New Road OX18 2LF Bampton Middle Prospect Oxfordshire | British | 148531740001 | ||||||
BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite Lauren Court M33 2AF Wharf Road Sale Greater Manchester | 900018560001 | |||||||
BENNETT, Michael Andrew | Geschäftsführer | 2 Dudley Road Wimbledon SW19 8PN London | United Kingdom | British | Manager/Director | 121591160001 | ||||
BITHELL, Christopher Luke | Geschäftsführer | 22 Ratcliffe Road Aspull WN2 1YE Wigan Lancashire | England | British | Consultant | 41672750001 | ||||
CHRISTOU, Richard | Geschäftsführer | Apartment 4 14 The Knightsbridge Knightsbridge SW7 1RH London | United Kingdom | British | Director | 5835350002 | ||||
COOPER, William Stephen | Geschäftsführer | Clayton Street WN8 8HX Skelmersdale 52 Lancashire | United Kingdom | British | Accountant | 123479390001 | ||||
CRICH, Graham | Geschäftsführer | 45 Chapel Rise Worthington LE65 1RX Ashby De La Zouch Leicestershire | British | Vp Sales | 70225980001 | |||||
FERGUSON, Alastair William | Geschäftsführer | Stroudley Road RG24 8FW Basingstoke 4 Cartel Business Centre Hampshire | England | British | Chartered Accountant | 125179970001 | ||||
FRIEDLOS, Nicholas Robert | Geschäftsführer | 13 Alwyne Road N1 2HH London | England | British | Director | 61183260002 | ||||
HEARN, David Gareth | Geschäftsführer | New Road OX18 2LF Bampton Middle Prospect Oxfordshire | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 59462210001 | ||||
HOOFT, Pieter Johannes | Geschäftsführer | Greystones Cottage Lower Kingsdown Road SN13 8BA Kingsdown | United Kingdom | Dutch | Director | 99349340001 | ||||
JOSS, William Alexander | Geschäftsführer | The Old Rectory Whatcote CV36 5EB Warwickshire | United Kingdom | British | Company Director & Consultant | 72152610002 | ||||
ROE, Karl James | Geschäftsführer | Apartment 115 Century Buildings 14 Saint Marys Parsonage M3 2DE Manchester | British | Salesperson | 61507840003 | |||||
SEVERS, John Nicholas Foster | Geschäftsführer | Mayditch Place Bradwell Common MK13 8LX Milton Keynes 25 Buckinghamshire | Uk | British | None | 22649030002 | ||||
SHEPPARD, Richard John | Geschäftsführer | Kingsmere House Sandhurst Road, Finchampstead RG40 3LT Wokingham Berkshire | United Kingdom | British | Director | 105123380002 | ||||
DEANSGATE COMPANY FORMATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | The Britannia Suite Lauren Court M33 2AF Wharf Road Sale Greater Manchester | 900018550001 |
Hat 7 GLOBAL GROUP LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
All assets debenture | Erstellt am 12. Jan. 2011 Geliefert am 13. Jan. 2011 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee & debenture | Erstellt am 15. Nov. 2007 Geliefert am 24. Nov. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 18. Juni 2003 Geliefert am 25. Juni 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of variation (the "deed of variation") of a fixed and floating charge dated 7TH february 2001 (the "charge"). | Erstellt am 21. Juni 2001 Geliefert am 04. Juli 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 07. Feb. 2001 Geliefert am 23. Feb. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat 7 GLOBAL GROUP LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| In Verwaltung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
| Gläubiger-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0