MOUNTAIN SOFTWARE (IPR) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | MOUNTAIN SOFTWARE (IPR) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03749042 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von MOUNTAIN SOFTWARE (IPR) LIMITED?
- (7487) /
Wo befindet sich MOUNTAIN SOFTWARE (IPR) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | c/o KPMG LLP One Snowhill Snow Hill Queensway B4 6GH Birmingham |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von MOUNTAIN SOFTWARE (IPR) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| NEVBRIGHT (81) LIMITED | 08. Apr. 1999 | 08. Apr. 1999 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MOUNTAIN SOFTWARE (IPR) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Apr. 2009 |
Welche sind die letzten Einreichungen für MOUNTAIN SOFTWARE (IPR) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 3 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O C/O Kpmg 2 Cornwall Street Birmingham B3 2DL am 22. Dez. 2009 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Barbara Firth als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Apr. 2009 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Riding Court House Riding Court Road Datchet Slough Berkshire SL3 9JT United Kingdom am 12. Okt. 2009 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Insolvenzbeschluss Resolution INSOLVENCY:Special Resolution "In Specie" | 1 Seiten | LIQ MISC RES | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 403a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2008 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 225 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Juli 2007 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 190 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 353 | ||||||||||
legacy | 14 Seiten | 395 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 31 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von MOUNTAIN SOFTWARE (IPR) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBERTS, Neal Anthony | Sekretär | Little Aston Park Road B74 3BZ Sutton Coldfield Rivendell West Midlands | British | 140194900001 | ||||||
| LEUW, Martin Philip | Geschäftsführer | 29 Deansway N2 0NF London | United Kingdom | British | 4229530001 | |||||
| ROBERTS, Neal Anthony | Geschäftsführer | Rivendell Little Aston Park Road Little Aston B74 3BZ Sutton Coldfield West Midlands | United Kingdom | British | 12470210003 | |||||
| BREWIN, Joan Lorraine Emily | Sekretär | Danley Lodge Church Lane Welby NG32 3LS Grantham Lincolnshire | British | 41026050001 | ||||||
| BREWSTER, Alan Jetson | Sekretär | 10 Northease Drive BN3 8PQ Hove East Sussex | British | 46309600001 | ||||||
| CHALLINGER, Sara | Sekretär | Hollyoak 2a Cricket Hill Finchampstead RG40 3TN Wokingham Berkshire | British | 123713140001 | ||||||
| FIRTH, Barbara Ann | Sekretär | Bryher Cottage Lynx Hill KT24 5AX East Horsley Surrey | British | 73934790001 | ||||||
| KENDRICK, Stephen Edward | Sekretär | 36 Riverside Close PE9 2DX Stamford Lincolnshire | British | 65401010006 | ||||||
| BREWIN, Joan Lorraine Emily | Geschäftsführer | Danley Lodge Church Lane Welby NG32 3LS Grantham Lincolnshire | British | 41026050001 | ||||||
| BREWIN, John Martin | Geschäftsführer | Danley Lodge Church Lane Welby NG32 3LS Grantham Lincolnshire | British | 5101200001 | ||||||
| BREWSTER, Alan Jetson | Geschäftsführer | 10 Northease Drive BN3 8PQ Hove East Sussex | British | 46309600001 | ||||||
| FIRTH, Barbara Ann | Geschäftsführer | Bryher Cottage Lynx Hill KT24 5AX East Horsley Surrey | England | British | 73934790001 | |||||
| KENDRICK, Stephen Edward | Geschäftsführer | 36 Riverside Close PE9 2DX Stamford Lincolnshire | England | British | 65401010006 | |||||
| KNOX, Ian Wallace | Geschäftsführer | Laurel House First Drift Wothorpe PE9 3JL Stamford | United Kingdom | British | 8456660002 | |||||
| MURRIA, Vinodka | Geschäftsführer | Furran 16 Barham Close KT13 9PR Weybridge Surrey | United Kingdom | British | 57998050002 | |||||
| SAMPSON, Alison Lesley | Geschäftsführer | 5 Old Patcham Mews Patcham BN1 8YW Brighton East Sussex | England | British | 99210060001 | |||||
| VELUSSI, Luca | Geschäftsführer | 123 Hepworth Court 30 Gatliff Road SW1W 8QP London | United Kingdom | Italian | 113413330002 |
Hat MOUNTAIN SOFTWARE (IPR) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 02. Okt. 2007 Geliefert am 15. Okt. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the chargee or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 01. Dez. 2004 Geliefert am 21. Dez. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and debenture | Erstellt am 07. Okt. 2002 Geliefert am 15. Okt. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat MOUNTAIN SOFTWARE (IPR) LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0