SUMMERDALE COURT LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | SUMMERDALE COURT LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03750254 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von SUMMERDALE COURT LIMITED?
- Sonstige menschliche Gesundheitsaktivitäten (86900) / Gesundheits- und Sozialwesen
Wo befindet sich SUMMERDALE COURT LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Norcliffe House Station Road SK9 1BU Wilmslow |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SUMMERDALE COURT LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2014 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für SUMMERDALE COURT LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für SUMMERDALE COURT LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 05. Okt. 2015
| 5 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 06. Apr. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Ian Richard Smith am 19. Feb. 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Benjamin Robert Taberner am 18. Feb. 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Dominic Jude Kay als Geschäftsführer am 31. Okt. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Dominic Kay als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Abigail Mattison als Sekretär | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Maureen Claire Royston am 22. Mai 2014 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 06. Apr. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * Emerson Court Alderley Road Wilmslow Cheshire SK9 1NX* am 21. Feb. 2014 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung von Maureen Claire Royston als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Peter Calveley als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Ian Richard Smith als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 06. Apr. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 06. Apr. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von SUMMERDALE COURT LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATTISON, Abigail | Sekretär | Station Road SK9 1BU Wilmslow Norcliffe House United Kingdom | 188580880001 | |||||||
| ROYSTON, Maureen Claire, Dr | Geschäftsführer | Alderley Road Wilmslow SK9 1NX Cheshire Emerson Court England England | United Kingdom | British | 184190020002 | |||||
| SMITH, Ian Richard | Geschäftsführer | Station Road SK9 1BU Wilmslow Norcliffe House | United Kingdom | British | 181082310001 | |||||
| TABERNER, Benjamin Robert | Geschäftsführer | Station Road SK9 1BU Wilmslow Norcliffe House | United Kingdom | British | 150511890001 | |||||
| BARBER, David Alan | Sekretär | 14 Pinewood Gate HG2 0JF Harrogate North Yorkshire | British | 69879580002 | ||||||
| CALDWELL, Charles Anthony | Sekretär | 26 Hampton Manor BT7 3EL Belfast County Antrim | British | 65779460001 | ||||||
| CROWE, Geoffrey Michael | Sekretär | 51 Oakwood Lane Bowdon WA14 3DL Altrincham Cheshire | British | 38256680007 | ||||||
| KAY, Dominic Jude | Sekretär | 4 Glyn Avenue WA15 9DG Hale Cheshire | British | 145920530001 | ||||||
| MURPHY, Marc | Sekretär | 39 Cranmore Park BT9 6JF Belfast | Irish | 88620540001 | ||||||
| PATTERSON, Gordon | Sekretär | 6 Cultra Park BT18 0QE Holywood County Down | British | 65359330001 | ||||||
| CHETTLEBURGH INTERNATIONAL LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Temple House 20 Holywell Row EC2A 4JB London | 900000860001 | |||||||
| AUSTIN, Robert John | Geschäftsführer | The Cottage 8 Dockroyd Oakworth BD22 7RH Keighley West Yorkshire | British | 49285440001 | ||||||
| CALDWELL, Charles Anthony | Geschäftsführer | 26 Hampton Manor BT7 3EL Belfast County Antrim | Northern Ireland | British | 65779460001 | |||||
| CALVELEY, Peter, Dr | Geschäftsführer | Canwick Hill Canwick LN4 2RF Lincoln The Old Vicarage Lincolnshire | United Kingdom | British | 131468590001 | |||||
| HEHIR, Anthony Patrick | Geschäftsführer | Scolty Lodge 12 Oldfield Road Heswall CH60 6SE Wirral Merseyside | England | British | 111038070001 | |||||
| HEYWOOD, Anthony George | Geschäftsführer | Harborough Hall Lane CO5 9UA Messing Harborough Hall Essex | England | British | 131288260001 | |||||
| KAY, Dominic Jude | Geschäftsführer | 4 Glyn Avenue WA15 9DG Hale Cheshire | United Kingdom | British | 145920530001 | |||||
| MITCHELL, Nicholas John | Geschäftsführer | Lymbrook 53 Dore Road Dore S17 3NA Sheffield South Yorkshire | Great Britain | British | 145102120001 | |||||
| ORESCHNICK, Robert | Geschäftsführer | Bankfield Cold Hill Lane New Mill HD9 7JX Huddersfield West Yorkshire | American | 82179080001 | ||||||
| PATTERSON, Gordon | Geschäftsführer | No 5 Cultra Park BT18 0QE Holywood County Down Northern Ireland | British | 66574310004 | ||||||
| PATTERSON, Gordon | Geschäftsführer | 6 Cultra Park BT18 0QE Holywood County Down | Northern Ireland | British | 65359330001 | |||||
| PATTERSON, James | Geschäftsführer | 19 Knockmore Park BT20 3SL Bangor County Down Northern Ireland | Northern Ireland | British | 65359270002 | |||||
| SEARCH, Annabel Shirley | Geschäftsführer | Old Orchard House Church Street Goldsborough HG5 8NR Knaresborough North Yorkshire | British | 63367650001 | ||||||
| SMITH, Michael John | Geschäftsführer | 11 Lower Park Road IG10 4NB Loughton Essex | England | British | 641150001 |
Hat SUMMERDALE COURT LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of accession to a debenture dated 12 november 2004 | Erstellt am 11. Mai 2005 Geliefert am 27. Mai 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All property, certain group shares, contracts specified in the rhyme debenture, certain intellectual property rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental legal charge (supplemental to composite guarantee and debenture dated 7TH october 1998) | Erstellt am 18. Aug. 1999 Geliefert am 21. Aug. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies obligations and liabilities due or to become due from the obligors (as defined) or any of them to the chargee for itself and as trustee for the beneficiaries (as defined)under or in connection with the finance documents (as defined) and/or on any other account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a summerdale court nursing home 73 butchers road newham london E16 1PH t/nos: EGL340176 (part) and EGL350263 together with all buildings fixtures and fittings including trade fixtures and fittings and fixed plant and machinery from time to time thereon and/or the proceeds of sale thereof. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of accession (to composite guarnatee and mortgage debenture dated 7TH october 1998) | Erstellt am 18. Aug. 1999 Geliefert am 21. Aug. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies obligations and liabilities due or to become due from the obligors (as defined) or any of them to the chargee for itself and as trustee for the beneficiaries (as defined)under or in connection with the finance documents (as defined) and/or on any other account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 06. Mai 1999 Geliefert am 14. Mai 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land on the east side of butchers road canning town t/n EGL350263; f/h land k/a land on the east side of butchers road newham london t/n EGL340176. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0