WHINNEY HILL ENERGY 2 LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | WHINNEY HILL ENERGY 2 LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03754359 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von WHINNEY HILL ENERGY 2 LIMITED?
- Erzeugung von Elektrizität (35110) / Versorgung mit Elektrizität, Gas, Dampf und klimatisierten Luft
Wo befindet sich WHINNEY HILL ENERGY 2 LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 6th Floor 33 Holborn EC1N 2HT London England England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WHINNEY HILL ENERGY 2 LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für WHINNEY HILL ENERGY 2 LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 29. Nov. 2019
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 25. Apr. 2019 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Ernennung von Octopus Company Secretarial Services Limited als Sekretär am 15. Nov. 2018 | 2 Seiten | AP04 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Sharna Ludlow als Sekretär am 15. Nov. 2018 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2018 | 5 Seiten | AA | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Paul Stephen Latham am 07. Sept. 2018 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Company Secretary Sharna Ludlow am 25. Apr. 2018 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 25. Apr. 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Company Secretary Sharna Ludlow am 16. März 2018 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2017 | 5 Seiten | AA | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Kamalika Ria Banerjee als Sekretär am 19. Feb. 2018 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||||||
Ernennung von Kamalika Ria Banerjee als Sekretär am 30. Okt. 2017 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Paul Stephen Latham als Direktor am 15. Aug. 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 27. Apr. 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Matthew George Setchell am 20. Feb. 2017 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2016 | 5 Seiten | AA | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Tim James Senior als Geschäftsführer am 06. Okt. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Matthew George Setchell als Direktor am 06. Okt. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Register(s) wurden an die Geschäftsanschrift 6th Floor 33 Holborn London England EC1N 2HT verlegt | 2 Seiten | AD04 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von WHINNEY HILL ENERGY 2 LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCTOPUS COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Sekretär | Holborn EC1N 2HT London 33 England England |
| 253893850001 | ||||||||||
| LATHAM, Paul Stephen | Geschäftsführer | 33 Holborn EC1N 2HT London 6th Floor England England | United Kingdom | British | 146527710002 | |||||||||
| SETCHELL, Matthew George | Geschäftsführer | 33 Holborn EC1N 2HT London 6th Floor England England | England | British | 157021230004 | |||||||||
| WILKINSON, Edwin John | Geschäftsführer | Deben Mill Business Centre Old Maltings Approach IP12 1BL Woodbridge 6 Suffolk United Kingdom | England | British | 86926370001 | |||||||||
| BANERJEE, Kamalika Ria | Sekretär | 33 Holborn EC1N 2HT London 6th Floor England England | 239579570001 | |||||||||||
| FITZHERBERT, David Henry | Sekretär | 12 Gordon Place W8 4JD London | Irish | 74254060001 | ||||||||||
| GOOLD, James Edward Ian | Sekretär | 37 Lavender Sweep SW11 1DY London | British | 63011810002 | ||||||||||
| LUDLOW, Sharna, Company Secretary | Sekretär | Holborn EC1N 2HT London 33 England England | 208745520001 | |||||||||||
| PENTECOST, Alexandra Helen | Sekretär | 2 Stratton Villas Milbourne SN16 9JB Malmesbury Wiltshire | British | 70254590001 | ||||||||||
| WARD, Karen | Sekretär | 33 Holborn EC1N 2HT London 6th Floor England England | 204136920001 | |||||||||||
| EVERSECRETARY LIMITED | Sekretär | Eversheds House 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester | 60471940015 | |||||||||||
| FITZHERBERT, David Henry | Geschäftsführer | 12 Gordon Place W8 4JD London | United Kingdom | Irish | 74254060001 | |||||||||
| GOOLD, James Edward Ian | Geschäftsführer | 37 Lavender Sweep SW11 1DY London | British | 63011810002 | ||||||||||
| HOLMES, Randall Duane | Geschäftsführer | 36 Neustadt Lane 10514 Chappaqua New York Ny 10514 Usa | American | 64549270001 | ||||||||||
| PATON, John Derek | Geschäftsführer | Deben Mill Business Centre Old Maltings Approach IP12 1BL Woodbridge 6 Suffolk United Kingdom | United Kingdom | British | 76165310001 | |||||||||
| SENIOR, Timothy James, Dr | Geschäftsführer | 33 Holborn EC1N 2HT London 6th Floor England England | England | British | 244462470001 | |||||||||
| SWANSON, Robert Ernest | Geschäftsführer | 119 Turtle Point Road Tuxedo Park New York 10987 Usa | American | 95188450001 | ||||||||||
| THORNEYCROFT, Maxwell Bennett | Geschäftsführer | 80 Elgin Crescent W11 2JL London | United Kingdom | British | 3367180002 | |||||||||
| TILSTONE, David Paul | Geschäftsführer | 12 Manor Road TN4 8UE Tunbridge Wells Kent | United Kingdom | British | 117871440001 | |||||||||
| WEST, Andrew Thomas | Geschäftsführer | 4 Filkins Hall Filkins GL7 3JJ Lechdale Gloucestershire | United Kingdom | British | 79568920001 | |||||||||
| WILSON, Douglas Ralph | Geschäftsführer | 312 Highland Avenue 07450 Ridgewood New Jersey 07450 Usa | American | 91734800002 | ||||||||||
| WYNDHAM, Harry Hugh Patrick | Geschäftsführer | 56 Stockwell Park Crescent SW9 0DG London | England | British | 37118660001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei WHINNEY HILL ENERGY 2 LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clpe Projects 2 Limited | 06. Apr. 2016 | 33 Holborn EC1N 2HT London 6th Floor England England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat WHINNEY HILL ENERGY 2 LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 21. Jan. 2010 Geliefert am 22. Jan. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 22. Feb. 2007 Geliefert am 09. März 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The secured obligations under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All land equipment insurances debts goodwill and uncalled capital. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 04. Mai 2006 Geliefert am 17. Mai 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company,by each borrower and each other project company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All its interest in the property,together with all buildings and fixtures thereon,the proceeds of sale of all or any part thereof and the benefit of any covenants. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of accession | Erstellt am 16. Okt. 2001 Geliefert am 30. Okt. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All money and all obligations and liabilities due or to become due by the chargor to the chargee (the bank) under or pursuant to the composite guarantee and debenture dated 30TH june 2000 and the deed of accession and all moneys and liabilities now or hereafter due owing or incurred to the bank (including without limitation all moneys and liabilities due owing or incurred under or pursuant to the facility agreement) by each other company on any account whatsoever (all terms as defined) | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 03. Juli 2000 Geliefert am 21. Juli 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0