THE STATIONERY OFFICE HOLDINGS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | THE STATIONERY OFFICE HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03757233 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von THE STATIONERY OFFICE HOLDINGS LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich THE STATIONERY OFFICE HOLDINGS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 18 Central Avenue St. Andrews Business Park NR7 0HR Norwich England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von THE STATIONERY OFFICE HOLDINGS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| MEADOWPOINT PLC | 21. Apr. 1999 | 21. Apr. 1999 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von THE STATIONERY OFFICE HOLDINGS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2023 |
Welche sind die letzten Einreichungen für THE STATIONERY OFFICE HOLDINGS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2023 | 3 Seiten | AA | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 18 st. Andrews Business Park Norwich NR7 0HR England zum 18 Central Avenue St. Andrews Business Park Norwich NR7 0HR am 15. Mai 2023 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse 1-5 Poland Street London W1F 8PR verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||||||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde vom 1-5 Poland Street London W1F 8PR England zum 1-5 Poland Street London W1F 8PR geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde auf 1-5 Poland Street London W1F 8PR geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 21. Apr. 2023 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 1-5 Poland Street Soho London W1F 8PR England zum 18 st. Andrews Business Park Norwich NR7 0HR am 30. Apr. 2023 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Change of details for Williams Lea Group Limited as a person with significant control on 30. Apr. 2023 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||||||
Geänderte Konten eines Mikrounternehmens erstellt bis 31. Dez. 2022 | 3 Seiten | AAMD | ||||||||||||||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2022 | 3 Seiten | AA | ||||||||||||||
Ernennung von Nicholas Morgan als Direktor am 30. Sept. 2022 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jeremy Hamilton Hook als Geschäftsführer am 30. Sept. 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2021 | 3 Seiten | AA | ||||||||||||||
Change of details for Williams Lea Group Limited as a person with significant control on 01. Jan. 2022 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 10. Aug. 2022
| 5 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 21. Apr. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 6 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 21. Apr. 2021 mit Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 55 Wells Street London W1A 3AE England zum 1-5 Poland Street Soho London W1F 8PR am 30. Okt. 2020 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von THE STATIONERY OFFICE HOLDINGS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN, Nicholas | Geschäftsführer | Central Avenue St. Andrews Business Park NR7 0HR Norwich 18 England | United Kingdom | British | 300650740001 | |||||||||
| REID, Denise Mary | Geschäftsführer | Central Avenue St. Andrews Business Park NR7 0HR Norwich 18 England | England | British | 262166260001 | |||||||||
| DELL, Richard Frederick | Sekretär | 12 Corton Road NR32 4PL Lowestoft Suffolk | British | 74124260001 | ||||||||||
| DUNCAN, William Grant | Sekretär | St John's Lane EC1M 4NA London 29 England | British | 75956440002 | ||||||||||
| JEAKINGS, Adrian Dion | Sekretär | 466a Unthank Road NR4 7QJ Norwich Norfolk | British | 63331450001 | ||||||||||
| LI, Jane | Sekretär | Ocean House The Ring RG12 1AN Bracknell Company Secretary Berkshire England | 202695240001 | |||||||||||
| CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 10 Upper Bank Street E14 5JJ London | 900005620001 | |||||||||||
| EXEL SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Sekretär | The Ring RG12 1AN Bracknell Ocean House Berkshire United Kingdom |
| 32524900007 | ||||||||||
| BISH, John Edward | Geschäftsführer | 25 Stuart House Windsorway W14 0UF London | British | 118472780001 | ||||||||||
| BURNS, Iain Keatings | Geschäftsführer | Crow Clump Yaffle Road St Georges Hill KT13 0QF Weybridge Surrey | England | British | 34589310001 | |||||||||
| CHARLTON, Peter John | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 17 Kirkdale Road AL5 2PT Harpenden Hertfordshire | British | 900005610001 | ||||||||||
| COWARD, Richard Stanley | Geschäftsführer | 2 Leman Street E1 8FA London Aldgate Tower England | United Kingdom | British | 199946190001 | |||||||||
| DELL, Richard Frederick | Geschäftsführer | Eastbourne Terrace W2 6LG London 10 United Kingdom | United Kingdom | British | 74124260001 | |||||||||
| FAGANDINI, Julian Andrew | Geschäftsführer | 68 Elsenham Street Southfields SW18 5NT London | England | British | 46249760002 | |||||||||
| FAULKNER, Stephen James | Geschäftsführer | Wells Street W1A 3AE London 55 England | England | Irish | 190049190002 | |||||||||
| FITZSIMONS, Paul | Geschäftsführer | Kennel Moor Lower Moushill Lane GU8 5JX Milford Surrey | United Kingdom | British | 105466770001 | |||||||||
| GRIFFITHS, Timothy Philip | Geschäftsführer | Eastbourne Terrace W2 6LG London 10 United Kingdom | England | British | 9091580003 | |||||||||
| GUNTON, Andrew James | Geschäftsführer | Wells Street W1A 3AE London 55 England | England | British | 201996600001 | |||||||||
| HAILSTONE, Timothy Martin | Geschäftsführer | The White Cottage Ivy Bank Swannaton Road TQ6 9RL Dartmouth Devon | United Kingdom | British | 62539790001 | |||||||||
| HALL, Tom | Geschäftsführer | 45 Elgin Crescent W11 2JU London | British | 65649790001 | ||||||||||
| HOOK, Jeremy Hamilton | Geschäftsführer | Poland Street Soho W1F 8PR London 1-5 England | England | British | 80045690001 | |||||||||
| HOOK, Jeremy Hamilton | Geschäftsführer | Wells Street W1A 3AE London 55 England | England | British | 80045690001 | |||||||||
| HOWL, Roger Stuart | Geschäftsführer | Wells Street W1A 3AE London 55 England | England | British | 199288360001 | |||||||||
| JEAKINGS, Adrian Dion | Geschäftsführer | 466a Unthank Road NR4 7QJ Norwich Norfolk | Uk | British | 63331450001 | |||||||||
| LAWTON, Kevan | Geschäftsführer | 14 The Chase SL6 7QW Maidenhead Berkshire | British | 65367040001 | ||||||||||
| MIDDLETON, Rupert John | Geschäftsführer | 80 Mortimer Road N1 5AP London | United Kingdom | British | 27908530001 | |||||||||
| PENNANT-REA, Rupert Lascelles | Geschäftsführer | 59 Cranmer Court Whiteheads Grove SW3 3HW London | Uk | British | 44312900002 | |||||||||
| PERKINS, Frederick James | Geschäftsführer | 25 Ham Farm Road TW10 5NA Richmond Surrey | United Kingdom | British | 27861770001 | |||||||||
| PIERLEONI, Marco Alessandro | Geschäftsführer | St John's Lane EC1M 4NA London 29 England | England | British | 133649430001 | |||||||||
| RICHARDS, Martin Edgar | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 89 Thurleigh Road SW12 8TY London | British | 900002870001 | ||||||||||
| SIMPSON-DENT, Jonathan Andrew | Geschäftsführer | Wells Street W1A 3AE London 55 England | United Kingdom | British | 121064970001 | |||||||||
| SMITH, Benedict James | Geschäftsführer | Wells Street W1A 3AE London 55 England | England | British | 75231110002 | |||||||||
| TOULSON CLARKE, Christopher Timothy Miles | Geschäftsführer | Eastbourne Terrace W2 6LG London 10 United Kingdom | United Kingdom | British | 45455220003 | |||||||||
| WRIGHT, Timothy James | Geschäftsführer | Cherington House Cherington CV36 5HS Shipston On Stour Warwickshire | United Kingdom | British | 88919840001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei THE STATIONERY OFFICE HOLDINGS LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mr Jonathan Andrew Simpson-Dent | 01. Apr. 2018 | Wells Street W1A 3AE London 55 England | Ja | ||||||||||
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: United Kingdom | |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Mr Stephen James Faulkner | 21. Apr. 2017 | Wells Street W1A 3AE London 55 England | Ja | ||||||||||
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Mr Andrew James Gunton | 21. Apr. 2017 | Wells Street W1A 3AE London 55 England | Ja | ||||||||||
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Mr Jeremy Hamilton Hook | 21. Apr. 2017 | Wells Street W1A 3AE London 55 England | Ja | ||||||||||
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Mr Richard Stanley Coward | 21. Apr. 2017 | 2 Leman Street E1 8FA London Aldgate Tower England | Ja | ||||||||||
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: United Kingdom | |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Williams Lea Group Limited | 06. Apr. 2016 | Leeds Valley Park LS10 1AB Leeds Darwin House England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat THE STATIONERY OFFICE HOLDINGS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of assignment of keyman life policies | Erstellt am 03. Apr. 2003 Geliefert am 10. Apr. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All indebtedness liabilities and obligations due or to become due from any group company to the chargee (the "security trustee") as agent and trustee forthe banks, the working capital bank and the hedging counterparty) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The policies and all monies. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security deposit deed | Erstellt am 31. Okt. 2002 Geliefert am 08. Nov. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All monies including the initial deposit of £5,000,000 together with all interest accruing standing to the credit of the account held by the company with the bank. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 20. Juli 2000 Geliefert am 02. Aug. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All indebtedness liabilities and obligations due owing or incurred in any manner whatsoever to the chargee by the company under the deep discount bond instrument | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 20. Juli 2000 Geliefert am 02. Aug. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any charging company and/or any group company to the security benficiaries which is for the time being a party to any security document whether pursuant to the guarantee or otherwise (all as defined therein) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 30. Juli 1999 Geliefert am 10. Aug. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All indebtedness liabilities and obligations due or to become due from the charging company and/or any group company (as defined) to the chargee as security trustee for the security beneficiaries (as defined) whether pursuant to the guarantee (as defined) or otherwise or any security document (as defined) and on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over cash collateral account | Erstellt am 30. Juli 1999 Geliefert am 10. Aug. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the loan note guarantee facility | |
Kurze Angaben All right title and interest in the cash collateral account and the charged balance. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0