FSG SECURITY PLC

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameFSG SECURITY PLC
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformAktiengesellschaft
    Unternehmensnummer 03759409
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von FSG SECURITY PLC?

    • (7460) /

    Wo befindet sich FSG SECURITY PLC?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Pannell House
    159 Charles Street
    LE1 1LD Leicester
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von FSG SECURITY PLC?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    ECOHAZEL LTD26. Apr. 199926. Apr. 1999

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von FSG SECURITY PLC?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2008

    Welche sind die letzten Einreichungen für FSG SECURITY PLC?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    10 Seiten4.72

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 01. Juni 2013

    2 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 01. Juni 2012

    11 Seiten4.68

    Insolvenzgerichtsbeschluss

    Court order INSOLVENCY:replacement of liquidator
    34 SeitenLIQ MISC OC

    Hinweis auf die Einstellung der Tätigkeit als freiwilliger Liquidator

    1 Seiten4.40

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 13. Okt. 2011

    12 Seiten4.68

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Insolvenzgerichtsbeschluss

    Court order insolvency:- replacement of liquidator
    27 SeitenLIQ MISC OC

    Hinweis auf die Einstellung der Tätigkeit als freiwilliger Liquidator

    1 Seiten4.40

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 29. Juli 2011

    11 Seiten4.68

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    3 SeitenF10.2

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 23. Juli 2010

    13 Seiten2.24B

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    11 Seiten2.34B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 27. Feb. 2010

    12 Seiten2.24B

    Ergebnis der Gläubigerversammlung

    3 Seiten2.23B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.15B/2.14B

    53 Seiten2.16B

    Vorschlag des Verwalters

    58 Seiten2.17B

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten287

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    legacy

    1 Seiten288c

    Wer sind die Geschäftsführer von FSG SECURITY PLC?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    WOODFORD, Christopher
    Wall Hill Road
    Allesley
    CV5 9EN Coventry
    3
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Wall Hill Road
    Allesley
    CV5 9EN Coventry
    3
    West Midlands
    BritishDirector107149630004
    BOWDEN, Garry Raymond
    3 Perryford Drive
    B91 3XE Solihull
    West Midlands
    Sekretär
    3 Perryford Drive
    B91 3XE Solihull
    West Midlands
    AustralianAccountant46567860001
    CASHMORE, Michael James
    16 Nightingale Court
    Kelvedon Grove
    B91 2UG Solihull
    West Midlands
    Sekretär
    16 Nightingale Court
    Kelvedon Grove
    B91 2UG Solihull
    West Midlands
    British94577950001
    CONYBEARE, Steven James
    113-123 Upper Richmond Road
    SW15 2TL London
    Sekretär
    113-123 Upper Richmond Road
    SW15 2TL London
    British62127530001
    DAVIES, Keith
    49 Landor Road
    Knowle
    B93 9HZ Solihull
    Sekretär
    49 Landor Road
    Knowle
    B93 9HZ Solihull
    British85602300001
    DONEGAN, Simon Patrick
    The Old School House
    Northend
    RG9 6LJ Henley Upon Thames
    Oxfordshire
    Sekretär
    The Old School House
    Northend
    RG9 6LJ Henley Upon Thames
    Oxfordshire
    BritishSecurity Consultant77399210003
    LAWRENCE, Christopher
    4 Sunderland Close
    RG5 4XR Woodley
    Berkshire
    Sekretär
    4 Sunderland Close
    RG5 4XR Woodley
    Berkshire
    BritishDirector77399470001
    WAKELEY, David Peacefull
    166 Rosemary Hill Road
    B74 4HN Sutton Coldfield
    West Midlands
    Sekretär
    166 Rosemary Hill Road
    B74 4HN Sutton Coldfield
    West Midlands
    BritishFinance Director86839080001
    WEBB, David John
    44 Phipps Hatch Lane
    EN2 0HN Enfield
    Middlesex
    Sekretär
    44 Phipps Hatch Lane
    EN2 0HN Enfield
    Middlesex
    British38372670002
    FORM 10 SECRETARIES FD LTD
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    Bevollmächtigter Sekretär
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    900014000001
    BOWDEN, Garry Raymond
    3 Perryford Drive
    B91 3XE Solihull
    West Midlands
    Geschäftsführer
    3 Perryford Drive
    B91 3XE Solihull
    West Midlands
    AustralianAccountant46567860001
    BROWN, Neil Philip
    5 Woodlands Lane
    NN18 8HJ Great Oakley
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    5 Woodlands Lane
    NN18 8HJ Great Oakley
    Northamptonshire
    BritishDirector81334660001
    CAPON, Val St John
    21 The Street
    Rustington
    BN16 3PA Littlehampton
    West Sussex
    Geschäftsführer
    21 The Street
    Rustington
    BN16 3PA Littlehampton
    West Sussex
    EnglandBritishDirector96311330002
    DONEGAN, Simon Patrick
    The Old School House
    Northend
    RG9 6LJ Henley Upon Thames
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    The Old School House
    Northend
    RG9 6LJ Henley Upon Thames
    Oxfordshire
    BritishSecurity Consultant77399210003
    GUNSTON, John Wellesley, Sir
    12 Carlyle Court
    Chelsea Harbour
    SW10 0UQ London
    Geschäftsführer
    12 Carlyle Court
    Chelsea Harbour
    SW10 0UQ London
    BritishCompany Director45875000002
    HALLER, Frederic Zachary
    The Brick House 2a Dunstan Road
    NW11 8AA London
    Geschäftsführer
    The Brick House 2a Dunstan Road
    NW11 8AA London
    EnglandBritishBanker36104430001
    HIGGINS, Neil
    6 Lurgashall
    RH15 0BL Burgess Hill
    West Sussex
    Geschäftsführer
    6 Lurgashall
    RH15 0BL Burgess Hill
    West Sussex
    BritishSecurity Consultant64447450002
    HOBBS, Keith Raymond
    Benwhyles
    Medstead
    GU34 5EA Alton
    Geschäftsführer
    Benwhyles
    Medstead
    GU34 5EA Alton
    United KingdomBritishCompany Director707020001
    LAWRENCE, Christopher
    4 Sunderland Close
    RG5 4XR Woodley
    Berkshire
    Geschäftsführer
    4 Sunderland Close
    RG5 4XR Woodley
    Berkshire
    United Kingdom BritishCompany Director77399470001
    LOCKIE, Dean Royston
    33 Stockburn Drive
    M35 9SD Failsworth
    Manchester
    Geschäftsführer
    33 Stockburn Drive
    M35 9SD Failsworth
    Manchester
    BritishManaging Director76878680001
    LUNN, Andrew Jonathan
    30 Shirland Street
    S41 7NH Chesterfield
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    30 Shirland Street
    S41 7NH Chesterfield
    Derbyshire
    BritishSales Director70754600002
    MARTIN, Leslie John, Mr.
    Parchfield House
    Colton Road
    WS15 3HG Rugeley
    Staffs
    Geschäftsführer
    Parchfield House
    Colton Road
    WS15 3HG Rugeley
    Staffs
    EnglandEnglishDirector116204820001
    O'REILLY, Anthony James
    3 Melton Road
    NG12 5PH Stanton On The Wolds
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    3 Melton Road
    NG12 5PH Stanton On The Wolds
    Nottinghamshire
    BritishDirector97146280002
    ROBERTSON, Robert William
    117 Winwick Road
    WA12 8DB Newton Le Willows
    Merseyside
    Geschäftsführer
    117 Winwick Road
    WA12 8DB Newton Le Willows
    Merseyside
    BritishSecurity Consultant100065310001
    SCOTT, Andrew Hillyer
    Lower Lye
    Holloway, East Knoyle
    SP3 6AQ Salisbury
    Wiltshire
    Geschäftsführer
    Lower Lye
    Holloway, East Knoyle
    SP3 6AQ Salisbury
    Wiltshire
    United KingdomBritishDirector64012720001
    TAFT, David Jackson
    The Croft
    Worcester Road Broome
    DY9 0HS Stourbridge
    West Midlands
    Geschäftsführer
    The Croft
    Worcester Road Broome
    DY9 0HS Stourbridge
    West Midlands
    UkBritishDirector82677730001
    WAKELEY, David Peacefull
    166 Rosemary Hill Road
    B74 4HN Sutton Coldfield
    West Midlands
    Geschäftsführer
    166 Rosemary Hill Road
    B74 4HN Sutton Coldfield
    West Midlands
    United KingdomBritishFinance Director86839080001
    FORM 10 DIRECTORS FD LTD
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    900013990001

    Hat FSG SECURITY PLC Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 01. Juni 2006
    Geliefert am 07. Juni 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transaktionen
    • 07. Juni 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 30. Mai 2006
    Geliefert am 03. Juni 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Juni 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 20. Jan. 2005
    Geliefert am 27. Jan. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Jan. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Juli 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 14. März 2003
    Geliefert am 20. März 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. März 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Mai 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest
    Erstellt am 31. Dez. 2002
    Geliefert am 03. Jan. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of fixed equitable charge all debts purchased or purported to be purchased by the chargee pursuant to an agreement for the purchase of debts between the chargee and the company (including the associated rights relating thereto) which fail to vest effectively or absolutely in the chargee for any reason.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD
    Transaktionen
    • 03. Jan. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Mai 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 11. Juni 2002
    Geliefert am 20. Juni 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Juni 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Apr. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 30. Okt. 2001
    Geliefert am 01. Nov. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Nov. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Mai 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 10. Jan. 2000
    Geliefert am 13. Jan. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a lease of even date
    Kurze Angaben
    The initial deposit of £3,779.95 plus further sums.
    Berechtigte Personen
    • Barlows Developments Limited
    Transaktionen
    • 13. Jan. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Mai 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat FSG SECURITY PLC Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    30. Juli 2010Ende der Verwaltung
    28. Aug. 2009Beginn der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Brian James Hamblin
    Pkf
    New Guild House
    B3 2LX 45 Great Charles Street
    Queensway Birmingham
    Praktiker
    Pkf
    New Guild House
    B3 2LX 45 Great Charles Street
    Queensway Birmingham
    Edward Terence Kerr
    Pkf
    Pannell House
    LE1 1LD 159 Charles Street
    Leicester
    Praktiker
    Pkf
    Pannell House
    LE1 1LD 159 Charles Street
    Leicester
    2
    DatumTyp
    17. Apr. 2014Aufgelöst am
    30. Juli 2010Beginn der Liquidation
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Brian James Hamblin
    Pkf
    New Guild House
    B3 2LX 45 Great Charles Street
    Queensway Birmingham
    Praktiker
    Pkf
    New Guild House
    B3 2LX 45 Great Charles Street
    Queensway Birmingham
    Edward Terence Kerr
    Pkf
    Pannell House
    LE1 1LD 159 Charles Street
    Leicester
    Praktiker
    Pkf
    Pannell House
    LE1 1LD 159 Charles Street
    Leicester
    Ian James Gould
    Bdo Llp Pannell House
    159 Charles Street
    LE1 1LD Leicester
    Praktiker
    Bdo Llp Pannell House
    159 Charles Street
    LE1 1LD Leicester

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0