BLANELAND LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameBLANELAND LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03759899
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von BLANELAND LIMITED?

    • Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich BLANELAND LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    340 Deansgate
    M3 4LY Manchester
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BLANELAND LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2010

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für BLANELAND LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für BLANELAND LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    19 Seiten4.72

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 10. Sept. 2013

    17 Seiten4.68

    Vermögensübersicht mit Formular 4.19

    6 Seiten4.20

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren

    LRESEX

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Crowe Clark Whitehill Llp Arkwright House Parsonage Gardens Manchester M3 2HP England am 23. Aug. 2012

    2 SeitenAD01

    Jahresrückblick erstellt bis 27. Apr. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital29. Mai 2012

    Kapitalaufstellung am 29. Mai 2012

    • Kapital: GBP 1,000
    SH01

    accounts-with-accounts-type-

    7 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 27. Apr. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Raymond Malcolm Victor Gross am 27. Apr. 2011

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Adam Louis Gross am 27. Apr. 2011

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Mr Raymond Malcolm Victor Gross am 27. Apr. 2011

    2 SeitenCH03

    Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Horwath Clark Whitehill 6th Floor Arkwright House Parsonage Gardens Manchester M3 2HP am 22. Juni 2011

    1 SeitenAD01

    legacy

    3 SeitenMG02

    accounts-with-accounts-type-

    7 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 27. Apr. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    accounts-with-accounts-type-

    5 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288b

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007

    15 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288c

    Wer sind die Geschäftsführer von BLANELAND LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    GROSS, Raymond Malcolm Victor
    Ashley Road
    Hale
    WA14 2UN Altrincham
    124a
    Cheshire
    Sekretär
    Ashley Road
    Hale
    WA14 2UN Altrincham
    124a
    Cheshire
    British12387890002
    GROSS, Adam Louis
    Ashley Road
    Hale
    WA14 2UN Altrincham
    124a
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Ashley Road
    Hale
    WA14 2UN Altrincham
    124a
    Cheshire
    United KingdomBritish75469030003
    GROSS, Raymond Malcolm Victor
    Ashley Road
    Hale
    WA14 2UN Altrincham
    124a
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Ashley Road
    Hale
    WA14 2UN Altrincham
    124a
    Cheshire
    United KingdomBritish12387890002
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Bevollmächtigter Sekretär
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004100001
    GROSS, Gerald
    10a-11a The Square
    Hale Burns
    WA15 8ST Altrincham
    Cheshire
    Geschäftsführer
    10a-11a The Square
    Hale Burns
    WA15 8ST Altrincham
    Cheshire
    British28848540004
    RACKIND, Peter Elliot
    Wrenwood
    19 Broadway Hale
    WA15 0PE Altrincham
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Wrenwood
    19 Broadway Hale
    WA15 0PE Altrincham
    Cheshire
    British2398970001
    HALLMARK REGISTRARS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004090001

    Hat BLANELAND LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 20. Juli 2005
    Geliefert am 28. Juli 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property at 73 to 83 (odd numbers) liverpool road and other land lying to the south of liverpool road and north of rice street manchester t/no's GM85658 and GM353333. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 28. Juli 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Aug. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 04. Aug. 2004
    Geliefert am 07. Aug. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 07. Aug. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Aug. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 29. Apr. 2002
    Geliefert am 30. Apr. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Leasehold property k/a ground floor unit 91-93 liverpool road manchester. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 30. Apr. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Aug. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Mortgage
    Erstellt am 11. Aug. 2000
    Geliefert am 16. Aug. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to an agreement dated 28TH july 2000
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 73/83 liverpool road castlefield manchester - GM85658 and GM353333.
    Berechtigte Personen
    • M J Gleeson Group PLC
    Transaktionen
    • 16. Aug. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Mai 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal mortgage
    Erstellt am 06. Juli 1999
    Geliefert am 09. Juli 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a 73/83 liverpool road manchester. T/no gm 85658 and gm 353333. and the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Juli 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Aug. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat BLANELAND LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    11. Sept. 2012Beginn der Liquidation
    02. März 2015Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Paul Stanley
    C/O Begbies Traynor (Central) Llp, 340 Deansgate
    M3 4LY Manchester
    Praktiker
    C/O Begbies Traynor (Central) Llp, 340 Deansgate
    M3 4LY Manchester
    Jason Dean Greenhalgh
    340 Deansgate
    M3 4LY Manchester
    Praktiker
    340 Deansgate
    M3 4LY Manchester

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0