BNY MELLON CAPITAL MARKETS EMEA LIMITED

BNY MELLON CAPITAL MARKETS EMEA LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameBNY MELLON CAPITAL MARKETS EMEA LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03766757
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von BNY MELLON CAPITAL MARKETS EMEA LIMITED?

    • Finanzintermediation sonst. n.n.a. (64999) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen

    Wo befindet sich BNY MELLON CAPITAL MARKETS EMEA LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von BNY MELLON CAPITAL MARKETS EMEA LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    BNY MELLON SERVICES LIMITED01. Feb. 200801. Feb. 2008
    BNY SECURITIES LIMITED25. Jan. 200225. Jan. 2002
    BNY CLEARING SERVICES INTERNATIONAL LIMITED01. Aug. 200001. Aug. 2000
    BHF SECURITIES INTERNATIONAL LIMITED04. Juni 199904. Juni 1999
    FLATWALL LIMITED07. Mai 199907. Mai 1999

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BNY MELLON CAPITAL MARKETS EMEA LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2018

    Welche sind die letzten Einreichungen für BNY MELLON CAPITAL MARKETS EMEA LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    9 SeitenLIQ13

    Geänderte Geschäftsanschrift vom One Canada Square London E14 5AL zum 25 Farringdon Street London EC4A 4AB am 15. Juni 2020

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 26. Mai 2020

    LRESSP

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    6 SeitenLIQ01

    Bestätigungserklärung erstellt am 07. Mai 2020 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Kapitalaufstellung am 13. März 2020

    • Kapital: GBP 1
    • Kapital: USD 1
    3 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenSH20

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Erfüllung der Belastung 6 vollständig

    6 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 7 vollständig

    6 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 5 vollständig

    11 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 2 vollständig

    6 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 4 vollständig

    8 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 037667570008 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 3 vollständig

    5 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 1 vollständig

    11 SeitenMR04

    Ernennung von Mr John Charles Tisdall als Direktor am 06. Juli 2017

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von John Charles Tisdall als Geschäftsführer am 11. Okt. 2019

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 07. Mai 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2018

    43 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von James Alexander Edwards als Geschäftsführer am 23. Mai 2018

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017

    38 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von BNY MELLON CAPITAL MARKETS EMEA LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BNY MELLON SECRETARIES (UK) LIMITED
    Queen Victoria Street
    EC4V 4LA London
    160
    United Kingdom
    Sekretär
    Queen Victoria Street
    EC4V 4LA London
    160
    United Kingdom
    Art des AusweisesBritische Gesellschaft mit beschränkter Haftung
    Registrierungsnummer04115131
    73421460005
    SAVCHUK, Robin Culver
    Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    25
    Geschäftsführer
    Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    25
    EnglandCanadian180477490001
    TISDALL, John Charles
    Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    25
    Geschäftsführer
    Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    25
    EnglandSouth African263751560001
    WATKINS, Daniel Edward
    Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    25
    Geschäftsführer
    Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    25
    United KingdomBritish235181080001
    BATESON, Anne Rosalind
    High Trees
    Great Holland
    CO13 0HZ Frinton On Sea
    Essex
    Bevollmächtigter Sekretär
    High Trees
    Great Holland
    CO13 0HZ Frinton On Sea
    Essex
    British900007490001
    CHOU WO, Patrick
    1996 East 28th Street
    Brooklyn
    New York 11229
    Usa
    Sekretär
    1996 East 28th Street
    Brooklyn
    New York 11229
    Usa
    American65094730001
    BERNTSEN, Torry
    22 Linden Lane
    Chatham
    FOREIGN New Jersey Nj 07928
    Usa
    Geschäftsführer
    22 Linden Lane
    Chatham
    FOREIGN New Jersey Nj 07928
    Usa
    United StatesAmerican50100800001
    CAMERON, Angus Kenneth
    1 Canada Square
    E14 5AL London
    Geschäftsführer
    1 Canada Square
    E14 5AL London
    British116129240001
    CHOU WO, Patrick
    1996 East 28th Street
    Brooklyn
    New York 11229
    Usa
    Geschäftsführer
    1996 East 28th Street
    Brooklyn
    New York 11229
    Usa
    American65094730001
    COLEMAN, Nicholas Charles
    Ashdown House East
    Tanyard Lane
    RH17 7JW Danehill
    East Sussex
    Geschäftsführer
    Ashdown House East
    Tanyard Lane
    RH17 7JW Danehill
    East Sussex
    EnglandBritish191831630001
    COMPSON, Douglas William
    7 Downside
    10 St Johns Avenue Putney
    SW15 2AE London
    Geschäftsführer
    7 Downside
    10 St Johns Avenue Putney
    SW15 2AE London
    British92490850002
    EDWARDS, James Alexander
    One Canada Square
    London
    E14 5AL
    Geschäftsführer
    One Canada Square
    London
    E14 5AL
    EnglandBritish164607520001
    FITZPATRICK, Vincent John
    302 Rocky Top Road,
    FOREIGN Morganville
    New Jersey 07751
    United States
    Geschäftsführer
    302 Rocky Top Road,
    FOREIGN Morganville
    New Jersey 07751
    United States
    Us Citizen105094450001
    GASS, Ian Christopher
    One Canada Square
    London
    E14 5AL
    Geschäftsführer
    One Canada Square
    London
    E14 5AL
    United KingdomBritish174643660001
    GILL, Richard John
    One Canada Square
    London
    E14 5AL
    Geschäftsführer
    One Canada Square
    London
    E14 5AL
    United KingdomBritish252911660001
    GRANA, Michael
    15 Rambling Brook Drive
    Holmdel
    Nj 07733
    Usa
    Geschäftsführer
    15 Rambling Brook Drive
    Holmdel
    Nj 07733
    Usa
    American65526350001
    JOHNSTON, John Meikle
    One Canada Square
    London
    E14 5AL
    Geschäftsführer
    One Canada Square
    London
    E14 5AL
    EnglandBritish116070740001
    JOHNSTONE, Alexander George
    Marmion Road
    SW11 5PD London
    15a
    Geschäftsführer
    Marmion Road
    SW11 5PD London
    15a
    British107679870001
    JONES, Gareth Richard
    Garden Flat
    75 Oxford Gardens
    W10 5UL London
    Geschäftsführer
    Garden Flat
    75 Oxford Gardens
    W10 5UL London
    British95819670001
    JONES, Stephen Anthony
    10 Folly Avenue
    AL3 5QD St Albans
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    10 Folly Avenue
    AL3 5QD St Albans
    Hertfordshire
    EnglandBritish71457180001
    KEANEY, Timothy Francis
    2 Wetherby Gardens
    SW5 0JN London
    Geschäftsführer
    2 Wetherby Gardens
    SW5 0JN London
    United KingdomUnited States93962140002
    KERR, William Abercrombie
    One Canada Square
    London
    E14 5AL
    Geschäftsführer
    One Canada Square
    London
    E14 5AL
    EnglandBritish125919810001
    LAI, Poh Lim
    24 Redwood Drive
    LU7 0TA Wing
    Buckinghamshire
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    24 Redwood Drive
    LU7 0TA Wing
    Buckinghamshire
    British900007480001
    LASALLA, Francis Joseph
    1170 Bridge Pointe Lane
    Yorktown Heights
    FOREIGN New York 10598
    Usa
    Geschäftsführer
    1170 Bridge Pointe Lane
    Yorktown Heights
    FOREIGN New York 10598
    Usa
    American65094510001
    LAX, Craig Steven
    425 West End Avenue
    Apartment Pha
    New York
    100024
    United States
    Geschäftsführer
    425 West End Avenue
    Apartment Pha
    New York
    100024
    United States
    American108583790001
    MANUELE, Lisa Ann
    124 Todd Lane
    Briarcliff
    10510 New York
    United States Of America
    Geschäftsführer
    124 Todd Lane
    Briarcliff
    10510 New York
    United States Of America
    American96386590001
    MASTRANGELO, Ralph Michael
    781 Highwoods Drive
    FOREIGN Franklin Lakes
    New Jersey Nj 07417
    United States Of America
    Geschäftsführer
    781 Highwoods Drive
    FOREIGN Franklin Lakes
    New Jersey Nj 07417
    United States Of America
    United States87461580001
    MCELENEY, James C
    One Canada Square
    London
    E14 5AL
    Geschäftsführer
    One Canada Square
    London
    E14 5AL
    United KingdomUs Citizen167461590001
    MESERVE, John Donald
    56 Thomas Street
    4th Floor
    New York
    10013
    United States Of America
    Geschäftsführer
    56 Thomas Street
    4th Floor
    New York
    10013
    United States Of America
    American96226400001
    MILITELLO, Mark Stephen
    One Canada Square
    London
    E14 5AL
    Geschäftsführer
    One Canada Square
    London
    E14 5AL
    Hong KongBritish186920540001
    MOSE, Christopher
    One Canada Square
    London
    E14 5AL
    Geschäftsführer
    One Canada Square
    London
    E14 5AL
    United StatesUs Citizen175134480001
    PACILIO, Vincent Louis
    Flat 1
    89 Holland Park
    W11 3RZ London
    Geschäftsführer
    Flat 1
    89 Holland Park
    W11 3RZ London
    Us Citizen85259220001
    PACK, Carey Steven
    15 Troy Lane
    FOREIGN Short Hills
    New Jersey 07078
    United States Of America
    Geschäftsführer
    15 Troy Lane
    FOREIGN Short Hills
    New Jersey 07078
    United States Of America
    American126374230001
    RAPPOLD, Charles Edward
    1050 Rahway Road
    FOREIGN Plainfield
    New Jersey 07060
    United States Of America
    Geschäftsführer
    1050 Rahway Road
    FOREIGN Plainfield
    New Jersey 07060
    United States Of America
    American94138990001
    ROGAN, Brian Gerard
    9 Plum Beach Point Road
    Sands Point
    New York
    Ny 11050
    Usa
    Geschäftsführer
    9 Plum Beach Point Road
    Sands Point
    New York
    Ny 11050
    Usa
    American86277620001

    Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für BNY MELLON CAPITAL MARKETS EMEA LIMITED?

    Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss
    Benachrichtigt amAufgehört amErklärung
    07. Mai 2017Das Unternehmen weiß oder hat Grund zu der Annahme, dass es keine registrierungspflichtige Person oder registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen gibt.

    Hat BNY MELLON CAPITAL MARKETS EMEA LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 16. Okt. 2013
    Geliefert am 22. Okt. 2013
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • The Bank of New York Mellon
    Transaktionen
    • 22. Okt. 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 10. März 2020Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A security agreement
    Erstellt am 05. Feb. 2003
    Geliefert am 11. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All personal property and fixtures of the company or in which the company has an interest wherever located and whether now or hereafter existing or now owned or hereafter acquired and whether or nor subject to the uniform commercial code as in effect in the state of new york and also including all interest dividends and other distributions thereon paid and payable in cash or I property and all replacements and substitutions for and all accessions and additions to and all products and proceeds of all the foregoing.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Bank of New York
    Transaktionen
    • 11. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. März 2020Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A security agreement
    Erstellt am 05. Feb. 2003
    Geliefert am 11. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All personal property and fixtures of the company or in which the company has an interest wherever located and whether now or hereafter existing or now owned or hereafter exisiting or now owned or hereafter acquired and whether or not subject to the uniform commercial code as in effect in the state of new york;. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Bank of New York
    Transaktionen
    • 11. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. März 2020Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Security deed
    Erstellt am 15. Jan. 2003
    Geliefert am 05. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed charge over all sums and payments receivable by or for the account of the company by reason or in respect of any transfer or debit,stock from any stock account; all other rights and sums standing to the credit of the controlled accounts and all interest thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Citibank Na
    Transaktionen
    • 05. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. März 2020Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Supplement
    Erstellt am 15. Jan. 2003
    Geliefert am 05. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    First priority fixed right over all rights in respect of transactions cleared and all other rights in respect of certain cash accounts of the company with the bank; all sums receivable or agreement to transfer or debit,securities from any account. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Citibank,N.A.and Citibank International PLC
    Transaktionen
    • 05. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. März 2020Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Collateral agreement governing secured borrowings by participants in the euroclear system
    Erstellt am 20. Aug. 2001
    Geliefert am 24. Aug. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All amounts due or to become due from the company to the chargee referred to in section 2 of the collateral agreement being all borrowings (as defined) and other obligations in whatever form that relate t oor result from the company'' use of the euroclear system now outstanding or which may be outstanding at any time in the future to the chargee and to any other office of the chargee
    Kurze Angaben
    All "collateral". See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Euroclear Bank N.V./S.A.
    Transaktionen
    • 24. Aug. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. März 2020Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A supplement to a main clearing agreement
    Erstellt am 22. Feb. 2001
    Geliefert am 02. März 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to citibank international PLC and/or citibank, N.a pursuant to or in connection with (a) a master clearing agreement between the company and the bank (b) a tri-partite agreement between the company, cip and the london clearing house (c) the supplement (d) the crest settlement arrangements made between the company, cip or the bank (e) the rules of crest, the london stock exchange and the london clearing house in connection with the service (f) the bank's or cip's obligations to the london clearing house in connection with the service (g) any transactions effected by the company from time to time pursuant to the service (all terms as defined)
    Kurze Angaben
    The company granted a security interest by way of first priority fixed right of security over (a) all rights it has or may now or in the future have against cip in respect of transactions cleared or to be cleared by cip for the company (b) all rights it has or may have now or in the future in respect of certain cash accounts of the company with the bank (all terms as defined). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Citibank, N.a and Citibank International PLC
    Transaktionen
    • 02. März 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. März 2020Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Security deed
    Erstellt am 22. Feb. 2001
    Geliefert am 02. März 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company or any group company to the chargee under the facility agreement and/or the security deed or the making of any assured payment by the bank for the account of the company; or any transfer of stock to the company by means of crest; or any transfer of stock to the company by means of crest, whether the company is acting for itself or on behalf of a system-beneficiary (all terms as defined)
    Kurze Angaben
    By way of fixed charge all sums and payments at the date of the security deed and from time to time thereafter receivable by or for the account of the company by reason or in respect of any transfer or debit of, or agreement to transfer or debit, stock from any (eligible) stock account of or in the name of or otherwise referable to the company in crest or of any transfer by the company of its right title, or interest to or in stock represented or to be represented by any credit balance for the time being on any such stock account in crest, together with all rights and interests in such sums and payments (all terms as defined). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Citibank N.A.
    Transaktionen
    • 02. März 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. März 2020Erfüllung einer Belastung (MR04)

    Hat BNY MELLON CAPITAL MARKETS EMEA LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    26. Mai 2020Beginn der Liquidation
    02. Nov. 2021Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Matthew Robert Haw
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    Praktiker
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    Karen Ann Spears
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    Praktiker
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0