PIPELINE INTEGRITY INTERNATIONAL LIMITED
Überblick
Unternehmensname | PIPELINE INTEGRITY INTERNATIONAL LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 03770078 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von PIPELINE INTEGRITY INTERNATIONAL LIMITED?
- (9305) /
Wo befindet sich PIPELINE INTEGRITY INTERNATIONAL LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 1 More London Place SE1 2AF London |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von PIPELINE INTEGRITY INTERNATIONAL LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
PII CONTRACTS LIMITED | 13. Mai 1999 | 13. Mai 1999 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PIPELINE INTEGRITY INTERNATIONAL LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2009 |
Welche sind die letzten Einreichungen für PIPELINE INTEGRITY INTERNATIONAL LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 6 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde vom Webber House 26-28 Market Street Altrincham Cheshire WA14 1PF geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Oakwood Corporate Secretary Limited als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 4 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Ian Hornby als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Atley Way North Nelson Industrial Estate Cramlington Northumberland NE23 1WW am 11. Jan. 2011 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 13. Mai 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Michael Bellamy als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von John Bucci als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Marco Renato Bruno Paparoni am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Adam Bathgate am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für John Vincent Bucci am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Ian Hornby am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Alasdair Murray Campbell Sloan am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||
Ernennung von Oakwood Corporate Secretary Limited als Sekretär | 3 Seiten | AP04 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von A G Secretarial Limited als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von PIPELINE INTEGRITY INTERNATIONAL LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATHGATE, Adam | Geschäftsführer | North Nelson Industrial Estate NE23 1WW Cramlington Atley Way Northumberland United Kingdom | United Kingdom | British | Regional Manager | 124847880001 | ||||||||
BELLAMY, Michael | Geschäftsführer | North Nelson Industrial Estate NE23 1WW Cramlington Atley Way Northumberland | United Kingdom | British | General Manager | 76315930001 | ||||||||
PAPARONI, Marco Renato Bruno | Geschäftsführer | North Nelson Industrial Estate NE23 1WW Cramlington Atley Way Northumberland United Kingdom | Italian | Chief Financial Officer | 133714660001 | |||||||||
SLOAN, Alasdair Murray Campbell | Geschäftsführer | North Nelson Industrial Estate NE23 1WW Cramlington Atley Way Northumberland United Kingdom | British | Chartered Accountant | 61524540004 | |||||||||
CONE, Harry Douglas | Sekretär | 5 The Orchard Hepscott NE61 6HT Morpeth Northumberland | British | 796210001 | ||||||||||
HARRISON, Irene Lesley | Bevollmächtigter Sekretär | Fy Mwthin 22 Merthyr Road Tongwynlais CF15 7LH Cardiff South Glamorgan | British | 900003790001 | ||||||||||
HIGGINS, Caroline Patricia | Sekretär | 24 Mayfield Road Gosforth NE3 4HE Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | 32519770002 | ||||||||||
A G SECRETARIAL LIMITED | Sekretär | 100 Barbirolli Square M2 3AB Manchester | 90084920001 | |||||||||||
CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED | Sekretär | 10 Upper Bank Street E14 5JJ London | 38508390004 | |||||||||||
OAKWOOD CORPORATE SECRETARY LIMITED | Sekretär | 26-28 Market Street WA14 1PF Altrincham Webber House Cheshire |
| 146358090001 | ||||||||||
ACKHURST, Trent Braden | Geschäftsführer | Hollyhurst Hepscott NE61 6LX Morpeth Northumberland | United Kingdom | British | Product Manager | 120742460001 | ||||||||
BERGER, Christopher Carl | Geschäftsführer | 56 Percy Park NE30 4JX Tynemouth Tyne & Wear | American | Global Technology Director | 122240370001 | |||||||||
BUCCI, John Vincent | Geschäftsführer | North Nelson Industrial Estate NE23 1WW Cramlington Atley Way Northumberland United Kingdom | American | Director | 124762710001 | |||||||||
CARTLEDGE, Andrew | Geschäftsführer | 30 Trailside Road MA 02493 Weston United States | British | Director | 70072110003 | |||||||||
CHRISTIE, Roderick Angus | Geschäftsführer | 14 Oakfield Road SL8 5QN Bourne End Buckinghamshire | British | General Manager Energy Service | 82543780001 | |||||||||
CLARK, Alyson Margaret | Geschäftsführer | 13 Heron's Place TW7 7BE Old Isleworth Middlesex | United Kingdom | British | Legal Counsel | 56868460002 | ||||||||
DANIELL, Paul Nigel | Geschäftsführer | 7 Lucerne Drive Stadhampton OX44 7QT Oxford Oxfordshire | British | Human Resources Manager | 62463920001 | |||||||||
DIGBY, Mark Damien | Geschäftsführer | Calle Valle Del Roncal 71, Las Lomas 28660 Boadilla Del Monte Madrid Spain | Irish | Europe Operations Manager | 103125610001 | |||||||||
GRAHAM, William | Geschäftsführer | The Coach House Shortridge Hall NE64 0XU Warkworth Northumberland | British | Director | 59156580005 | |||||||||
HORNBY, Ian | Geschäftsführer | North Nelson Industrial Estate NE23 1WW Cramlington Atley Way Northumberland United Kingdom | United Kingdom | British | Legal Counsel | 130519940001 | ||||||||
JACOB, Frances Carol | Geschäftsführer | 11 Augustus Court Augustus Road Southfields SW19 6NA London | British | Fund Manager | 38154840001 | |||||||||
KEENAN, John Joseph | Geschäftsführer | 5 Gresham Road CM14 4HN Brentwood Essex | British | Uk Controller Ge Energy | 106985300001 | |||||||||
LITTLE, Daniel Stephen Paul | Geschäftsführer | 48 Chester Road Poynton SK12 1HA Stockport Cheshire | England | British | Chartered Accountant | 229666930001 | ||||||||
MANN, Cynthia Kay | Geschäftsführer | 5302 Cambridge Sugar Land Texas United States | American | Attorney | 122240470001 | |||||||||
MULHOLLAND, Diarmaid Patrick | Geschäftsführer | Largo Zandonai 4 FOREIGN Milan 20145 Italy | Italy | Irish | Sales Engineer | 116288460001 | ||||||||
POULIQUEN, Patrick | Geschäftsführer | 17 Rue Leon Deubel Belfort F 9000 France | French | Director | 82626990001 | |||||||||
POWELL, Michael Anthony | Geschäftsführer | 31 Love Lane Pandon Quays NE1 3DW Newcastle Upon Tyne | British | Director | 57278520004 | |||||||||
ROGERSON, Philip Graham | Geschäftsführer | 56 Vogans Mill Mill Street SE1 2BZ London | British | Director | 93942500001 | |||||||||
SIMMONS, Michael James | Geschäftsführer | 405 Bunker Hill 77024 Houston Texas United States | American | Director | 97716420003 | |||||||||
TON, Gwaine William | Geschäftsführer | Beech Hill Lodge Ridgemead Road, Englefield Green TW20 0YD Egham Surrey | American | Company Director | 93302530001 | |||||||||
WAKE, Hilary Anne, Mrs. | Geschäftsführer | The Coach House Bridge Farm Newland DN14 7XD Eastrington | United Kingdom | British | Tax Manager | 96648390001 | ||||||||
BUSINESS INFORMATION RESEARCH & REPORTING LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Crown House 64 Whitchurch Road CF14 3LX Cardiff | 900005500001 |
Hat PIPELINE INTEGRITY INTERNATIONAL LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Guarantee and debenture | Erstellt am 24. Nov. 1999 Geliefert am 07. Dez. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the senior finance documents | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat PIPELINE INTEGRITY INTERNATIONAL LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0