PENNANT SOFTWARE SERVICES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | PENNANT SOFTWARE SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03772667 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von PENNANT SOFTWARE SERVICES LIMITED?
- Entwicklung von Geschäfts- und Haushaltssoftware (62012) / Information und Kommunikation
Wo befindet sich PENNANT SOFTWARE SERVICES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Pennant Court Staverton Technology Park GL51 6TL Cheltenham Gloucestershire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von PENNANT SOFTWARE SERVICES LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| PENNANT INFORMATION SERVICES LIMITED | 21. Jan. 2000 | 21. Jan. 2000 |
| SOLVERA INFORMATION SERVICES (DOCUMENTATION) LIMITED | 28. Juli 1999 | 28. Juli 1999 |
| PRECIS (1761) LIMITED | 18. Mai 1999 | 18. Mai 1999 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PENNANT SOFTWARE SERVICES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2017 |
Welche sind die letzten Einreichungen für PENNANT SOFTWARE SERVICES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Gary Robert Barnes als Geschäftsführer am 21. Nov. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 18. Mai 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Christopher Charles Powell als Geschäftsführer am 03. Mai 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Timothy Julian Rice als Geschäftsführer am 24. Sept. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 18. Mai 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Gary Robert Barnes als Direktor am 01. Apr. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 26 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr David Joseph Clements als Direktor am 12. Okt. 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr David Joseph Clements als Sekretär am 15. Juni 2017 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Philip Henry Walker als Sekretär am 15. Juni 2017 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Mr Timothy Julian Rice als Direktor am 05. Juni 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Simon Alick Moore als Direktor am 05. Juni 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 18. Mai 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Christopher Snook als Geschäftsführer am 29. März 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 25 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 18. Mai 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 25 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 18. Mai 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 27 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Philip Henry Walker als Sekretär am 03. Nov. 2014 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Ernennung von Mr Philip Henry Walker als Direktor am 03. Nov. 2014 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von John Mark Waller als Geschäftsführer am 03. Nov. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von PENNANT SOFTWARE SERVICES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLEMENTS, David Joseph | Sekretär | Pennant Court Staverton Technology Park GL51 6TL Cheltenham Gloucestershire | 233687120001 | |||||||
| CLEMENTS, David Joseph | Geschäftsführer | Pennant Court Staverton Technology Park GL51 6TL Cheltenham Gloucestershire | England | British | 200768970001 | |||||
| MOORE, Simon Alick | Geschäftsführer | Pennant Court Staverton Technology Park GL51 6TL Cheltenham Gloucestershire | England | British | 169812620001 | |||||
| WALKER, Philip Henry | Geschäftsführer | Pennant Court Staverton Technology Park GL51 6TL Cheltenham Gloucestershire | England | British | 192548770001 | |||||
| WALKER, Philip Henry | Sekretär | Pennant Court Staverton Technology Park GL51 6TL Cheltenham Gloucestershire | 192552730001 | |||||||
| WALLER, John Mark | Sekretär | Pennant Court Staverton Technology Park GL51 6TL Cheltenham Gloucestershire | British | 8778550002 | ||||||
| WEST, James Crawshaw | Sekretär | 103 Lower Road SL9 8JZ Gerrards Cross Buckinghamshire | British | 29331030001 | ||||||
| OFFICE ORGANIZATION & SERVICES LIMITED | Sekretär | Level 1 Exchange House Primrose Street EC2A 2HS London | 2519400001 | |||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| BARNES, Gary Robert | Geschäftsführer | Pennant Court Staverton Technology Park GL51 6TL Cheltenham Gloucestershire | England | British | 244815210001 | |||||
| BARNETT, Calvin Stuart | Geschäftsführer | 3 The Firs Stockbridge Road SO20 5BD Winchester Hampshire | England | British | 65673400001 | |||||
| DENHOLM, Ian Thomas | Geschäftsführer | 4 Sunset Road Totton SO40 3JU Southampton Hampshire | British | 68340880002 | ||||||
| DENHOLM, Ian Thomas | Geschäftsführer | The Old School Hemp Lane Wigginton HP23 6HF Tring Hertfordshire | British | 68340880001 | ||||||
| JEROME, David Leslie | Geschäftsführer | 34 Collington Crescent PO6 4BH Portsmouth Hampshire | British | 61080770001 | ||||||
| JEROME, David Leslie | Geschäftsführer | 34 Collington Crescent PO6 4BH Portsmouth Hampshire | British | 61080770001 | ||||||
| PENFOLD, Diane June | Geschäftsführer | 43 Eagle Court Hermon Hill E11 1PD London | United Kingdom | British | 59962430002 | |||||
| POWELL, Christopher Charles | Geschäftsführer | Pennant Court Staverton Technology Park GL51 6TL Cheltenham Gloucestershire | England | British | 264658290001 | |||||
| RICE, Timothy Julian | Geschäftsführer | Pennant Court Staverton Technology Park GL51 6TL Cheltenham Gloucestershire | England | British | 219666070001 | |||||
| SNOOK, Christopher | Geschäftsführer | Avalon 14 Whiteway View Stratton GL7 2HY Cirencester Gloucestershire | England | British | 81547090001 | |||||
| THOMPSON, Joseph John James | Geschäftsführer | Underhill House Gretton GL54 5DA Cheltenham Gloucestershire | British | 43146240001 | ||||||
| WALLER, John Mark | Geschäftsführer | Farriers House Naseby Road Thornby NN6 8SW Northampton Northamptonshire | England | British | 8778550002 | |||||
| WILSON, Clare Alice | Geschäftsführer | 75 Ifield Road SW10 9AU London | British | 47611200001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei PENNANT SOFTWARE SERVICES LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pennant International Group Plc | 06. Apr. 2016 | Herrick Close Staverton Technology Park, Staverton GL51 6TL Cheltenham Pennant Court England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat PENNANT SOFTWARE SERVICES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Charge of intellectual property | Erstellt am 26. März 2003 Geliefert am 04. Apr. 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All rights,title and interest in and to the intellectual property rights excluding third party rights and all materials; the right to commence proceedings and/or receive and recover damages and all plant,machinery and equipment thereon; all book and other debts from time to time due to the company; first floating charge over the remaining undertaking,assets and business and all other rights,assets and property; see form 395 for details. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 13. Feb. 2002 Geliefert am 19. Feb. 2002 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H properties 2-10 cawte road 210-214 shirley road 1, 3, 5, 7 and 9 paynes road and land adjoining t/nos: HP154515 HP586655 HP518278 HP111751 HP428299 HP397993 HP238161 HP320808. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 21. Dez. 1999 Geliefert am 23. Dez. 1999 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 10. Aug. 1999 Geliefert am 14. Aug. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 06. Aug. 1999 Geliefert am 23. Aug. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 3 of the hive down agreement dated 6 august 1999 | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 06. Aug. 1999 Geliefert am 14. Aug. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0