RENAISSANCE FILMS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameRENAISSANCE FILMS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03772745
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von RENAISSANCE FILMS LIMITED?

    • (9211) /

    Wo befindet sich RENAISSANCE FILMS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    1 Kings Avenue
    Winchmore Hill
    N21 3NA London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von RENAISSANCE FILMS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    BLEAKLAND LIMITED18. Mai 199918. Mai 1999

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von RENAISSANCE FILMS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2003

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für RENAISSANCE FILMS LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für RENAISSANCE FILMS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    4 Seiten4.72

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 25. Juli 2014

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 25. Jan. 2014

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 25. Juli 2013

    5 Seiten4.68

    Insolvenzmeldung

    Insolvency:secretary of state's certificate of release of liquidator
    1 SeitenLIQ MISC

    Insolvenzmeldung

    Insolvency:order of court appointing ninos koumettou as liquidator of the company
    5 SeitenLIQ MISC

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 25. Jan. 2013

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 25. Juli 2012

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 25. Jan. 2012

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 25. Juli 2011

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 25. Jan. 2011

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 25. Juli 2010

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 25. Jan. 2010

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 25. Juli 2009

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 25. Jan. 2009

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 25. Juli 2008

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren

    5 Seiten4.68

    legacy

    1 Seiten288b

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren

    5 Seiten4.68

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    4 Seiten2.34B

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    1 Seiten288b

    Vermögensübersicht

    6 Seiten2.16B

    Wer sind die Geschäftsführer von RENAISSANCE FILMS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BLOYE, Charles James
    3 Durand Gardens
    SW9 0PS London
    Sekretär
    3 Durand Gardens
    SW9 0PS London
    British69540670001
    SHEEHAN, Anne Mary
    Flat 2
    10 St Quintin Avenue
    W10 6NU London
    Sekretär
    Flat 2
    10 St Quintin Avenue
    W10 6NU London
    British,Irish190395430001
    TAYLOR, Caroline Burnett
    6 Tasman Road
    Stockwell
    SW9 9LT London
    Sekretär
    6 Tasman Road
    Stockwell
    SW9 9LT London
    British97126820001
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Bevollmächtigter Sekretär
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004100001
    BLOYE, Charles James
    3 Durand Gardens
    SW9 0PS London
    Geschäftsführer
    3 Durand Gardens
    SW9 0PS London
    British69540670001
    BROOKE, Christopher Roger Ettrick
    Watermeadow
    Swarraton
    SO24 9TQ Alresford
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Watermeadow
    Swarraton
    SO24 9TQ Alresford
    Hampshire
    UkBritish44560390001
    CHAMBERS, Antony Craven
    The Lake House
    SO24 9DB Alresford
    Hampshire
    Geschäftsführer
    The Lake House
    SO24 9DB Alresford
    Hampshire
    United KingdomBritish94516690001
    EVANS, Stephen Anthony
    Flat E
    58 Eaton Square
    SW1W 9BG London
    Geschäftsführer
    Flat E
    58 Eaton Square
    SW1W 9BG London
    United KingdomBritish114331730002
    FINNEY, Angus Hugh
    Flat 15
    2 Weymouth Street
    W1W 5BT London
    Geschäftsführer
    Flat 15
    2 Weymouth Street
    W1W 5BT London
    British84180470003
    FLINT, Michael Frederick
    Green Lane House
    Castle Green
    IP12 2NF Orford
    Suffolk
    Geschäftsführer
    Green Lane House
    Castle Green
    IP12 2NF Orford
    Suffolk
    EnglandBritish36888110003
    PADGETT, Robert Alan
    74 Chilton Road
    Long Crendon
    HP18 9DA Aylesbury
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    74 Chilton Road
    Long Crendon
    HP18 9DA Aylesbury
    Buckinghamshire
    British2118350004
    SHEEHAN, Anne Mary
    Flat 2
    10 St Quintin Avenue
    W10 6NU London
    Geschäftsführer
    Flat 2
    10 St Quintin Avenue
    W10 6NU London
    United KingdomBritish,Irish190395430001
    STEPHENS, William Ramsay
    18 Sherwoods Road
    WD19 4AZ Watford
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    18 Sherwoods Road
    WD19 4AZ Watford
    Hertfordshire
    United KingdomBritish85048290002
    WOOD, Caroline Sarah
    11 Burnley Road
    SW9 0SH London
    Geschäftsführer
    11 Burnley Road
    SW9 0SH London
    British49654410001
    HALLMARK REGISTRARS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004090001

    Hat RENAISSANCE FILMS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Deed of charge
    Erstellt am 24. Feb. 2003
    Geliefert am 14. März 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed charge over all right,title and interest in and to all copies of the film ("the safety of objects") and any music and/or sound recordings or other works produced thereon; all other rights,properties and all proceeds owed and payable including all income and receipts,revenues from book debts,etc; floating charge over over all rights,title and interest; see form 395 for details. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Vulcan Productions Inc.(Formerly Clear Blue Sky Productions Inc)
    Transaktionen
    • 14. März 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of charge over credit balances
    Erstellt am 06. Apr. 2000
    Geliefert am 12. Apr. 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from renaissance luzhin limited to the chargee on any account whatsoever provided th the total sum recoverable under the security shall not exceed the amount of the deposit(s) together with all interest for the time being accrued thereon.
    Kurze Angaben
    Barclays bank PLC re renaissance films limited business premium account number 40123560. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Apr. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    A charge and deed of assignment in respect of "the luzhin defense" (the "film") between renaissance luzhin LTD (1) renaissance films limited (2) renaissance international limited (3) (together with 1 and 2 the "chargor") and societe generale,london branch (the "chargee")
    Erstellt am 05. Apr. 2000
    Geliefert am 14. Apr. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The benefit of the first acquisition agreement and the pledge and assignment as further security for repayment of the loan by the chargor and all other monies from time to time owing to the chargee under the loan agreement
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge all of the chargor's right title and interest to the extent thereof (whether now owned or hereinafter acquired) in and to the following in relation to the film and all collateral,allied,ancillary and subsidiary rights therein and all properties and things of value pertaining thereto.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Societe Generale (London Branch)
    Transaktionen
    • 14. Apr. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Juli 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of deposit
    Erstellt am 12. Okt. 1999
    Geliefert am 19. Okt. 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £11,500 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    The sum of £11,500 deposited at the royal bank of scotland.
    Berechtigte Personen
    • Marsa Holdings Limited
    Transaktionen
    • 19. Okt. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 01. Juli 1999
    Geliefert am 14. Juli 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a loan facility agreement of even date
    Kurze Angaben
    The keyman insurance policy numbers 3442146 and 3442273 issued by the canada life assurance company on the life of mr stephen evans in the amounts of £2,500,000 and £7,500,000, stephen evans' personal accident insurance policy the sum of £10,000,000 for the first 36 months and £7,500,000 for a further 24 months, the keyman insurance policy numbers 086373H and 0863733G issued by national westminster life assurance on the life of mr angus finney in the amounts of £3,770,000 and £1,250,000 together with. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Britel Fund Nominees Limited and Possfund Nominees Limited
    Transaktionen
    • 14. Juli 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Mai 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat RENAISSANCE FILMS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    22. Juli 2005Beginn der Verwaltung
    26. Juli 2006Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Chris M Iacovides
    Jeffreys Henry Jacobs
    Fergusson House
    EC1V 2NJ 124-128 City Road
    London
    Praktiker
    Jeffreys Henry Jacobs
    Fergusson House
    EC1V 2NJ 124-128 City Road
    London
    2
    DatumTyp
    26. Juli 2006Beginn der Liquidation
    04. Feb. 2015Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Chris M Iacovides
    Alexander Lawson Jacobs
    1 Kings Avenue
    Winchmore Hill
    London N21 3na
    Praktiker
    Alexander Lawson Jacobs
    1 Kings Avenue
    Winchmore Hill
    London N21 3na
    Ninos Koumettou
    Alexander Lawson & Co
    1 Kings Avenue
    N21 3NA Winchmore Hill
    London
    Praktiker
    Alexander Lawson & Co
    1 Kings Avenue
    N21 3NA Winchmore Hill
    London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0