EASTER INVESTMENTS SEVEN LIMITED

EASTER INVESTMENTS SEVEN LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameEASTER INVESTMENTS SEVEN LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03776842
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von EASTER INVESTMENTS SEVEN LIMITED?

    • (7020) /

    Wo befindet sich EASTER INVESTMENTS SEVEN LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Griffins Tavistock House South
    Tavistock Square
    WC1H 9LG London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von EASTER INVESTMENTS SEVEN LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    DRAYPARCS (TIPTON) LIMITED10. Sept. 199910. Sept. 1999
    FORAY 1221 LIMITED25. Mai 199925. Mai 1999

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von EASTER INVESTMENTS SEVEN LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2008

    Welche sind die letzten Einreichungen für EASTER INVESTMENTS SEVEN LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Dez. 2011

    5 Seiten4.68

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    3 Seiten4.71

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Juli 2011

    5 Seiten4.68

    Ernennung von Mrs Nicola Louise Lenthall als Sekretär

    1 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Stephen Corner als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Jan. 2011

    5 Seiten4.68

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 18 Buckingham Gate London SW1E 6LB am 08. Feb. 2010

    1 SeitenAD01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 21. Jan. 2010

    LRESSP

    Beendigung der Bestellung von Jolyon Moss als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2008

    14 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    2 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2007

    15 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten363a

    legacy

    10 Seiten155(6)a

    legacy

    10 Seiten155(6)a

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Gewährung finanzieller Unterstützung für den Erwerb von Aktien

    RES07

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    4 Seiten395

    Wer sind die Geschäftsführer von EASTER INVESTMENTS SEVEN LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    LENTHALL, Nicola Louise
    Tavistock Square
    WC1H 9LG London
    Griffins Tavistock House South
    Sekretär
    Tavistock Square
    WC1H 9LG London
    Griffins Tavistock House South
    157987770001
    TAYLOR, Peter
    Seymour House
    High Street
    GL55 6AG Chipping Campden
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    Seymour House
    High Street
    GL55 6AG Chipping Campden
    Gloucestershire
    EnglandBritishChartered Surveyor109810150001
    CLARKE, Joanna Lindsey
    10 Gordon Road
    Harborne
    B17 9HB Birmingham
    West Midlands
    Sekretär
    10 Gordon Road
    Harborne
    B17 9HB Birmingham
    West Midlands
    BritishSolicitor68391410001
    CORNER, Stephen Donald
    57 Mayfield Avenue
    BR6 0AJ Orpington
    Kent
    Sekretär
    57 Mayfield Avenue
    BR6 0AJ Orpington
    Kent
    BritishCompany Secretary85743480001
    MIDDLETON, Trevor
    High House
    Old Warwick Road
    CV35 7AA Rowington
    Warwickshire
    Sekretär
    High House
    Old Warwick Road
    CV35 7AA Rowington
    Warwickshire
    BritishCompany Director221486370001
    CLARKE, Joanna Lindsey
    10 Gordon Road
    Harborne
    B17 9HB Birmingham
    West Midlands
    Geschäftsführer
    10 Gordon Road
    Harborne
    B17 9HB Birmingham
    West Midlands
    BritishSolicitor68391410001
    FISHER, Jacqueline
    926 Kingstanding Road
    B44 9NG Birmingham
    West Midlands
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    926 Kingstanding Road
    B44 9NG Birmingham
    West Midlands
    British900013260001
    GROVE, David Leslie
    Badgers Holt, Rookery Lane
    Lowsonford
    B95 5EP Solihull
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Badgers Holt, Rookery Lane
    Lowsonford
    B95 5EP Solihull
    West Midlands
    EnglandBritishDirector4174280001
    JONES, Colin Stuart Goodman
    36 Whinchat Grove
    DY10 4TJ Kidderminster
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    36 Whinchat Grove
    DY10 4TJ Kidderminster
    Worcestershire
    BritishSurveyor13002560001
    LITWINOWICZ, Leszek Richard
    72 Rosemary Hill Road
    Streetly
    B74 4HJ Sutton Coldfield
    West Midlands
    Geschäftsführer
    72 Rosemary Hill Road
    Streetly
    B74 4HJ Sutton Coldfield
    West Midlands
    EnglandBritishDirector70815770002
    MIDDLETON, Trevor
    High House
    Old Warwick Road
    CV35 7AA Rowington
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    High House
    Old Warwick Road
    CV35 7AA Rowington
    Warwickshire
    EnglandBritishCompany Director221486370001
    MOSS, Jolyon Francis Robert
    14 Kempson Road
    SW6 4PU London
    Geschäftsführer
    14 Kempson Road
    SW6 4PU London
    EnglandBritishProperty Financier14910070001
    SNOOK, John Thomas
    The Oaks Tag Lane
    Hare Hatch
    RG10 7ST Wargrave
    Berkshire
    Geschäftsführer
    The Oaks Tag Lane
    Hare Hatch
    RG10 7ST Wargrave
    Berkshire
    United KingdomBritishCompany Director29421120003

    Hat EASTER INVESTMENTS SEVEN LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 11. Dez. 2006
    Geliefert am 20. Dez. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property being eagle works eagle industrial estate bagnall street golds hill tipton t/n SF108557,. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 20. Dez. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Jan. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 11. Dez. 2006
    Geliefert am 20. Dez. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 20. Dez. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Jan. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 01. Juli 2005
    Geliefert am 22. Juli 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H eagle industrial estate bagnall street great bridge tipton west midlands t/n SF108557. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for the Secured Parties
    Transaktionen
    • 22. Juli 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Dez. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 27. Feb. 2004
    Geliefert am 09. März 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H eagle industrial estate tipton t/n SF108557. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 09. März 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Juli 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment of rental income
    Erstellt am 27. Feb. 2004
    Geliefert am 09. März 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    First fixed charge the assets and first priority assignment all rights under or in relation to the rental income and all claims of any description relating to them. Undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 09. März 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Juli 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 27. Feb. 2004
    Geliefert am 09. März 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 09. März 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Juli 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 16. Aug. 1999
    Geliefert am 02. Sept. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Close Securities Limited
    Transaktionen
    • 02. Sept. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Apr. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 30. Juli 1999
    Geliefert am 03. Aug. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Eagle works bagnall works bagnall street golds hill west bromwich west midlands t/no: SF108557. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Aug. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat EASTER INVESTMENTS SEVEN LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    21. Jan. 2010Beginn der Liquidation
    29. März 2012Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Kevin Ashley Goldfarb
    Griffins
    Tavistock House South
    WC1H 9LG Tavistock Square
    London
    Praktiker
    Griffins
    Tavistock House South
    WC1H 9LG Tavistock Square
    London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0