SPECIFIED AIR SOLUTIONS HOLDINGS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | SPECIFIED AIR SOLUTIONS HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03779938 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von SPECIFIED AIR SOLUTIONS HOLDINGS LIMITED?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich SPECIFIED AIR SOLUTIONS HOLDINGS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 25 Canada Square Level 37 Canary Wharf E14 5LQ London England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von SPECIFIED AIR SOLUTIONS HOLDINGS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| ROBERTS-GORDON HOLDINGS LIMITED | 16. Aug. 1999 | 16. Aug. 1999 |
| BONDCO 724 LIMITED | 28. Mai 1999 | 28. Mai 1999 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SPECIFIED AIR SOLUTIONS HOLDINGS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2017 |
Welche sind die letzten Einreichungen für SPECIFIED AIR SOLUTIONS HOLDINGS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 28. Mai 2019 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Benjamin Thomas Rogers als Direktor am 23. Mai 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von David Raymond Janicek als Direktor am 23. Mai 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Steven Allan Dykman als Geschäftsführer am 23. Mai 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Charles Merrill Brown als Geschäftsführer am 23. Mai 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 40 Bank Street Level 29 London E14 5DS England zum 25 Canada Square Level 37 Canary Wharf London E14 5LQ am 03. Aug. 2018 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Richard William Swift als Sekretär am 25. Juli 2018 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Richard William Swift als Geschäftsführer am 25. Juli 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Unit 20 Red Mill Trading Estate Rigby Street Wednesbury WS10 0NP England zum 40 Bank Street Level 29 London E14 5DS am 10. Juli 2018 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 28. Mai 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Steven Allan Dykman als Direktor am 25. Jan. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Charles Merrill Brown als Direktor am 25. Jan. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Richard Jasiura als Geschäftsführer am 25. Jan. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 22 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 28. Mai 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Unit a Kings Hill Business Park Darlaston Road Wednesbury West Midlands WS10 7SH zum Unit 20 Red Mill Trading Estate Rigby Street Wednesbury WS10 0NP am 18. Okt. 2016 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 19 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Mai 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Mai 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von SPECIFIED AIR SOLUTIONS HOLDINGS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANICEK, David Raymond | Geschäftsführer | Level 37 Canary Wharf E14 5LQ London 25 Canada Square England | United States | American | 242982720001 | |||||
| ROGERS, Benjamin Thomas | Geschäftsführer | Level 37 Canary Wharf E14 5LQ London 25 Canada Square England | United States | American | 259420670001 | |||||
| SWIFT, Richard William | Sekretär | Bank Street Level 29 E14 5DS London 40 England | British | 75152300001 | ||||||
| VEAR, Heather | Sekretär | 5 Pinehurst Court Bassett Row SO16 7FT Southampton Hampshire | British | 49172370001 | ||||||
| WOZNIAK, Peter Boleslaw | Sekretär | 41 Meadowvale Road Lickey End B60 1JY Bromsgrove Worcestershire | British | 6509000002 | ||||||
| BONDLAW SECRETARIES LIMITED | Sekretär | 22 Kings Park Road SO15 2UF Southampton Hampshire | 59771390002 | |||||||
| BONDLAW SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 39/49 Commercial Road SO15 1GA Southampton Hampshire | 900018010001 | |||||||
| ARLISS, Jeremy Herbert | Geschäftsführer | 4 Randall Road Chandlers Ford SO53 5AL Eastleigh Hampshire | British | 3170690001 | ||||||
| BROWN, Charles Merrill | Geschäftsführer | William Street NY 14206 Buffalo 1250 New York United States | United States | American | 243608540001 | |||||
| DINES, Mark | Geschäftsführer | 6411 Lakemore Court G Amheist New York 1451 Usa | Usa | United States | 69721550001 | |||||
| DINES, Paul | Geschäftsführer | 6372 Woodland Drive Eiamherst 14051 New York Usa | Usa | United States | 38981290001 | |||||
| DYKMAN, Steven Allan | Geschäftsführer | William Street NY 14206 Buffalo 1250 New York United States | United States | American | 244241080001 | |||||
| JASIURA, Richard | Geschäftsführer | 26 Birdsong Parkway Orchard Park New York 14127 Usa | United States | American | 69730240001 | |||||
| OAKLEY, Damien John | Geschäftsführer | 5 Aldwick Gardens PO21 3QT Bognor Regis West Sussex | United Kingdom | British | 50062460001 | |||||
| SWIFT, Richard William | Geschäftsführer | Bank Street Level 29 E14 5DS London 40 England | England | British | 75152300002 | |||||
| VEAR, Heather | Geschäftsführer | 5 Pinehurst Court Bassett Row SO16 7FT Southampton Hampshire | British | 49172370001 | ||||||
| WOZNIAK, Peter Boleslaw | Geschäftsführer | 41 Meadowvale Road Lickey End B60 1JY Bromsgrove Worcestershire | British | 6509000002 | ||||||
| YATES, Alan | Geschäftsführer | 20 Halesfield Hindley, Hindley Green WN2 4WX Wigan | British | 94078260001 | ||||||
| BONDLAW DIRECTORS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 39-49 Commercial Road SO15 1GA Southampton Hampshire | 900018000001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei SPECIFIED AIR SOLUTIONS HOLDINGS LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sas Llc | 01. Juli 2016 | William Street 14240-0044 PO BOX 44 Buffalo 1250 United States | Nein | ||||
| |||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||
Hat SPECIFIED AIR SOLUTIONS HOLDINGS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Share charge | Erstellt am 01. März 2012 Geliefert am 20. März 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each credit party from time to time owed to the agents (including former agents), the lenders or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of first fixed charge, the securities being 46B ordinary shares of £1 each in the capital of heater wholeslae limited being all the b ordinary shares of £1 each owned by the chargor in the capital of heaters wholesale limited see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Share charge | Erstellt am 01. März 2012 Geliefert am 20. März 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any borrower to the lenders or chargee or to any other direct or indirect subsidiary or affiliate of agent or any lender on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of first fixed charge, the securities being 46B ordinary shares of £1 each in the capital of heater wholeslae limited being all the b ordinary shares of £1 each owned by the chargor in the capital of heaters wholesale limited. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debentures | Erstellt am 20. Apr. 2011 Geliefert am 07. Mai 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each credit party to the agents (including former agents) the lenders or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 20. Apr. 2011 Geliefert am 07. Mai 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any borrower to the lenders or chargee or to any other direct or indirect subsidiary or affiliate of agent or any lender on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over shares | Erstellt am 30. Sept. 2010 Geliefert am 06. Okt. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben 65 ordinary shares of £1 each in the capital of dale heating services (U.K.) limited. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over shares | Erstellt am 30. Sept. 2010 Geliefert am 06. Okt. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben 166 ordinary shares of £1 each and 30 ordinary b shares of £1 each in the capital of heaters wholesale limited. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Share charge | Erstellt am 01. Okt. 2007 Geliefert am 17. Okt. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All interest in and to all of the secured property being the shares and all stock, shares, warrants, securities, rights, moneys or property, including the dividends, interest or income thereon. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 01. Okt. 2007 Geliefert am 10. Okt. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the borrower to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All rents and deposits relating to the properties all goodwill all the equipment all the investments. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Share charge | Erstellt am 28. Sept. 2006 Geliefert am 11. Okt. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Shares and all stock shares warrants securities rights moneys or property (including the dividends, interest or income thereon or arising therefrom). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 27. Sept. 2006 Geliefert am 12. Okt. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Share charge | Erstellt am 24. Jan. 2005 Geliefert am 04. Feb. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All interest in and to all the secured property being the shares and all stock shares warrants securities rights monies or property (including the dividends interest or income thereon or arising therefrom). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Share charge | Erstellt am 20. Juni 2000 Geliefert am 21. Juni 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag And the aggregate obligations (as defined in an amended and restated credit agreement dated 23 february 1999) and all other sums due from the company to the chargee under or pursuant to the share charge | |
Kurze Angaben All interest in and to all of the secured property and all stock,warrants,securities,rights,monies,property,dividends thereon. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 05. Aug. 1999 Geliefert am 13. Aug. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0