ISOFT OVERSEAS HOLDINGS LIMITED

ISOFT OVERSEAS HOLDINGS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameISOFT OVERSEAS HOLDINGS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03782295
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von ISOFT OVERSEAS HOLDINGS LIMITED?

    • Tätigkeit anderer Holdinggesellschaften n.n.a. (64209) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen

    Wo befindet sich ISOFT OVERSEAS HOLDINGS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Royal Pavilion
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Hampshire
    United Kingdom
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von ISOFT OVERSEAS HOLDINGS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    ISOFT.COM PLC28. Mai 199928. Mai 1999

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ISOFT OVERSEAS HOLDINGS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2012

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für ISOFT OVERSEAS HOLDINGS LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für ISOFT OVERSEAS HOLDINGS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 31. März 2013 bis 30. Sept. 2013

    3 SeitenAA01

    Beendigung der Bestellung von Andrew James Edward Thomson als Geschäftsführer am 30. Aug. 2013

    2 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 06. Juli 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital02. Aug. 2013

    Kapitalaufstellung am 02. Aug. 2013

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Kapitalaufstellung am 24. Juni 2013

    • Kapital: GBP 1
    4 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenSH20

    Beschlüsse

    Resolutions
    4 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06
    capital

    Beschlüsse

    Company business 29/03/2013
    RES13

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2012

    17 SeitenAA

    Ernennung von David William Hart Gray als Sekretär am 31. März 2013

    3 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Gareth Antony Wilson als Sekretär am 31. März 2013

    2 SeitenTM02

    Beschlüsse

    Resolutions
    34 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Annahme der Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    Beendigung der Bestellung eines Geschäftsführers

    2 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 06. Juli 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Beendigung der Bestellung von Adrian Charles Stevens als Geschäftsführer am 30. Juni 2012

    1 SeitenTM01

    Register(s) wurden an die Geschäftsanschrift verlegt

    1 SeitenAD04

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2011

    16 SeitenAA

    Aktueller Abrechnungszeitraum verkürzt von 30. Juni 2012 bis 31. März 2012

    1 SeitenAA01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Andrew James Edward Thomson am 12. Sept. 2011

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Adrian Charles Stevens am 12. Sept. 2011

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Mr Gareth Antony Wilson am 12. Sept. 2011

    2 SeitenCH03

    Änderung der Details des Direktors für Mr Andrea Fiumicelli am 12. Sept. 2011

    2 SeitenCH01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Csc Computer Sciences International Ltd Royal Pavilion Wellesley Road Aldershot Hampshire GU11 1PZ United Kingdom am 18. Aug. 2011

    1 SeitenAD01

    Wer sind die Geschäftsführer von ISOFT OVERSEAS HOLDINGS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    GRAY, David William Hart
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    Sekretär
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    British177357710001
    FIUMICELLI, Andrea
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    ItalyItalianCompany Director135619020001
    CRYNE, Patrick
    The Tannery
    Town Lane
    SK14 6HQ Charlesworth
    Cheshire
    Sekretär
    The Tannery
    Town Lane
    SK14 6HQ Charlesworth
    Cheshire
    BritishCompany Director58894020001
    EDELMAN, Howard Todd
    Elizabeth Bay Road
    2011 Elizabeth Bay
    84/108
    Nsw
    Australia
    Sekretär
    Elizabeth Bay Road
    2011 Elizabeth Bay
    84/108
    Nsw
    Australia
    AustralianCompany Secretary126124430005
    HILL, Teifion Mark
    59 Hill Top Avenue
    Cheadle Hulme
    SK8 7HZ Stockport
    Cheshire
    Sekretär
    59 Hill Top Avenue
    Cheadle Hulme
    SK8 7HZ Stockport
    Cheshire
    BritishHead Of Legal100105520001
    WILSON, Gareth Antony
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    Sekretär
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    162049670001
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    Bevollmächtigter Sekretär
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    900013300001
    COHEN, Gary Michael
    178 Hopetoun Avenue,
    Watsons Bay
    Nsw 2030
    Australia
    Geschäftsführer
    178 Hopetoun Avenue,
    Watsons Bay
    Nsw 2030
    Australia
    AustraliaAustralianCompany Director125992970001
    CRYNE, Patrick
    The Tannery
    Town Lane
    SK14 6HQ Charlesworth
    Cheshire
    Geschäftsführer
    The Tannery
    Town Lane
    SK14 6HQ Charlesworth
    Cheshire
    EnglandBritishCompany Director58894020001
    DICKENS, Roger Joseph
    6 Woodbourne Road
    Edgbaston
    B15 3QH Birmingham
    West Midlands
    Geschäftsführer
    6 Woodbourne Road
    Edgbaston
    B15 3QH Birmingham
    West Midlands
    BritishCompany Director63562150001
    GRAHAM, Stephen Paul
    Brackenridge
    Mereside Road
    WA16 6QR Mere
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Brackenridge
    Mereside Road
    WA16 6QR Mere
    Cheshire
    United KingdomBritishCompany Director97528710001
    HENRY, William Patrick
    9 Grafton Road
    GL50 2ET Cheltenham
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    9 Grafton Road
    GL50 2ET Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandAmericanCompany Director119049370001
    JAMES, Gavin Keith, Mr.
    Camelford
    Bradcutts Lane
    SL6 9AA Cookham Dean
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Camelford
    Bradcutts Lane
    SL6 9AA Cookham Dean
    Berkshire
    EnglandBritishFinance Director44173560008
    KUMAR, Ravi
    14 Parkham Close
    Daisy Hill Westhaughton
    BL5 2GT Bolton
    Lancashire
    Geschäftsführer
    14 Parkham Close
    Daisy Hill Westhaughton
    BL5 2GT Bolton
    Lancashire
    BritishCompany Director101025710001
    MACKAY, James Gordon
    Daventry Road
    OX16 3JT Banbury
    Isoft Group Plc
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Daventry Road
    OX16 3JT Banbury
    Isoft Group Plc
    Oxfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director178097680001
    RICHARDS, Paul
    The Barn Green Lane
    South Newington
    OX15 4JH Banbury
    Geschäftsführer
    The Barn Green Lane
    South Newington
    OX15 4JH Banbury
    United KingdomBritishCompany Director126777780001
    STEVENS, Adrian Charles
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director76964750002
    THOMSON, Andrew James Edward
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Accountant147270780001
    WHELAN, John
    26 Lynton Park Road
    SK8 6JA Cheadle Hulme
    Cheshire
    Geschäftsführer
    26 Lynton Park Road
    SK8 6JA Cheadle Hulme
    Cheshire
    UkBritishFinance Director105872500001
    WHISTON, Timothy Andrew
    Boothshill Farm
    Booths Lane
    WA13 0PF Lymm
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Boothshill Farm
    Booths Lane
    WA13 0PF Lymm
    Cheshire
    EnglandBritishDirector69575560002
    PINSENT MASONS DIRECTOR LIMITED
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    900013290001
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    76579530001

    Hat ISOFT OVERSEAS HOLDINGS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Singaporean law governed second ranking share charge
    Erstellt am 23. Nov. 2010
    Geliefert am 30. Nov. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Equitable charge all the shares and fixed charge all related rights see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Nov. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 01. Aug. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Ratification and extension of deed of pledge of participations executed outside the united kingdom over property situated there
    Erstellt am 11. Feb. 2010
    Geliefert am 02. März 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The security interest over the original participations, the company extends the pledge of participations to the 17,127,821 new participations see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (The Security Agent), Barclays Bank PLC, Clydesdale Bank PLC, Westpac Banking Corporation, the Governor and Company of the Bank of Ireland, Abbey National Treasury Services PLC, Kfw Ipex-Bank Gmbh
    Transaktionen
    • 02. März 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 01. Aug. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Deed of share charge
    Erstellt am 30. Dez. 2009
    Geliefert am 18. Jan. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All the shares and by way of first fixed charge, all related rights. Shares means 8,794,177 ordinary shares of the subject company. Subject company means isoft (holdings) singapore pte LTD. Related rights means any dividend, see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (The Security Agent) as Agent and/or Trustee for the Secured Parties
    Transaktionen
    • 18. Jan. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 01. Aug. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Security agreement
    Erstellt am 30. Dez. 2009
    Geliefert am 18. Jan. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All f/h and l/h property,all equipment and fixed assets,all shares,all other stocks debentures,bonds,warrants,coupons or other securities see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (The Security Agent)
    Transaktionen
    • 18. Jan. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 01. Aug. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Pledge of credit rights
    Erstellt am 30. Dez. 2009
    Geliefert am 18. Jan. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    A security for the full and timely performance of the secured liabilities and without prejudice under the facilities agreement re: new shares means 17,127,821 shares of 1 euro value each numbered 3,007 to 17,130,827 see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (The Security Agent), Barclays Bank PLC, Clydesdale Bank PLC, Westpac Banking Corporation, the Governor and Company of the Bank of Ireland, Abbey National Treasury Services PLC, Kfw Ipex-Bank Gmbh
    Transaktionen
    • 18. Jan. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 01. Aug. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Pledge over participations
    Erstellt am 30. Dez. 2009
    Geliefert am 18. Jan. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    To secure performance of the secured liabilities and without prejudice under the security agreement re: 3,006 participations of 1 euro of nominal value each, numbered 1 to 3,006 see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (The Security Agent), Barclays Bank PLC, Clydesdale Bank PLC, Westpac Banking Corporation, the Governor and Company of the Bank of Ireland, Abbey National Treasury Services PLC, Kfw Ipex-Bank Gmbh
    Transaktionen
    • 18. Jan. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 01. Aug. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Security agreement
    Erstellt am 30. Dez. 2009
    Geliefert am 14. Jan. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All the security under the deed see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Jan. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 01. Aug. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Security agreement
    Erstellt am 30. Dez. 2009
    Geliefert am 13. Jan. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All f/h and l/h property,all equipment and fixed assets,all shares,all other stocks debentures,bonds,warrants,coupons or other securities see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (The Security Agent)
    Transaktionen
    • 13. Jan. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 01. Aug. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Specific security deed
    Erstellt am 30. Dez. 2009
    Geliefert am 13. Jan. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The secured property in respect of accounts receivable see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (The Security Agent)
    Transaktionen
    • 13. Jan. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 01. Aug. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    A supplemental deed
    Erstellt am 29. Okt. 2008
    Geliefert am 13. Nov. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each borrower to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All the shares and first fixed charge all the related rights see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Abn Amro Bank N.V.,London Branch (The Security Agent)
    Transaktionen
    • 13. Nov. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Jan. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Deed of ratification, extension and amendment of pledges
    Erstellt am 29. Okt. 2008
    Geliefert am 13. Nov. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The pledges means the plege over shares, participations and bank accounts see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Abn Amro Bank N.V., London Branch (The Security Agrent) and Aep Financial Services Holdings Pty Limited
    Transaktionen
    • 13. Nov. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Jan. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    A supplemental deed
    Erstellt am 29. Juli 2008
    Geliefert am 15. Aug. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of an equitable mortgage, all the shares; and by way of a first fixed charge, all the related rights see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Abn Amro Bank N.V., London Branch as Agent and Trustee for the Secured Parties (The Security Agent)
    Transaktionen
    • 15. Aug. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Jan. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    A deed of ratification of pledges
    Erstellt am 29. Juli 2008
    Geliefert am 15. Aug. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The chargor creates a pledge right in rem over participations in favour of the secured parties see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Abn Amro Bank N.V.,London Branch (The Security Agrent) and Aep Financial Services Holdings Pty Limited
    Transaktionen
    • 15. Aug. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Jan. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    A pledge over participations
    Erstellt am 15. Juli 2008
    Geliefert am 29. Juli 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Creates a pledge right in rem over participations see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Abn Amro Bank N.V., London Branch (The Security Agent) and Aep Financial Service Holdings Pty Limited
    Transaktionen
    • 29. Juli 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Jan. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    A security agreement
    Erstellt am 11. Dez. 2007
    Geliefert am 27. Dez. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each borrower and each target guarantor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Abn Amro Bank N.V., London Branch (The Security Agent)
    Transaktionen
    • 27. Dez. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Jan. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Specific security deed
    Erstellt am 27. Nov. 2007
    Geliefert am 17. Dez. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    A security interest in the secured property meaning the shares, the share rights. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Abn Amro Bank N.V. London Branch (The Security Agent)
    Transaktionen
    • 17. Dez. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Jan. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    A deed of accession
    Erstellt am 27. Nov. 2007
    Geliefert am 17. Dez. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each borrower as a borrower and from each target guarantor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets pres ent and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Abn Amro Bank N.V., London Branch, as Agent and Trustee for the Secured Parties (The Securityagent)
    Transaktionen
    • 17. Dez. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Jan. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    A deed of accession
    Erstellt am 27. Nov. 2007
    Geliefert am 13. Dez. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each borrower as a borrower and from each target guarantor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Abn Amro Bank N.V., London Branch, as Agent and Trustee for the Secured Parties (The Securityagent)
    Transaktionen
    • 13. Dez. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Jan. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Deed of share charge
    Erstellt am 27. Nov. 2007
    Geliefert am 13. Dez. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each borrower and each target guarantor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The shares and all the related rights,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Abn Amro Bank N.V., London Branch as Agent and Trustee for the Secured Parties (Security Agent)
    Transaktionen
    • 13. Dez. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Jan. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    An amendement agreement to a pledge agreement dated 29 may 2006
    Erstellt am 10. Okt. 2006
    Geliefert am 23. Okt. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and the obligors to the creditors under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    A pledge over 3,006 shares with a nominal value of one euro each numbered from 1 to 3,006 (inclusive) with the same rights and obligations. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC (In Its Capacity as Security Trustee) (the Security Trustee)
    Transaktionen
    • 23. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Okt. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Omnibus guarantee and set-off agreement
    Erstellt am 24. Aug. 2006
    Geliefert am 31. Aug. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Any sums or sums standing to the credit if any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 31. Aug. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Feb. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 30TH january 2003
    Erstellt am 13. Apr. 2006
    Geliefert am 28. Apr. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Apr. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Nov. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 29. Apr. 2004
    Geliefert am 07. Mai 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the parent company, any chargor or any of the parent company's subsidiaries to the finance parties or any of them and such other banks or financial institutions under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Agent and Security Trustee
    Transaktionen
    • 07. Mai 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Okt. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Set-off agreement
    Erstellt am 30. Jan. 2003
    Geliefert am 19. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The companies agree that the bank may at any time and from time to time combine or consolidate all or any of the then existing accounts of the companies with all or any of the liabilities of the companies or any of them to the bank under the ancillary facilities and/or set-off and transfer any sum or sums standing to the credit of one or more of such accounts. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Aug. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 30. Juli 2002
    Geliefert am 20. Aug. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All money,obligations and liabilities due or to become due from each chargor to the chargee and to the lenders (or any of them) in any currency under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Including (I) suite 306,bridgewater house,58-60 whitworth street,manchester; (ii) suite 202,bridgewater house,58-60 whitworth street,manchester; (iii) units 2.01-2.05 faraday wharf aston science park,holt street,birmingham; see form 395 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC,as Security Trustee
    Transaktionen
    • 20. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Aug. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0