ISOFT SOLUTIONS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameISOFT SOLUTIONS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03782306
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von ISOFT SOLUTIONS LIMITED?

    • Sonstige Software-Veröffentlichungen (58290) / Information und Kommunikation

    Wo befindet sich ISOFT SOLUTIONS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Royal Pavilion
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Hampshire
    United Kingdom
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von ISOFT SOLUTIONS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    ISOFT SOLUTIONS PLC19. Juli 199919. Juli 1999
    ISOFT GROUP PLC28. Mai 199928. Mai 1999

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ISOFT SOLUTIONS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2011

    Welche sind die letzten Einreichungen für ISOFT SOLUTIONS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Beschlüsse

    Resolutions
    34 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Annahme der Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    Beendigung der Bestellung von Adrian Charles Stevens als Geschäftsführer am 30. Juni 2012

    2 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 28. Mai 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital28. Mai 2012

    Kapitalaufstellung am 28. Mai 2012

    • Kapital: GBP 28,010,002
    SH01

    Register(s) wurden an die Geschäftsanschrift verlegt

    1 SeitenAD04

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2011

    16 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Mr Andrew James Edward Thomson am 12. Sept. 2011

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Adrian Charles Stevens am 12. Sept. 2011

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Mr Gareth Antony Wilson am 12. Sept. 2011

    2 SeitenCH03

    Änderung der Details des Direktors für Mr Andrea Fiumicelli am 12. Sept. 2011

    2 SeitenCH01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Csc Computer Sciences International Ltd Royal Pavilion Wellesley Road Aldershot Hampshire GU11 1PZ United Kingdom am 18. Aug. 2011

    1 SeitenAD01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Isoft Group Plc Daventry Road Banbury Oxfordshire OX16 3JT am 05. Aug. 2011

    1 SeitenAD01

    legacy

    3 SeitenMG02

    Ernennung von Mr Andrew James Edward Thomson als Direktor

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Gareth Antony Wilson als Sekretär

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von James Mackay als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Howard Edelman als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Jahresrückblick erstellt bis 28. Mai 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Mr James Gordon Mackay am 21. Feb. 2011

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2010

    9 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Gary Cohen als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 28. Mai 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt

    1 SeitenAD03

    Wer sind die Geschäftsführer von ISOFT SOLUTIONS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    WILSON, Gareth Antony
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    Sekretär
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    162045650001
    FIUMICELLI, Andrea
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    ItalyItalianCompany Director135619020001
    THOMSON, Andrew James Edward
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Accountant147270780001
    EDELMAN, Howard Todd
    Elizabeth Bay Road
    2011 Elizabeth Bay
    84/108
    Nsw
    Australia
    Sekretär
    Elizabeth Bay Road
    2011 Elizabeth Bay
    84/108
    Nsw
    Australia
    AustralianCompany Secretary126124430005
    HILL, Teifion Mark
    59 Hill Top Avenue
    Cheadle Hulme
    SK8 7HZ Stockport
    Cheshire
    Sekretär
    59 Hill Top Avenue
    Cheadle Hulme
    SK8 7HZ Stockport
    Cheshire
    British100105520001
    WHISTON, Timothy Andrew
    Boothshill Farm
    Booths Lane
    WA13 0PF Lymm
    Cheshire
    Sekretär
    Boothshill Farm
    Booths Lane
    WA13 0PF Lymm
    Cheshire
    BritishCompany Director69575560002
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    Bevollmächtigter Sekretär
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    900013300001
    COHEN, Gary Michael
    178 Hopetoun Avenue,
    Watsons Bay
    Nsw 2030
    Australia
    Geschäftsführer
    178 Hopetoun Avenue,
    Watsons Bay
    Nsw 2030
    Australia
    AustraliaAustralianCompany Director125992970001
    CRYNE, Patrick
    The Tannery
    Town Lane
    SK14 6HQ Charlesworth
    Cheshire
    Geschäftsführer
    The Tannery
    Town Lane
    SK14 6HQ Charlesworth
    Cheshire
    EnglandBritishCompany Director58894020001
    DICKENS, Roger Joseph
    6 Woodbourne Road
    Edgbaston
    B15 3QH Birmingham
    West Midlands
    Geschäftsführer
    6 Woodbourne Road
    Edgbaston
    B15 3QH Birmingham
    West Midlands
    BritishCompany Director63562150001
    GRAHAM, Stephen Paul
    Brackenridge
    Mereside Road
    WA16 6QR Mere
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Brackenridge
    Mereside Road
    WA16 6QR Mere
    Cheshire
    United KingdomBritishCompany Director97528710001
    HENRY, William Patrick
    9 Grafton Road
    GL50 2ET Cheltenham
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    9 Grafton Road
    GL50 2ET Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandAmericanCompany Director119049370001
    JAMES, Gavin Keith, Mr.
    Camelford
    Bradcutts Lane
    SL6 9AA Cookham Dean
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Camelford
    Bradcutts Lane
    SL6 9AA Cookham Dean
    Berkshire
    EnglandBritishFinance Director44173560008
    KUMAR, Ravi
    14 Parkham Close
    Daisy Hill Westhaughton
    BL5 2GT Bolton
    Lancashire
    Geschäftsführer
    14 Parkham Close
    Daisy Hill Westhaughton
    BL5 2GT Bolton
    Lancashire
    BritishCompany Director101025710001
    MACKAY, James Gordon
    Daventry Road
    OX16 3JT Banbury
    Isoft Group Plc
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Daventry Road
    OX16 3JT Banbury
    Isoft Group Plc
    Oxfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director178097680001
    RICHARDS, Paul
    The Barn Green Lane
    South Newington
    OX15 4JH Banbury
    Geschäftsführer
    The Barn Green Lane
    South Newington
    OX15 4JH Banbury
    United KingdomBritishCompany Director126777780001
    STEVENS, Adrian Charles
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director76964750002
    WHELAN, John
    26 Lynton Park Road
    SK8 6JA Cheadle Hulme
    Cheshire
    Geschäftsführer
    26 Lynton Park Road
    SK8 6JA Cheadle Hulme
    Cheshire
    UkBritishFinance Director105872500001
    WHISTON, Timothy Andrew
    Boothshill Farm
    Booths Lane
    WA13 0PF Lymm
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Boothshill Farm
    Booths Lane
    WA13 0PF Lymm
    Cheshire
    EnglandBritishCompany Director69575560002
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    76579530001

    Hat ISOFT SOLUTIONS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Security agreement
    Erstellt am 30. Dez. 2009
    Geliefert am 13. Jan. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All f/h and l/h property,all equipment and fixed assets,all shares,all other stocks debentures,bonds,warrants,coupons or other securities see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (The Security Agent)
    Transaktionen
    • 13. Jan. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 01. Aug. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    A deed of accession
    Erstellt am 27. Nov. 2007
    Geliefert am 13. Dez. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each borrower as a borrower and from each target guarantor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Abn Amro Bank N.V., London Branch, as Agent and Trustee for the Secured Parties (The Securityagent)
    Transaktionen
    • 13. Dez. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Jan. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Omnibus guarantee and set-off agreement
    Erstellt am 24. Aug. 2006
    Geliefert am 31. Aug. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Any sums or sums standing to the credit if any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 31. Aug. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Apr. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 30TH january 2003
    Erstellt am 13. Apr. 2006
    Geliefert am 28. Apr. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Apr. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Nov. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 29. Apr. 2004
    Geliefert am 07. Mai 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the parent company, any chargor or any of the parent company's subsidiaries to the finance parties or any of them and such other banks or financial institutions under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Agent and Security Trustee
    Transaktionen
    • 07. Mai 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Okt. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Set-off agreement
    Erstellt am 30. Jan. 2003
    Geliefert am 19. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The companies agree that the bank may at any time and from time to time combine or consolidate all or any of the then existing accounts of the companies with all or any of the liabilities of the companies or any of them to the bank under the ancillary facilities and/or set-off and transfer any sum or sums standing to the credit of one or more of such accounts. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Aug. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 30. Juli 2002
    Geliefert am 20. Aug. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All money,obligations and liabilities due or to become due from each chargor to the chargee and to the lenders (or any of them) in any currency under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Including (I) suite 306,bridgewater house,58-60 whitworth street,manchester; (ii) suite 202,bridgewater house,58-60 whitworth street,manchester; (iii) units 2.01-2.05 faraday wharf aston science park,holt street,birmingham; see form 395 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC,as Security Trustee
    Transaktionen
    • 20. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Aug. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0