ISOFT SOLUTIONS LIMITED
Überblick
Unternehmensname | ISOFT SOLUTIONS LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 03782306 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ISOFT SOLUTIONS LIMITED?
- Sonstige Software-Veröffentlichungen (58290) / Information und Kommunikation
Wo befindet sich ISOFT SOLUTIONS LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Royal Pavilion Wellesley Road GU11 1PZ Aldershot Hampshire United Kingdom |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ISOFT SOLUTIONS LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
ISOFT SOLUTIONS PLC | 19. Juli 1999 | 19. Juli 1999 |
ISOFT GROUP PLC | 28. Mai 1999 | 28. Mai 1999 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ISOFT SOLUTIONS LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2011 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ISOFT SOLUTIONS LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 34 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Adrian Charles Stevens als Geschäftsf ührer am 30. Juni 2012 | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Mai 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Register(s) wurden an die Geschäftsanschrift verlegt | 1 Seiten | AD04 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2011 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Andrew James Edward Thomson am 12. Sept. 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Adrian Charles Stevens am 12. Sept. 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Mr Gareth Antony Wilson am 12. Sept. 2011 | 2 Seiten | CH03 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Andrea Fiumicelli am 12. Sept. 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Csc Computer Sciences International Ltd Royal Pavilion Wellesley Road Aldershot Hampshire GU11 1PZ United Kingdom am 18. Aug. 2011 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Isoft Group Plc Daventry Road Banbury Oxfordshire OX16 3JT am 05. Aug. 2011 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
Ernennung von Mr Andrew James Edward Thomson als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Gareth Antony Wilson als Sekretär | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von James Mackay als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Howard Edelman als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Mai 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr James Gordon Mackay am 21. Feb. 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2010 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Gary Cohen als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Mai 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ISOFT SOLUTIONS LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WILSON, Gareth Antony | Sekretär | Wellesley Road GU11 1PZ Aldershot Royal Pavilion Hampshire United Kingdom | 162045650001 | |||||||
FIUMICELLI, Andrea | Geschäftsführer | Wellesley Road GU11 1PZ Aldershot Royal Pavilion Hampshire United Kingdom | Italy | Italian | Company Director | 135619020001 | ||||
THOMSON, Andrew James Edward | Geschäftsführer | Wellesley Road GU11 1PZ Aldershot Royal Pavilion Hampshire United Kingdom | England | British | Chartered Accountant | 147270780001 | ||||
EDELMAN, Howard Todd | Sekretär | Elizabeth Bay Road 2011 Elizabeth Bay 84/108 Nsw Australia | Australian | Company Secretary | 126124430005 | |||||
HILL, Teifion Mark | Sekretär | 59 Hill Top Avenue Cheadle Hulme SK8 7HZ Stockport Cheshire | British | 100105520001 | ||||||
WHISTON, Timothy Andrew | Sekretär | Boothshill Farm Booths Lane WA13 0PF Lymm Cheshire | British | Company Director | 69575560002 | |||||
PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 41 Park Square LS1 2NS Leeds | 900013300001 | |||||||
COHEN, Gary Michael | Geschäftsführer | 178 Hopetoun Avenue, Watsons Bay Nsw 2030 Australia | Australia | Australian | Company Director | 125992970001 | ||||
CRYNE, Patrick | Geschäftsführer | The Tannery Town Lane SK14 6HQ Charlesworth Cheshire | England | British | Company Director | 58894020001 | ||||
DICKENS, Roger Joseph | Geschäftsführer | 6 Woodbourne Road Edgbaston B15 3QH Birmingham West Midlands | British | Company Director | 63562150001 | |||||
GRAHAM, Stephen Paul | Geschäftsführer | Brackenridge Mereside Road WA16 6QR Mere Cheshire | United Kingdom | British | Company Director | 97528710001 | ||||
HENRY, William Patrick | Geschäftsführer | 9 Grafton Road GL50 2ET Cheltenham Gloucestershire | England | American | Company Director | 119049370001 | ||||
JAMES, Gavin Keith, Mr. | Geschäftsführer | Camelford Bradcutts Lane SL6 9AA Cookham Dean Berkshire | England | British | Finance Director | 44173560008 | ||||
KUMAR, Ravi | Geschäftsführer | 14 Parkham Close Daisy Hill Westhaughton BL5 2GT Bolton Lancashire | British | Company Director | 101025710001 | |||||
MACKAY, James Gordon | Geschäftsführer | Daventry Road OX16 3JT Banbury Isoft Group Plc Oxfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 178097680001 | ||||
RICHARDS, Paul | Geschäftsführer | The Barn Green Lane South Newington OX15 4JH Banbury | United Kingdom | British | Company Director | 126777780001 | ||||
STEVENS, Adrian Charles | Geschäftsführer | Wellesley Road GU11 1PZ Aldershot Royal Pavilion Hampshire United Kingdom | England | British | Company Director | 76964750002 | ||||
WHELAN, John | Geschäftsführer | 26 Lynton Park Road SK8 6JA Cheadle Hulme Cheshire | Uk | British | Finance Director | 105872500001 | ||||
WHISTON, Timothy Andrew | Geschäftsführer | Boothshill Farm Booths Lane WA13 0PF Lymm Cheshire | England | British | Company Director | 69575560002 | ||||
PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED | Geschäftsführer | 1 Park Row LS1 5AB Leeds West Yorkshire | 76579530001 |
Hat ISOFT SOLUTIONS LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Security agreement | Erstellt am 30. Dez. 2009 Geliefert am 13. Jan. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All f/h and l/h property,all equipment and fixed assets,all shares,all other stocks debentures,bonds,warrants,coupons or other securities see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A deed of accession | Erstellt am 27. Nov. 2007 Geliefert am 13. Dez. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each borrower as a borrower and from each target guarantor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Omnibus guarantee and set-off agreement | Erstellt am 24. Aug. 2006 Geliefert am 31. Aug. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Any sums or sums standing to the credit if any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 30TH january 2003 | Erstellt am 13. Apr. 2006 Geliefert am 28. Apr. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee & debenture | Erstellt am 29. Apr. 2004 Geliefert am 07. Mai 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the parent company, any chargor or any of the parent company's subsidiaries to the finance parties or any of them and such other banks or financial institutions under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Set-off agreement | Erstellt am 30. Jan. 2003 Geliefert am 19. Feb. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The companies agree that the bank may at any time and from time to time combine or consolidate all or any of the then existing accounts of the companies with all or any of the liabilities of the companies or any of them to the bank under the ancillary facilities and/or set-off and transfer any sum or sums standing to the credit of one or more of such accounts. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 30. Juli 2002 Geliefert am 20. Aug. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All money,obligations and liabilities due or to become due from each chargor to the chargee and to the lenders (or any of them) in any currency under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Including (I) suite 306,bridgewater house,58-60 whitworth street,manchester; (ii) suite 202,bridgewater house,58-60 whitworth street,manchester; (iii) units 2.01-2.05 faraday wharf aston science park,holt street,birmingham; see form 395 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0