OCTOBER PROPERTY INVESTMENTS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | OCTOBER PROPERTY INVESTMENTS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03784813 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von OCTOBER PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?
- Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich OCTOBER PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 88 Wood Street EC2V 7QF London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von OCTOBER PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| BIRKBY INVESTMENTS LIMITED | 04. Juni 1999 | 04. Juni 1999 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von OCTOBER PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2011 |
Welche sind die letzten Einreichungen für OCTOBER PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung am 07. Nov. 2013 | 20 Seiten | 2.35B | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 19. Mai 2013 | 19 Seiten | 2.24B | ||||||||||
Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge | 1 Seiten | F2.18 | ||||||||||
Vermögensübersicht mit Formular 2.14B | 6 Seiten | 2.16B | ||||||||||
Vorschlag des Verwalters | 27 Seiten | 2.17B | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O King Loose St John's Parade 5 South Parade Summertown Oxford OX2 7JL am 30. Nov. 2012 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines Verwalters | 1 Seiten | 2.12B | ||||||||||
legacy | 6 Seiten | LQ01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. März 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2011 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Noel Martin Smyth am 04. Nov. 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2010 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. März 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Ernennung von Alannah Smyth als Sekretär | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Ernennung von Bryan Lawlor als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Bryan Lawlor als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von John Mckenna als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. März 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2009 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2008 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von OCTOBER PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMYTH, Alannah | Sekretär | Portobello Road Dublin 8 29 Ireland | 154679490001 | |||||||
| KINNAIRD, Nigel John | Geschäftsführer | 14 Magheraconluce Lane BT26 6PT Hillsborough County Down | Northern Ireland | British | 83042830001 | |||||
| LAWLOR, Bryan | Geschäftsführer | Coolamber Court Knocklyon Road Dublin 16 17 Ireland | Ireland | Irish | 154652750001 | |||||
| SMYTH, Noel Martin | Geschäftsführer | 25 Tooting Bec Road SW17 8BY London Flat 7 England | Ireland | Irish | 91238420002 | |||||
| DIGHTON, Simon Gerald | Sekretär | 28 Lightwoods Hill Bearwood B67 5EA Warley West Midlands | British | 78151560001 | ||||||
| DRYSDALE, Clive Douglas | Sekretär | 22 Laburnham Road SL6 4DB Maidenhead Berkshire | British | 45345090002 | ||||||
| DUDLEY, Martin Paul | Sekretär | Horsebrook House 51 Old Farm Drive WV8 1GF Codsall Wolverhampton | British | 93516350001 | ||||||
| GIBSON, Jacqueline | Sekretär | 7 Manor Court Beech Road Headington OX3 7SD Oxford Oxfordshire | British | 84250850001 | ||||||
| GRADUS, Vicki Doreen | Sekretär | 99 Deacons Hill Road Elstree WD6 3JF Borehamwood Hertfordshire | British | 60427810001 | ||||||
| LAWLOR, Bryan William | Sekretär | Coolamber Court Knocklyon Road 21 Dublin 16 Republic Of Ireland | Irish | 154652750014 | ||||||
| BEER, Paul Allan | Geschäftsführer | Oaklands 14 Sandy Lodge Way HA6 2AJ Northwood Middlesex | British | 6436770001 | ||||||
| CRAN, William Michael | Geschäftsführer | 16 Colne Valley Business Park Linthwaite HD7 5QG Huddersfield West Yorkshire | British | 64725130001 | ||||||
| DIGHTON, Simon Gerald | Geschäftsführer | 28 Lightwoods Hill Bearwood B67 5EA Warley West Midlands | United Kingdom | British | 78151560001 | |||||
| DRYSDALE, Clive Douglas | Geschäftsführer | 22 Laburnham Road SL6 4DB Maidenhead Berkshire | British | 45345090002 | ||||||
| DUDLEY, Martin Paul | Geschäftsführer | Horsebrook House 51 Old Farm Drive WV8 1GF Codsall Wolverhampton | United Kingdom | British | 93516350001 | |||||
| GWYN JONES, Henry Alexander | Geschäftsführer | 4 Rue Desaix Paris 75008 France | British | 69720680007 | ||||||
| KIRKWOOD, Stuart Watson | Geschäftsführer | The Granary Malthouse Farm Evesham Road Cookhill B49 5LJ Alcester Warwickshire | British | 76937270002 | ||||||
| KUELSHEIMER, Leslie Claude | Geschäftsführer | 55 Foscote Road Hendon NW4 3SE London | British | 7163440001 | ||||||
| MCKENNA, John | Geschäftsführer | 34 Brighton Square Rathgar IRISH Dublin 6 Republic Of Ireland | Ireland | Irish | 116525480001 | |||||
| MELVILLE, Stephen | Geschäftsführer | 31 West Hill Way N20 8QX London | Spain | British | 50085870002 | |||||
| SMITH, Nicholas Paul | Geschäftsführer | Scrag Oak TN5 6NP Wadhurst Sussex | United Knigdom | British | 32981540001 | |||||
| STOCK, Maurice David John | Geschäftsführer | Weymouth Avenue Mill Hill NW7 3JD London 11 | England | British | 42738500001 | |||||
| TAYLOR-SMITH, Kim David Spencer | Geschäftsführer | White Lodge 338 Upper Richmond Road SW15 6TL London | British | 78391680002 |
Hat OCTOBER PROPERTY INVESTMENTS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 28. Sept. 2007 Geliefert am 06. Okt. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and each borrower to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h property known as lonsdale house 52 blucher street birmingham t/n WK162153, fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled share capital buildings and fixtures,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 22. Feb. 2007 Geliefert am 08. März 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The mortgaged property being lonsdale house, 52 blucher st, birmingham t/no WK162153. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Subordination agreement | Erstellt am 22. Feb. 2007 Geliefert am 08. März 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Under the subordination agreement, if: any obligor makes any payment in cash or in kind on account of, or for the purchase or other acquisition of, all or any part of the junior liabilities; or the company receives all or any amount in cash or in kind of the junior liabilities:. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture with floating charge | Erstellt am 22. Feb. 2007 Geliefert am 08. März 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of first legal mortgage the mortgaged property, assignment any rental income, insurance policies, the hedge documents, fixed charges the real property, the property account, the gic account, book and other debts, goodwill and uncalled share capital, scottish property, scottish shares, jersey shares, floating charge all assets and undertaking. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| ||||
| Debenture with floating charge | Erstellt am 29. Sept. 2005 Geliefert am 10. Okt. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the lender on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a lonsdale house 52 blucher street birmingham t/n wk 162153 the shares and all its present and future investments rental income insurace policies goodwill by way of floating charge all present and future assets and undertaking. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture with floating charge | Erstellt am 29. Sept. 2005 Geliefert am 10. Okt. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the lender and/or the security trustee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a lonsdale house 52 blucher street birmingham t/n WK162153 right title and interest to, in and under all agreements contracts deeds licences undertakings guarantees covenants warranties rental income insurance policies. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 05. Nov. 1999 Geliefert am 17. Nov. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All the company's undertaking property and other assets of whatever nature. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat OCTOBER PROPERTY INVESTMENTS LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Receiver/Manager bestellt |
| |||||||||||||||||||||||
| 2 |
| In Verwaltung |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0