INVICTA (CLUB INDIGO) LIMITED

INVICTA (CLUB INDIGO) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameINVICTA (CLUB INDIGO) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03787893
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von INVICTA (CLUB INDIGO) LIMITED?

    • Fitnessstudios (93130) / Kunst, Unterhaltung und Erholung

    Wo befindet sich INVICTA (CLUB INDIGO) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    C/O Mazars Llp
    45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von INVICTA (CLUB INDIGO) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    INVICTA LEISURE (BRADFORD) LIMITED11. Juni 199911. Juni 1999

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von INVICTA (CLUB INDIGO) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2017

    Welche sind die letzten Einreichungen für INVICTA (CLUB INDIGO) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    17 SeitenLIQ13

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 100 Aldersgate Street London EC1A 4LX zum C/O Mazars Llp 45 Church Street Birmingham B3 2RT am 11. Juli 2018

    4 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 18. Juni 2018

    LRESSP

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    5 SeitenLIQ01

    Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 30. Mai 2018

    • Kapital: GBP 23,150,002
    4 SeitenSH01

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Zuteilung von Wertpapieren

    RES10

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2017

    10 SeitenAA

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016

    12 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 29. Aug. 2017 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von Paul Antony Woolf als Geschäftsführer am 21. Feb. 2017

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015

    12 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 29. Aug. 2016 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse The Pinnacle 170 Midsummer Boulevard Milton Keynes MK9 1FE verlegt

    1 SeitenAD03

    Ernennung von Mr David Anthony Rowland Carter als Direktor am 08. Aug. 2016

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Robert Barclay Cook als Direktor am 08. Aug. 2016

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Matthew Graham Merrick als Geschäftsführer am 02. Aug. 2016

    1 SeitenTM01

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse The Pinnacle 170 Midsummer Boulevard Milton Keynes MK9 1FE verlegt

    1 SeitenAD03

    Ernennung von Johanna Ruth Hartley als Direktor am 09. Dez. 2015

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Mark Paul Burrows als Geschäftsführer am 01. Dez. 2015

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2014

    12 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 29. Aug. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital07. Sept. 2015

    Kapitalaufstellung am 07. Sept. 2015

    • Kapital: GBP 6,500,002
    SH01

    Ernennung von Mark Paul Burrows als Direktor am 24. Nov. 2014

    2 SeitenAP01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013

    12 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von INVICTA (CLUB INDIGO) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    ARCHIBALD, James
    45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    C/O Mazars Llp
    Sekretär
    45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    C/O Mazars Llp
    British162965230001
    BUCKNALL, Matthew William
    45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    C/O Mazars Llp
    Geschäftsführer
    45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    C/O Mazars Llp
    United KingdomBritish162066820001
    CARTER, David Anthony Rowland
    45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    C/O Mazars Llp
    Geschäftsführer
    45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    C/O Mazars Llp
    EnglandBritish213043670001
    COOK, Robert Barclay
    45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    C/O Mazars Llp
    Geschäftsführer
    45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    C/O Mazars Llp
    United KingdomBritish281929160001
    HARTLEY, Johanna Ruth
    45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    C/O Mazars Llp
    Geschäftsführer
    45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    C/O Mazars Llp
    EnglandBritish203782500001
    BALL, Michael David
    Mulberry House
    Trumps Green Road
    GU25 4JA Virginia Water
    Surrey
    Sekretär
    Mulberry House
    Trumps Green Road
    GU25 4JA Virginia Water
    Surrey
    British58961410002
    FALLOWS, Michael Joseph
    11 Greville Drive
    Edgbaston
    B15 2UU Birmingham
    Sekretär
    11 Greville Drive
    Edgbaston
    B15 2UU Birmingham
    British58345490001
    HULL, William Lewis Robert
    20 Lansdown View
    Timsbury
    BA3 1JP Bath
    Avon
    Sekretär
    20 Lansdown View
    Timsbury
    BA3 1JP Bath
    Avon
    British63815510001
    SCALES, Eugene Patrick
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    Sekretär
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    Other124193970001
    TYSON, Roger Thomas Virley
    2 Gadd Close
    RG40 5PQ Wokingham
    Berkshire
    Sekretär
    2 Gadd Close
    RG40 5PQ Wokingham
    Berkshire
    British113777700001
    WONG, Wai Chung
    Flat 3 Rowsley Lodge
    72a Lady Margaret Road
    N19 5EL London
    Sekretär
    Flat 3 Rowsley Lodge
    72a Lady Margaret Road
    N19 5EL London
    British123616460002
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Bevollmächtigter Sekretär
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BALL, Michael David
    Mulberry House
    Trumps Green Road
    GU25 4JA Virginia Water
    Surrey
    Geschäftsführer
    Mulberry House
    Trumps Green Road
    GU25 4JA Virginia Water
    Surrey
    United KingdomBritish58961410002
    BURROWS, Mark Paul
    Aldersgate Street
    EC1A 4LX London
    100
    Geschäftsführer
    Aldersgate Street
    EC1A 4LX London
    100
    United KingdomBritish192910210001
    CHARLTON, Stephen Paul
    9 Rowan Close
    L40 4LP Burscough
    Lancashire
    Geschäftsführer
    9 Rowan Close
    L40 4LP Burscough
    Lancashire
    EnglandBritish96743210001
    CLELAND, Jonathan Bradley
    21 North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Active House
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    21 North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Active House
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish146698270001
    CREED, Stuart John
    Jade House The Avenue
    Claverton Down
    BA2 7AX Bath
    Geschäftsführer
    Jade House The Avenue
    Claverton Down
    BA2 7AX Bath
    United KingdomBritish3716600001
    DHODY, Jog
    21 North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Active House
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    21 North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Active House
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish104269910002
    FALLOWS, Michael Joseph
    11 Greville Drive
    Edgbaston
    B15 2UU Birmingham
    Geschäftsführer
    11 Greville Drive
    Edgbaston
    B15 2UU Birmingham
    EnglandBritish58345490001
    FIELD, Norman Mark
    21 North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Active House
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    21 North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Active House
    Buckinghamshire
    United KingdomSouth African161860310001
    GILLIS, Neil Duncan
    Lodge Farm
    High Street, Thelnetham
    IP22 1JL Diss
    Norfolk
    Geschäftsführer
    Lodge Farm
    High Street, Thelnetham
    IP22 1JL Diss
    Norfolk
    EnglandBritish69204500003
    GUYER, Paul John
    Oakwood House
    29 Leydene Park
    GU32 1HF East Meon
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Oakwood House
    29 Leydene Park
    GU32 1HF East Meon
    Hampshire
    British100971720002
    HALL, Andrew James
    Tanglewood
    3 Badingham Drive
    AL5 2DA Harpenden
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Tanglewood
    3 Badingham Drive
    AL5 2DA Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish30306840002
    LEATHERBARROW, David Jon
    21 North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Active House
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    21 North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Active House
    Buckinghamshire
    EnglandBritish135618280002
    MCCOLLUM, Kevin Boyd
    Waterton Stables
    Ampney Crucis
    GL7 5RX Cirencester
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    Waterton Stables
    Ampney Crucis
    GL7 5RX Cirencester
    Gloucestershire
    EnglandBritish121972580001
    MCGUIGAN, Marc Edward
    Avadi
    Chapel Lane
    GL20 7ER Tewkesbury
    Gloucester
    Geschäftsführer
    Avadi
    Chapel Lane
    GL20 7ER Tewkesbury
    Gloucester
    EnglandBritish93677590002
    MERRICK, Matthew Graham
    Aldersgate Street
    EC1A 4LX London
    100
    England
    Geschäftsführer
    Aldersgate Street
    EC1A 4LX London
    100
    England
    United KingdomBritish162110530001
    MOORE, Trevor Philip
    Malmsmead
    Bayleys Hill
    TN14 6HS Sevenoaks
    Kent
    Geschäftsführer
    Malmsmead
    Bayleys Hill
    TN14 6HS Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritish113047410001
    SEGAL, Richard Lawrence
    21 North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Active House
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    21 North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Active House
    Buckinghamshire
    EnglandBritish138744060001
    TIMMS, Glenn Gordon
    8 Haywards Close
    RG9 1UY Henley On Thames
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    8 Haywards Close
    RG9 1UY Henley On Thames
    Oxfordshire
    British54133140004
    TOWNSEND, John
    9 Mariners Drive
    Backwell
    BS48 3HT Bristol
    Geschäftsführer
    9 Mariners Drive
    Backwell
    BS48 3HT Bristol
    British57873610002
    WEATHERLEY, Kenneth Frank
    8 Langtons Court
    Sun Lane
    SO24 9UE Alresford
    Hampshire
    Geschäftsführer
    8 Langtons Court
    Sun Lane
    SO24 9UE Alresford
    Hampshire
    British50477690001
    WOOLF, Paul Antony
    Aldersgate Street
    EC1A 4LX London
    100
    England
    Geschäftsführer
    Aldersgate Street
    EC1A 4LX London
    100
    England
    United KingdomBritish160679880001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei INVICTA (CLUB INDIGO) LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Esporta Health & Fitness Limited
    Aldersgate Street
    EC1A 4LX London
    100
    England
    06. Apr. 2016
    Aldersgate Street
    EC1A 4LX London
    100
    England
    Nein
    RechtsformPrivate Limited Company
    RegistrierungslandUnited Kingdom
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortEngland & Wales
    Registrierungsnummer02999311
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat INVICTA (CLUB INDIGO) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Supplemental security
    Erstellt am 04. Sept. 2009
    Geliefert am 15. Sept. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company or any other chargor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    A health and fitness club at waterton retail park bridgend, all buildings and fixtures, book debts, plant and machinery relating to the mortgaged property, see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Societe Generale London Branch
    Transaktionen
    • 15. Sept. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Okt. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Fixed and floating security document
    Erstellt am 18. Juni 2009
    Geliefert am 26. Juni 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company or any other chargor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Societe Generale as Security Trustee for the Benefit of the Secured Parties
    Transaktionen
    • 26. Juni 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Okt. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Group debenture
    Erstellt am 08. Feb. 2006
    Geliefert am 18. Feb. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Trustee for the Secured Parties)(in Such Capacity the "Security Agent")
    Transaktionen
    • 18. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. März 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 27. Jan. 2004
    Geliefert am 07. Feb. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the borrower, the charging group and/or any other member of the group to the note finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Electra Partners Europe Limited as Noteholders' Agent and Noteholders' Security Trustee Andnoteholders Security Trust (The "Noteholders' Security Trustee")
    Transaktionen
    • 07. Feb. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Nov. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 27. Jan. 2004
    Geliefert am 03. Feb. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the borrower, the charging group and/or any member of the group (meaning the borrower or its subsidiaries from time to time) to the finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Dukes meadow chiswick hounslow t/no NGL147830; imperial way croydon surrey t/no SGL454522; llandarcy neath swansea t/no CYM43829 and WA953690 for details of further properties charged please refer to form 395 unscheduled property, rental income, fixed or other plant and machinery, insurances, licences on land, reights as tenant, book and other debts, bank accounts, charged securities, uncalled capital , goodwill, intellectual property, licences, credit agreements, contracts floating charge undertaking property rights and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Feb. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. März 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental charge
    Erstellt am 28. Nov. 2003
    Geliefert am 12. Dez. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H property the health and fitness club at 168 locking road weston super mare north somerset all property, present and future book debts, all equipment, present and future licences, insurances, indebtedness owed by esporta h & f fropco (1B) limited to the company.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 12. Dez. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. März 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental charge
    Erstellt am 03. Sept. 2003
    Geliefert am 19. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any of the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The leasehold property being 151 to 156 east reach taunton somerset together with all buildings and fixtures thereon all other estates or interests in the property and any rights under any licence or other agreement all present and future book and other debts all equipment the benefit of all present and future licences permissions consents and authorisations all benefit in respect of all insurance in relation to the property.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent and Security Trustee for the Finance Parties
    Transaktionen
    • 19. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. März 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental charge
    Erstellt am 06. Feb. 2003
    Geliefert am 10. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H basement ground and first floors unit 4 clements road ilford essex. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 10. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. März 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 05. Sept. 2002
    Geliefert am 09. Sept. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys due or to become due from the issuer and by each charging company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of first legal mortgage all properties now owned by or vested in each charging company including t/n ST142672 168 locking road, weston super mare, north somerset. Leasehold t/n WSX263151 comprising a health and fitness centre and tennis courts at rustington golf centre, rustington. Leasehold t/n WYK6744799 premises at gallagher leisure park, dick lane bradford. For details of futher properties charged please refer to form 395. by way of first fixed mortgage the securities, first fixed charge all properties thereafter acquired, all present and future interests in or over freehold or leasehold property; all present and future rights, licences, guarantees, rents, deposits, contracts, covenants and warranties relating to the properties.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Electra Partners Europe Limited (As Noteholders' Agent and Noteholders' Security Agent for Thenote Finance Parties)
    Transaktionen
    • 09. Sept. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Jan. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental charge
    Erstellt am 27. Juni 2002
    Geliefert am 01. Juli 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any of the mezzanine finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H premises comprising tennis courts at rustington golf centre, rustington. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Electra Partners Europe Limited (As Mezzanine Security Trustee)
    Transaktionen
    • 01. Juli 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Sept. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    • 25. Sept. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental charge
    Erstellt am 27. Juni 2002
    Geliefert am 28. Juni 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of first legal mortgage, the property and all other estates or interests in the property. By way of first fixed charge all book and other debts, all equipment, the benefit of licences, permissions, consents etc, and the benefits in respect of all insurance.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 28. Juni 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. März 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental charge
    Erstellt am 05. Apr. 2002
    Geliefert am 06. Apr. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All liabilities and obligations due or to become due from the company to any of the mezzanine finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/Hold land known as 168 locking rd,weston super mare; part t/no ST142672; all buildings and fixtures thereon and the proceeds of sale thereof; the benefit of any covenants for title and all other estates or interests and any rights under any licence or other agreement or document; all book and other debts due and all rent payable by any tenant; the benefit of any rights,securities and guarantees whatsoever; all equipment,licences,consents,etc; see form 395 for details.
    Berechtigte Personen
    • Electra Partners Europe Limited
    Transaktionen
    • 06. Apr. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Sept. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    • 25. Sept. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental charge
    Erstellt am 05. Apr. 2002
    Geliefert am 06. Apr. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies obligations and liabilities due or to become due from the company to any of the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/Hold land known as 168 locking rd,weston super mare; part t/no ST142672; all buildings and fixtures thereon and the proceeds of sale thereof; the benefit of any covenants for title and all other estates or interests and any rights under any licence or other agreement or document; all book and other debts due and all rent payable by any tenant; the benefit of any rights,securities and guarantees whatsoever; all equipment,licences,consents,etc; see form 395 for details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC,as Agent and Security Trustee for the Finance Parties
    Transaktionen
    • 06. Apr. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. März 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental charge
    Erstellt am 28. März 2002
    Geliefert am 10. Apr. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys obligations and liabilities due or to become due from the company to any of the mezzanine finance parties on any ccount whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/Hold premises comprising a health and fitness centre at rustington golf centre,rustington with all buildings,fixtures,equipment thereon and the proceeds of sale thereof; the benefit of any covenants for title and any moneys paid thereunder; all other estates or interests and any rights under any licence or other agreement or document; first fixed charge over any book and other debts due. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Electra Partners Europe Limited,as Mezzanine Security Trustee
    Transaktionen
    • 10. Apr. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Sept. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    • 25. Sept. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental charge
    Erstellt am 28. März 2002
    Geliefert am 03. Apr. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever . under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H premises comprising a health & fitness centre at rustington golf course rustington. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 03. Apr. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. März 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental charge to the debenture created on 25 october 2000
    Erstellt am 18. Juni 2001
    Geliefert am 09. Juli 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future monies obligations and liabilities owed by the company to any of the mezzanine finance parties (as defined in the debenture dated 25 october 2000) in any capacity whatsoever under or in connection with the mezzanine financing documents (as defined in the debenture dated 25 october 2000)
    Kurze Angaben
    By way of first legal mortgage the l/h premises comprising a health and fitness centre at oldham street, denton in the course of registration at the land registry under provisional t/n GM869136 together with all buildings and fixtures thereon, the proceeds of sale of all or any part thereof and the benefit of any covenants of title given or entered into by any predecessor in title and any monies paid or payable in respect of such covenants. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Electra Partners Europe Limited (As Mezzanine Agent and Mezzanine Securitytrustee)
    Transaktionen
    • 09. Juli 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Sept. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    • 25. Sept. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental charge to a debenture dated 06 july 2000 and registered the 12 july 2000
    Erstellt am 18. Juni 2001
    Geliefert am 28. Juni 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with the financing documents including without limitationthe guarantee and debenture dated the 12 july 2000
    Kurze Angaben
    By way of first legal mortgage the l/h premises together with all buildings and fixtures thereon, the proceeds of sale of all or any part thereof and the benefit of any covenants of title given or entered into by any predecessor in title and any monies paid or payable in respect of such covenants, all other estates or interests in the property.. By way of fixed charge all present and future book and other debts... See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Coutts & Company
    Transaktionen
    • 28. Juni 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. März 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental charge to the debenture dated 06 july 2000 and registered the 12 july 2000
    Erstellt am 18. Juni 2001
    Geliefert am 28. Juni 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with the financing documents including without limitation the guarantee and debenture dated 12 july 2000
    Kurze Angaben
    By way of first legal mortgage the l/h premises together with all buildings and fixtures thereon, the proceeds of sale of all or any part thereof and the benefit of any covenants of title given or entered into by any predecessor in title and any monies paid or payable in respect of such covenants, all other estates or interests in the property.. By way of fixed charge all present and future book and other debts... See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Electra Partners Europe Limited
    Transaktionen
    • 28. Juni 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Aug. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental charge (as defined)
    Erstellt am 02. Feb. 2001
    Geliefert am 09. Feb. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys obligations and liabilities due or to become due from the company to any of the mezzanine finance parties (as defined in the debenture) in any capacity whatsoever under or in connection with the mezzanine financing documents (as defined in the debenture)
    Kurze Angaben
    L/Hold premises known as unit a cwmbran leisure park avondale road cwmbran south wales with all buildings fixtures thereon,the proceeds of sale thereof and benefit of any covenants for title and any moneys paid thereunder; all other estates or interests and any rights under any licence or other agreement or document; the benefit of any covenants and fixed charge over all book and other debts due and all rent payable; all other rights,securities and guarantees whatsoever and all equipment,plant,machinery,tools,etc. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Electra Partners Europe Limited (As Mezzanine Agent and Mezzanine Securitytrustee for the Mezzanine Finance Parties
    Transaktionen
    • 09. Feb. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Sept. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    • 25. Sept. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental charge
    Erstellt am 14. Dez. 2000
    Geliefert am 03. Jan. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future monies obligations and liabilities owed by the company to any of the finance parties (as defined) under or in connection with the financing documents (including without limitation the guarantee and this debenture)
    Kurze Angaben
    L/H unit a cwmbran leisure park avondale road cwmbran south wales together with all buildings and fixtures book debts and other debts. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Coutts & Company
    Transaktionen
    • 03. Jan. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. März 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 25. Okt. 2000
    Geliefert am 28. Okt. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future monies obligations and liabilities owed by the company to any of the mezzanine finance parties (as defined) whether actual or contingent and whether owed jointly or severally as principal or surety and/or in any other capacity whatsoever under or in connection with the mezzanine financing documents (as defined)
    Kurze Angaben
    Premises at gallagher leisure park dick lane bradford together with. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Electra Partners Europe Limited (As Agent and Security Trustee for the Mezzanine Finance Parties (as Defined)
    Transaktionen
    • 28. Okt. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Sept. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    • 25. Sept. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 06. Juli 2000
    Geliefert am 12. Juli 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or in connection with the financing documents (including, without limitation, the guarantee and this debenture)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Coutts & Company
    Transaktionen
    • 12. Juli 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. März 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat INVICTA (CLUB INDIGO) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    18. Juni 2018Beginn der Liquidation
    08. Jan. 2019Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Scott Christian Bevan
    Mazars Llp 45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    Praktiker
    Mazars Llp 45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    Simon David Chandler
    C/O Mazars Llp 1st Floor
    Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Praktiker
    C/O Mazars Llp 1st Floor
    Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0