MIMOSA HEALTHCARE LTD

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameMIMOSA HEALTHCARE LTD
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03788573
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von MIMOSA HEALTHCARE LTD?

    • Sonstige menschliche Gesundheitsaktivitäten (86900) / Gesundheits- und Sozialwesen

    Wo befindet sich MIMOSA HEALTHCARE LTD?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    3 Hardman Street
    Spinningfields
    M3 3AT Manchester
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von MIMOSA HEALTHCARE LTD?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    PINCO 1242 LIMITED14. Juni 199914. Juni 1999

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MIMOSA HEALTHCARE LTD?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Mai 2012

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für MIMOSA HEALTHCARE LTD?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für MIMOSA HEALTHCARE LTD?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung am 21. Dez. 2015

    19 Seiten2.35B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 06. Aug. 2015

    20 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 06. Feb. 2015

    17 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 23. Sept. 2014

    14 Seiten2.24B

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    1 SeitenF2.18

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    21 Seiten2.16B

    Vorschlag des Verwalters

    50 Seiten2.17B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * New Vernon House Vernon Avenue Beeston Nottingham NG9 2NS United Kingdom* am 01. Apr. 2014

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    Jahresrückblick erstellt bis 14. Juni 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital27. Juni 2013

    Kapitalaufstellung am 27. Juni 2013

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * 1St Floor Mmr House Harrimans Lane Lenton Industrial Estate Dunkirk Nottingham Nottinghamshire NG7 2SD* am 16. März 2013

    1 SeitenAD01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2012

    16 SeitenAA

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2011

    17 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 14. Juni 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt

    1 SeitenDISS40

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Jahresrückblick erstellt bis 14. Juni 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2010 bis 31. Mai 2011

    1 SeitenAA01

    Beendigung der Bestellung von Sophia Millar als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Mark Butler als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Simon Kaberry als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009

    17 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von MIMOSA HEALTHCARE LTD?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    MASSOURAS, Anthony George
    The Hall
    Church Lane
    S75 4BJ High Hoyland
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    The Hall
    Church Lane
    S75 4BJ High Hoyland
    South Yorkshire
    EnglandBritishDirector5059450003
    REDPATH, James
    16 Bosworth Way
    NG10 1EA Long Eaton
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    16 Bosworth Way
    NG10 1EA Long Eaton
    Nottinghamshire
    EnglandBritishFinance Director123915050001
    BINGLEY, Andrew Charles
    8 Buckland Drive
    Woodborough
    NG14 6EU Nottingham
    Norringhamshire
    Sekretär
    8 Buckland Drive
    Woodborough
    NG14 6EU Nottingham
    Norringhamshire
    BritishOffice Manager81787860001
    KABERRY, Simon Edmund John
    94 Parkstone Avenue
    LS16 6EN Leeds
    West Yorkshire
    Sekretär
    94 Parkstone Avenue
    LS16 6EN Leeds
    West Yorkshire
    British124046260001
    MASSOURAS, Anthony George
    235 Derby Road
    Beeston
    NG9 3AZ Nottingham
    Nottinghamshire
    Sekretär
    235 Derby Road
    Beeston
    NG9 3AZ Nottingham
    Nottinghamshire
    BritishDirector5059450001
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    Bevollmächtigter Sekretär
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    900013300001
    BUTLER, Mark Peter
    40 Blanch Croft
    Melbourne
    DE73 8GG Derby
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    40 Blanch Croft
    Melbourne
    DE73 8GG Derby
    Derbyshire
    EnglandBritishOperations Manager107543510001
    FENTON, Laurence
    188 Lubbesthorpe Road
    LE3 2XG Leicester
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    188 Lubbesthorpe Road
    LE3 2XG Leicester
    Leicestershire
    GbrBritishManagement Accountant36641710001
    FORD, Kryshia Therese
    1 Beardsley Gardens
    NG2 1QD Nottingham
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    1 Beardsley Gardens
    NG2 1QD Nottingham
    Nottinghamshire
    BritishMarketing Director74307000002
    MASSOURAS, Rosemary Jane
    235 Derby Road
    Beeston
    NG9 3AZ Nottingham
    Notts
    Geschäftsführer
    235 Derby Road
    Beeston
    NG9 3AZ Nottingham
    Notts
    BritishBusiness Manager21974390001
    MILLAR, Sophia Elizabeth
    27 Wren Court
    Sawley
    NG10 3AG Nottingham
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    27 Wren Court
    Sawley
    NG10 3AG Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritishSupport Manager107543590001
    PINSENT MASONS DIRECTOR LIMITED
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    900013290001

    Hat MIMOSA HEALTHCARE LTD Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 14. Jan. 2008
    Geliefert am 16. Jan. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a warren park nursing home, white lane, chapeltown t/no SYK340642. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC (Bos)
    Transaktionen
    • 16. Jan. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Mai 2007
    Geliefert am 25. Mai 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a pondsmead nursing home, bath road, mendip, somerset t/no ST76365. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 25. Mai 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 03. Apr. 2007
    Geliefert am 13. Apr. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to each secured finance party
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 13. Apr. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 09. Jan. 2006
    Geliefert am 10. Jan. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Castle meadows nursing home 112 dibdale road dudley west midlands. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Jan. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Apr. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 09. Jan. 2006
    Geliefert am 10. Jan. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H the willows 14 wolverhampton road codsall wolverhampton. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Jan. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Apr. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 09. Jan. 2006
    Geliefert am 10. Jan. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H nethercrest nursing home and nethercrest residential home brewster street cinder bank netherton. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Jan. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Apr. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 13. Juli 2005
    Geliefert am 15. Juli 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a orrell hall, spring road, wigan t/nos. GM368013 and GM464596. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Juli 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Apr. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 29. Juni 2005
    Geliefert am 01. Juli 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any or all of the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Hotbed Limited
    Transaktionen
    • 01. Juli 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Apr. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 29. Juni 2005
    Geliefert am 01. Juli 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Juli 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Apr. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 29. Juni 2005
    Geliefert am 01. Juli 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H wensley park nursing home wensley road new lodge barnsley t/no SYK314752. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Juli 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Apr. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 23. Dez. 2003
    Geliefert am 30. Dez. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Wensley park nursing home wensley road new lodge south yorkshire barnsley t/n SYK314752. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Dez. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Juli 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 10. Juni 2002
    Geliefert am 12. Juni 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Juni 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Juli 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge deed
    Erstellt am 12. Okt. 2000
    Geliefert am 20. Okt. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The principal sum (as defined) and all other monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under this charge
    Kurze Angaben
    Property known as wensley park nursing home wensley road new lodge barnsley; t/no SYK314752; all fixtures and all income payable thereon and all deeds/documents and all insurance monies; fixed charge over the goods and all fittings,plant and machinery and floating charge over all undertaking,property and assets whatsoever; see form 395 for details. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Northern Rock PLC
    Transaktionen
    • 20. Okt. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 03. Aug. 1999
    Geliefert am 10. Aug. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a fanum house 484 derby road nottingham nottinghamshire. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Aug. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Okt. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 15. Okt. 1987
    Erworben am 02. Nov. 2005
    Geliefert am 05. Nov. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of fixed charge all book debts and other debts and by way of floating charge all other the undertaking and all other property including its uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Nov. 2005Registrierung eines Erwerbs (400)
    • 21. Apr. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 03. Apr. 1987
    Erworben am 02. Nov. 2005
    Geliefert am 05. Nov. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a land at oswaldwistle, accrington, lancashire. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Nov. 2005Registrierung eines Erwerbs (400)
    • 21. Apr. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat MIMOSA HEALTHCARE LTD Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    24. März 2014Beginn der Verwaltung
    21. Dez. 2015Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Kerry Bailey
    3 Hardman Street
    Spinningfields
    M3 3AT Manchester
    Praktiker
    3 Hardman Street
    Spinningfields
    M3 3AT Manchester
    Sarah Megan Rayment
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Praktiker
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0