FEMCARE (HOLDINGS) LIMITED
Überblick
Unternehmensname | FEMCARE (HOLDINGS) LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 03788956 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von FEMCARE (HOLDINGS) LIMITED?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich FEMCARE (HOLDINGS) LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Femcare Uk 32 Premier Way SO51 9DQ Romsey Hampshire United Kingdom |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von FEMCARE (HOLDINGS) LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
SHARE IMAGE LIMITED | 14. Juni 1999 | 14. Juni 1999 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von FEMCARE (HOLDINGS) LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2017 |
Welche sind die letzten Einreichungen für FEMCARE (HOLDINGS) LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Widerruf des Antrags auf Löschung der Gesellschaft | 1 Seiten | DS02 | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 4 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 27. Sept. 2018
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 5 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 03. Juni 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Stuart Court Spursholt Place Salisbury Road Romsey Hampshire SO51 6DJ zum Femcare Uk 32 Premier Way Romsey Hampshire SO51 9DQ am 30. Nov. 2017 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 21 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 03. Juni 2017 mit Aktualisierungen | 6 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 03. Juni 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 19 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 14 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 03. Juni 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 03. Juni 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 13 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 03. Juni 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 12 Seiten | AA | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Adam Mcquilkin als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 03. Juni 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 8 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von FEMCARE (HOLDINGS) LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHINS, Paul Olson | Sekretär | 32 Premier Way SO51 9DQ Romsey Femcare Uk Hampshire United Kingdom | 162442870001 | |||||||
CORNWELL, Kevin Leighton | Geschäftsführer | 32 Premier Way SO51 9DQ Romsey Femcare Uk Hampshire United Kingdom | United States | American | None | 160368940001 | ||||
KOOPMAN, Brian Lee | Geschäftsführer | 32 Premier Way SO51 9DQ Romsey Femcare Uk Hampshire United Kingdom | United States | American | None | 160367730001 | ||||
RICHINS, Paul Olson | Geschäftsführer | 32 Premier Way SO51 9DQ Romsey Femcare Uk Hampshire United Kingdom | United States | American | None | 160371750001 | ||||
CAWDRON, Robert John | Sekretär | Pennine House 8 Stanford Street NG1 7BQ Nottingham Nottinghamshire | British | Solicitor | 65729370001 | |||||
MCQUILKIN, Peter Henry | Sekretär | Storthes Hall Storthes Hall Park Storthes Hall Lane, Kirkburton HD8 0PR Huddersfield | New Zealander | Director | 14958260006 | |||||
NICHOLSON, Martin James | Sekretär | 1 Northwood Rise DE6 1BF Ashbourne Derbyshire | British | Financial Director | 73143880001 | |||||
WILLIS, John Anthony | Sekretär | 3 Shepherds Way Everton SO41 0DB Lymington Hampshire | British | Accountant | 117025290001 | |||||
YORK PLACE COMPANY SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 12 York Place LS1 2DS Leeds West Yorkshire | 900000880001 | |||||||
COCOLAS, Dimitri George | Geschäftsführer | 4a Cedar Road Bedford View FOREIGN 288 Transvaal Republic Of South Africa | Greek | Director | 86928410001 | |||||
COCOLAS, George Dimitri | Geschäftsführer | 36 Hallenbach Drive Linnsfield Ridge FOREIGN Johannesburg Gauteng 2196 South Africa | South African | Analyst | 88024420001 | |||||
FILSHIE, Gilbert Marcus | Geschäftsführer | The End House Pembroke Drive NG3 5BG Nottingham Nottinghamshire | England | British | Reader | 7392650001 | ||||
JOHNSON, Peter David | Geschäftsführer | Pennine House 8 Stanford Street NG1 7BQ Nottingham | British | Solicitor | 76331040001 | |||||
LAMBRIANOS, Christos | Geschäftsführer | 27 Mavromichali Street Filothei FOREIGN Athens 152-37 Greece | Greek Cypriot | Director | 67986890002 | |||||
MCQUILKIN, Adam Peter | Geschäftsführer | Norwell Woodhouse NG23 6NG Newark Jacks Barn Nottinghamshire | England | British,New Zealander | Director | 69955890002 | ||||
MCQUILKIN, Peter Henry | Geschäftsführer | Storthes Hall Storthes Hall Park Storthes Hall Lane, Kirkburton HD8 0PR Huddersfield | New Zealander | Director | 14958260006 | |||||
NICHOLSON, Martin James | Geschäftsführer | 1 Northwood Rise DE6 1BF Ashbourne Derbyshire | England | British | Financial Director | 73143880001 | ||||
SMITH, Roy | Geschäftsführer | Silver Thatch Silver Street Hordle SO41 6DF Lymington Hampshire | United Kingdom | British | Director | 117024800001 | ||||
SWEENEY, Bernard | Geschäftsführer | Flat 3 3 South Road NG7 1EB Nottingham Nottinghamshire | British | Managing Director | 68091800002 | |||||
YORK PLACE COMPANY NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 12 York Place LS1 2DS Leeds West Yorkshire | 900000870001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei FEMCARE (HOLDINGS) LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Utah Medical Products, Inc. | 06. Apr. 2016 | 7043 South 300 West 84047 Midvale Corporate Headquarters Utah United States | Nein | ||||
| |||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat FEMCARE (HOLDINGS) LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Charge over securities | Erstellt am 18. März 2011 Geliefert am 24. März 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed charge the securities and their proceeds of sale see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Omnibus guarantee and set-off agreement | Erstellt am 27. Aug. 2004 Geliefert am 04. Sept. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 27. Aug. 2004 Geliefert am 04. Sept. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage | Erstellt am 01. Okt. 2001 Geliefert am 06. Okt. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a 63-67 saint peters street nottingham t/no nt 14425. together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0