VYKE COMMUNICATIONS (UK) LIMITED

VYKE COMMUNICATIONS (UK) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameVYKE COMMUNICATIONS (UK) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03790880
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von VYKE COMMUNICATIONS (UK) LIMITED?

    • (6420) /

    Wo befindet sich VYKE COMMUNICATIONS (UK) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    52 Brook Street
    W1K 5DS London
    United Kingdom
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von VYKE COMMUNICATIONS (UK) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    CALLSERVE COMMUNICATIONS LIMITED11. Juni 199911. Juni 1999

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von VYKE COMMUNICATIONS (UK) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2009

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für VYKE COMMUNICATIONS (UK) LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für VYKE COMMUNICATIONS (UK) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    10 Seiten4.72

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 18. Jan. 2014

    12 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 18. Jan. 2013

    10 Seiten4.68

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 18. Jan. 2012

    13 Seiten2.24B

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    1 Seiten2.34B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 12. Okt. 2011

    11 Seiten2.24B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    7 Seiten2.16B

    Ergebnis der Gläubigerversammlung

    1 Seiten2.23B

    Vorschlag des Verwalters

    49 Seiten2.17B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * 1 Harbour Exchange Square London E14 9GE United Kingdom* am 12. Mai 2011

    1 SeitenAD01

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009

    20 SeitenAA

    Ernennung von Mr Mohammad Asif als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Tommy Jensen als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 11. Juni 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital10. Aug. 2010

    Kapitalaufstellung am 10. Aug. 2010

    • Kapital: GBP 346,992
    SH01

    Beendigung der Bestellung von Kim Berknov als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * 10 Dover Street London W1S 4LQ* am 09. Dez. 2009

    1 SeitenAD01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008

    21 SeitenAA

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt

    2 SeitenAD03

    Die Adresse der Registerinspektion wurde geändert

    2 SeitenAD02

    Beendigung der Bestellung von Kjetil Bohn als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    4 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288b

    Wer sind die Geschäftsführer von VYKE COMMUNICATIONS (UK) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    ZANDEGIACOMO, Florio Rodolfo
    Shrewsbury Road
    RH1 6BH Redhill
    7
    Surrey
    Sekretär
    Shrewsbury Road
    RH1 6BH Redhill
    7
    Surrey
    British133799200001
    ASIF, Mohammad
    Brook Street
    W1K 5DS London
    52
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Brook Street
    W1K 5DS London
    52
    United Kingdom
    UsaAmerican155095150001
    BACCHUS, Malcolm Graham
    92 Jerningham Road
    Telegraph Hill
    SE14 5NW London
    Geschäftsführer
    92 Jerningham Road
    Telegraph Hill
    SE14 5NW London
    EnglandBritish53857330001
    BACCHUS, Malcolm Graham
    92 Jerningham Road
    Telegraph Hill
    SE14 5NW London
    Sekretär
    92 Jerningham Road
    Telegraph Hill
    SE14 5NW London
    British53857330001
    FERGUSON, Katherine Jane
    Stephendale Road
    Fulham
    SW6 2PH London
    110
    Sekretär
    Stephendale Road
    Fulham
    SW6 2PH London
    110
    British194527100001
    HENWOOD, Jeremy
    18 Gannet Close
    RG22 5QN Basingstoke
    Hampshire
    Sekretär
    18 Gannet Close
    RG22 5QN Basingstoke
    Hampshire
    British75590330001
    KUTTNER, Richard Clive
    77 Deodar Road
    SW15 2NU London
    Sekretär
    77 Deodar Road
    SW15 2NU London
    British6851110002
    KUTTNER, Richard Clive
    77 Deodar Road
    SW15 2NU London
    Sekretär
    77 Deodar Road
    SW15 2NU London
    British6851110002
    NEWTON, Simon
    103 Edith Road
    W14 0TJ London
    Sekretär
    103 Edith Road
    W14 0TJ London
    British71522630001
    PALMER, Neil Richard
    9 Blue House Lane
    RH8 0AA Oxted
    Surrey
    Sekretär
    9 Blue House Lane
    RH8 0AA Oxted
    Surrey
    British69100110003
    TAYLOR, John James
    Ben Sayers Park
    North Berwick
    EH39 5PT Edinburgh
    19
    East Lothian
    Sekretär
    Ben Sayers Park
    North Berwick
    EH39 5PT Edinburgh
    19
    East Lothian
    British138774840001
    THOMAS, Howard
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    Bevollmächtigter Sekretär
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British900000900001
    AHMED, Ajaz
    18 Wheathouse Road
    Birkby
    HD2 2UN Huddersfield
    Yorkshire
    Geschäftsführer
    18 Wheathouse Road
    Birkby
    HD2 2UN Huddersfield
    Yorkshire
    EnglandBritish52850040001
    BEATON, Andrew Laurie
    3 Manor Road
    TW11 8BH Teddington
    Middlesex
    Geschäftsführer
    3 Manor Road
    TW11 8BH Teddington
    Middlesex
    United KingdomBritish18079130002
    BERKNOV, Kim
    19 Enmore Gardens
    East Sheen
    SW14 8RF London
    Geschäftsführer
    19 Enmore Gardens
    East Sheen
    SW14 8RF London
    United KingdomDanish106297960001
    BOHN, Kjetil Langland
    Emanuelvei 14
    FOREIGN Oslo
    0167
    Norway
    Geschäftsführer
    Emanuelvei 14
    FOREIGN Oslo
    0167
    Norway
    Norwegian123273530001
    BRADLEY, Daniel Thomas
    188 Elsley Road
    SW11 5LQ London
    Geschäftsführer
    188 Elsley Road
    SW11 5LQ London
    United KingdomBritish149950480001
    COOK, Simon Christopher
    The Thatched Barn
    Heydon Lane, Heydon
    SG8 8QB Royston
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    The Thatched Barn
    Heydon Lane, Heydon
    SG8 8QB Royston
    Hertfordshire
    EnglandBritish79137930001
    CROSS, Fiona Marianne
    98 Clifden Court
    Clifden Road
    TW1 4LR Twickenham
    Middlesex
    Geschäftsführer
    98 Clifden Court
    Clifden Road
    TW1 4LR Twickenham
    Middlesex
    British56042890002
    DUFFY, Paul
    69 Anchorage Point
    Cuba Street
    E14 8NF London
    Geschäftsführer
    69 Anchorage Point
    Cuba Street
    E14 8NF London
    British65626530002
    FERGUSON, Katherine Jane
    Stephendale Road
    Fulham
    SW6 2PH London
    110
    Geschäftsführer
    Stephendale Road
    Fulham
    SW6 2PH London
    110
    EnglandBritish194527100001
    HOWSHIP, Simon Barrie
    The Old Coach House
    8 The Drive
    BD13 4DY Long Causeway
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    The Old Coach House
    8 The Drive
    BD13 4DY Long Causeway
    West Yorkshire
    EnglandBritish138245410001
    JENSEN, Tommy Boserup
    Stjernveien 24b 0779
    FOREIGN Oslo
    Norway
    Geschäftsführer
    Stjernveien 24b 0779
    FOREIGN Oslo
    Norway
    NorwayDanish106297740001
    KUTTNER, Richard Clive
    77 Deodar Road
    SW15 2NU London
    Geschäftsführer
    77 Deodar Road
    SW15 2NU London
    EnglandBritish6851110002
    KUTTNER, Richard Clive
    77 Deodar Road
    SW15 2NU London
    Geschäftsführer
    77 Deodar Road
    SW15 2NU London
    EnglandBritish6851110002
    MACECHERN, Gavin Macalister
    34-36 Gertrude Street
    SW10 0JG London
    Geschäftsführer
    34-36 Gertrude Street
    SW10 0JG London
    British67172770001
    NEWTON, Simon
    103 Edith Road
    W14 0TJ London
    Geschäftsführer
    103 Edith Road
    W14 0TJ London
    British71522630001
    PALMER, Neil Richard
    9 Blue House Lane
    RH8 0AA Oxted
    Surrey
    Geschäftsführer
    9 Blue House Lane
    RH8 0AA Oxted
    Surrey
    United KingdomBritish69100110003
    PIPE, Sharon Louise Elizabeth
    Summers Farm
    RG29 1TQ Long Sutton
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Summers Farm
    RG29 1TQ Long Sutton
    Hampshire
    United KingdomBritish70239330005
    SNOW, Alexander Charles Wallace
    6-7 Vicarage Gate
    W8 6QT London
    Geschäftsführer
    6-7 Vicarage Gate
    W8 6QT London
    British76001930001
    TAYLOR, John James
    Ben Sayers Park
    North Berwick
    EH39 5PT Edinburgh
    19
    East Lothian
    Geschäftsführer
    Ben Sayers Park
    North Berwick
    EH39 5PT Edinburgh
    19
    East Lothian
    ScotlandBritish138774840001
    TAYLOR, Nigel Mark
    35 Vine Street
    EC3N 2PX London
    Geschäftsführer
    35 Vine Street
    EC3N 2PX London
    British67856660002
    TESTER, William Andrew Joseph
    4 Geary House
    Georges Road
    N7 8EZ London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    4 Geary House
    Georges Road
    N7 8EZ London
    United KingdomBritish900000890001
    WEINSTEIN, Adam K.
    642 Ibis Drive
    Delray Beach 33444
    FOREIGN Florida
    Usa
    Geschäftsführer
    642 Ibis Drive
    Delray Beach 33444
    FOREIGN Florida
    Usa
    Usa69313550001
    WHENT, Peter John
    Chapel Lane
    SP11 8JP Grateley
    Grateley Lodge
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Chapel Lane
    SP11 8JP Grateley
    Grateley Lodge
    Hampshire
    United KingdomBritish131769110001

    Hat VYKE COMMUNICATIONS (UK) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 19. Aug. 2004
    Geliefert am 24. Aug. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All property, assets, undertakings, subject to the agreement between the company and each holder of the loan notes, which provides inter alia for the distribution of any funds realised by the enforcem. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • John P Greenwood
    Transaktionen
    • 24. Aug. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Feb. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 09. Aug. 2004
    Geliefert am 11. Aug. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Greenwood Nominees Limited
    Transaktionen
    • 11. Aug. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Feb. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 09. Juni 2004
    Geliefert am 15. Juni 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Gavin M Macechern
    Transaktionen
    • 15. Juni 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Feb. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 01. Juni 2004
    Geliefert am 08. Juni 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Kbc Peel Hunt Limited
    Transaktionen
    • 08. Juni 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Feb. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 01. Juni 2004
    Geliefert am 08. Juni 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Neville David Buch
    Transaktionen
    • 08. Juni 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Feb. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 14. Apr. 2004
    Geliefert am 24. Apr. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Notes and all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Richard C Kuttner
    Transaktionen
    • 24. Apr. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Feb. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 24. März 2004
    Geliefert am 05. Apr. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Notes and all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Paul Stuart Kuttner
    Transaktionen
    • 05. Apr. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Feb. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 24. März 2004
    Geliefert am 31. März 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Timothy J Davies
    Transaktionen
    • 31. März 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Feb. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 24. März 2004
    Geliefert am 31. März 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Southwind Limited
    Transaktionen
    • 31. März 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Feb. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 24. März 2004
    Geliefert am 31. März 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Bigport Limited
    Transaktionen
    • 31. März 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Feb. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 24. März 2004
    Geliefert am 31. März 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Warren a Furneaux
    Transaktionen
    • 31. März 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Feb. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 16. Okt. 2003
    Geliefert am 28. Okt. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Glenn Williams
    Transaktionen
    • 28. Okt. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Feb. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 30. Juni 2003
    Geliefert am 02. Juli 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Jeremy Henwood
    Transaktionen
    • 02. Juli 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Feb. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 30. Juni 2003
    Geliefert am 02. Juli 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Steven Davies
    Transaktionen
    • 02. Juli 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Feb. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 30. Juni 2003
    Geliefert am 02. Juli 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Warren a Furneaux
    Transaktionen
    • 02. Juli 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Feb. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 30. Juni 2003
    Geliefert am 02. Juli 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bigport Limited
    Transaktionen
    • 02. Juli 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Feb. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 30. Juni 2003
    Geliefert am 02. Juli 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Timothy J Davies
    Transaktionen
    • 02. Juli 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Feb. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 30. Juni 2003
    Geliefert am 02. Juli 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Kbc Peel Hunt Limited
    Transaktionen
    • 02. Juli 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Feb. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 11. Juni 2003
    Geliefert am 18. Juni 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £4,553,333 convertible secured loan notes 2004 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Th Lee Putnam Nominee Limited
    Transaktionen
    • 18. Juni 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Feb. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 12. März 2003
    Geliefert am 14. März 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Gavin Macechern
    Transaktionen
    • 14. März 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Feb. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 12. März 2003
    Geliefert am 14. März 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • John Paul Greenwood
    Transaktionen
    • 14. März 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Feb. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 06. März 2003
    Geliefert am 08. März 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Greenwood Nominees Limited
    Transaktionen
    • 08. März 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Feb. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 05. März 2003
    Geliefert am 07. März 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Alexander Charles Wallace Snow
    Transaktionen
    • 07. März 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Feb. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Further charge
    Erstellt am 05. März 2003
    Geliefert am 07. März 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • T H Lee Putnam Nominee Limited
    Transaktionen
    • 07. März 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Feb. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 05. März 2003
    Geliefert am 07. März 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Groundlinks Limited
    Transaktionen
    • 07. März 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Feb. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat VYKE COMMUNICATIONS (UK) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    13. Apr. 2011Beginn der Verwaltung
    19. Jan. 2012Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Stephen Robert Leslie Cork
    Cork Gully Llp 52 Brook Street
    W1K 5DS London
    Praktiker
    Cork Gully Llp 52 Brook Street
    W1K 5DS London
    Joanne Elizabeth Milner
    Cork Gully Llp 52 Brook Street
    W1K 5DS London
    Praktiker
    Cork Gully Llp 52 Brook Street
    W1K 5DS London
    2
    DatumTyp
    19. Jan. 2012Beginn der Liquidation
    16. Aug. 2014Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Stephen Robert Leslie Cork
    Cork Gully Llp 52 Brook Street
    W1K 5DS London
    Praktiker
    Cork Gully Llp 52 Brook Street
    W1K 5DS London
    Joanne Elizabeth Milner
    Cork Gully Llp 52 Brook Street
    W1K 5DS London
    Praktiker
    Cork Gully Llp 52 Brook Street
    W1K 5DS London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0