COUNTRY RETIREMENT LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCOUNTRY RETIREMENT LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03798558
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von COUNTRY RETIREMENT LIMITED?

    • Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen

    Wo befindet sich COUNTRY RETIREMENT LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Rydon House
    Station Road
    RH18 5DW Forest Row
    East Sussex
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von COUNTRY RETIREMENT LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    SOUTHWOLD COMPUTING LIMITED30. Juni 199930. Juni 1999

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von COUNTRY RETIREMENT LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2015

    Welche sind die letzten Einreichungen für COUNTRY RETIREMENT LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresrückblick erstellt bis 17. Juni 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital20. Juni 2016

    Kapitalaufstellung am 20. Juni 2016

    • Kapital: GBP 3
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2015

    14 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Juni 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital08. Juli 2015

    Kapitalaufstellung am 08. Juli 2015

    • Kapital: GBP 3
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2014

    13 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Mr Warwick James Barnes am 02. März 2015

    2 SeitenCH01

    Erfüllung der Belastung 037985580003 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 2 vollständig

    2 SeitenMR04

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Juni 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital03. Juli 2014

    Kapitalaufstellung am 03. Juli 2014

    • Kapital: GBP 3
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Robert Bond am 29. Juni 2014

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Warwick James Barnes am 29. Juni 2014

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2013

    13 SeitenAA

    Eintragung der Belastung 037985580005

    37 SeitenMR01

    Beschlüsse

    Resolutions
    23 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Facility agreement/deliver finance documents/directors conflict of interest 27/11/2013
    RES13
    incorporation

    Beschluss zur Satzung und/oder Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    Eintragung der Belastung 037985580004

    26 SeitenMR01

    Ernennung von Mr Antony David Wilkinson als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Paul Wright als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Eintragung der Belastung 037985580003

    7 SeitenMR01

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Juni 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Beendigung der Bestellung von John Kitchin als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Peter Masters als Sekretär

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Paul Wright als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2012

    13 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von COUNTRY RETIREMENT LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    MASTERS, Peter
    Station Road
    RH18 5DW Forest Row
    Rydon House
    East Sussex
    England
    Sekretär
    Station Road
    RH18 5DW Forest Row
    Rydon House
    East Sussex
    England
    175253230001
    BARNES, Warwick James
    Station Road
    RH18 5DW Forest Row
    Rydon House
    East Sussex
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Station Road
    RH18 5DW Forest Row
    Rydon House
    East Sussex
    United Kingdom
    United KingdomBritish194511260001
    BOND, Robert
    Station Road
    RH18 5DW Forest Row
    Rydon House
    East Sussex
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Station Road
    RH18 5DW Forest Row
    Rydon House
    East Sussex
    United Kingdom
    EnglandBritish110448850001
    CHASE, James
    Station Road
    RH18 5DW Forest Row
    Rydon House
    East Sussex
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Station Road
    RH18 5DW Forest Row
    Rydon House
    East Sussex
    United Kingdom
    United KingdomBritish158456450001
    WILKINSON, Antony David
    Station Road
    RH18 5DW Forest Row
    Rydon House
    East Sussex
    England
    Geschäftsführer
    Station Road
    RH18 5DW Forest Row
    Rydon House
    East Sussex
    England
    EnglandBritish173832310002
    DENNARD, Gwendoline
    Fairlawn
    Wildernesse Avenue
    TN15 0EA Sevenoaks
    Kent
    Sekretär
    Fairlawn
    Wildernesse Avenue
    TN15 0EA Sevenoaks
    Kent
    British71705100002
    WRIGHT, Paul Timothy
    Stonescot
    83 Janes Lane
    RH15 0QP Burgess Hill
    West Sussex
    Sekretär
    Stonescot
    83 Janes Lane
    RH15 0QP Burgess Hill
    West Sussex
    British18853840003
    STARTCO LIMITED
    18 The Steyne
    PO21 1TP Bognor Regis
    West Sussex
    Bevollmächtigter Sekretär
    18 The Steyne
    PO21 1TP Bognor Regis
    West Sussex
    900009720001
    DENNARD, Gwendoline
    Fairlawn
    Wildernesse Avenue
    TN15 0EA Sevenoaks
    Kent
    Geschäftsführer
    Fairlawn
    Wildernesse Avenue
    TN15 0EA Sevenoaks
    Kent
    British71705100002
    KITCHIN, John Edward
    Westbury
    Old Lane St Johns
    TN6 1RX Crowborough
    East Sussex
    Geschäftsführer
    Westbury
    Old Lane St Johns
    TN6 1RX Crowborough
    East Sussex
    United KingdomBritish78449180001
    NELSON, Hilary
    8-9 Ship Street
    BN1 1AZ Brighton
    East Sussex
    Geschäftsführer
    8-9 Ship Street
    BN1 1AZ Brighton
    East Sussex
    British67888950001
    TURNER, Gary Marshall
    42 Havelock Road
    BN1 6GF Brighton
    East Sussex
    Geschäftsführer
    42 Havelock Road
    BN1 6GF Brighton
    East Sussex
    British72224550001
    WRIGHT, Paul Timothy
    Stonescot
    83 Janes Lane
    RH15 0QP Burgess Hill
    West Sussex
    Geschäftsführer
    Stonescot
    83 Janes Lane
    RH15 0QP Burgess Hill
    West Sussex
    United KingdomBritish18853840003
    NEWCO LIMITED
    18 The Steyne
    PO21 1TP Bognor Regis
    Sussex
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    18 The Steyne
    PO21 1TP Bognor Regis
    Sussex
    900009710001

    Hat COUNTRY RETIREMENT LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 29. Nov. 2013
    Geliefert am 09. Dez. 2013
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    1. all registered or unregistered estates and interests in freehold and leasehold properties at or after the date of the charge owned by country retirement limited (the “company”) or in which the company has an interest from time to time (the “real property”); and. 2. the following assets (wherever located) at or after the date of the charge vested in or belonging to the company or in which the company has an interest from time to time:. (A) all other real property not effectively mortgaged or charged by paragraph 1 above; and. (B) any present or future interests (whether legal or equitable, and including the benefit of all licences) relating to any registered or unregistered trade marks, patents, copyrights, design rights, domain names, business names, confidential information, know-how and other intellectual property rights together with the rights to use any of the foregoing.. Notification of addition to or amendment of charge.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Robert Bond
    Transaktionen
    • 09. Dez. 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 29. Nov. 2013
    Geliefert am 03. Dez. 2013
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 03. Dez. 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 06. Nov. 2013
    Geliefert am 12. Nov. 2013
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Charges. 1) by way of legal mortgage the freehold property known as 42 the hill, littlebourne, canterbury CT3 1TA and registered at hm land registry under title number K802134 (“the property” together with all present and future buildings, fixtures (including trade and tenant’s fixtures) which are at any time on or attached to the property.. 2) by way of fixed charge over goodwill relating to the property or in the business or undertaking conducted at the property. 3) by way of a fixed charge all plant, machinery and other items attached to and forming part of the property on or at any time after the date of the legal charge. 4) by way of assignment the rental sums together with the benefit of all rights and remedies of the borrower relating to them to hold bos absolutely subject to the redemption upon repayment of the secured liabilities,. 5) by way of fixed charge all rights and interests in and claims made under any insurance policy relating to any of the property charge under the charge; and. 6) by way of a floating charge all unattached plant, machinery, chattels and goods now or at any time after the date of the legal charge on or in or used in connection with the property or the business or undertaking conducted at the property. Where –. “rental sums” means all rents profits income fees and other sums at any time payable by the lessees underlessees tenant or licensees of the property to the company pursuant to the terms of any agreements for lease leases underleases tenancies or licences to which all or any part of the property is subject but not any sums payable in respect of services provided by lessees underlessees tenants or licensees or payable in respect of insurance premiums or reasonable professional fees or expenses. Restriction on charges and disposal. 1) the company may not create or attempt to create or allow to be created or to exist any charge (whether fixed or floating) or lien or any king over the property (except in favour of bos without the prior written consent of bos. 2) the company may not sell transfer lease or otherwise dispose of all or any part of the property to agree to do so, whether at law or in equity, without the prior written consent of bos. Further assurances. The legal charge contains a further assurance provision requiring the company whenever required by bos to do anything and sign and deliver all deeds, instruments, notices and documents of any kind, in such form as bos may require, in order to enhance or perfect bos’s security under the legal charge, or to preserve the property or to enable bos to enforce the legal charge or exercise any of the powers and rights given to bos by the conditions or by law to bos or the receiver.. Notification of addition to or amendment of charge.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 12. Nov. 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 27. Jan. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 09. März 2006
    Geliefert am 22. März 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the security beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    42 the hill littlebourne canterbury kent t/no H802134. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (In Its Capacity as Security Trustee for the Security Beneficiaries) (the Security Trustee)
    Transaktionen
    • 22. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Jan. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 29. Sept. 2000
    Geliefert am 30. Sept. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    42 the hill littlebourne canterbury kent t/n K802134.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transaktionen
    • 30. Sept. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. März 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0