COUNTRY RETIREMENT LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | COUNTRY RETIREMENT LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03798558 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von COUNTRY RETIREMENT LIMITED?
- Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen
Wo befindet sich COUNTRY RETIREMENT LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Rydon House Station Road RH18 5DW Forest Row East Sussex |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von COUNTRY RETIREMENT LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| SOUTHWOLD COMPUTING LIMITED | 30. Juni 1999 | 30. Juni 1999 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von COUNTRY RETIREMENT LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2015 |
Welche sind die letzten Einreichungen für COUNTRY RETIREMENT LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 17. Juni 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2015 | 14 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Juni 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2014 | 13 Seiten | AA | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Warwick James Barnes am 02. März 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 037985580003 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 2 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Juni 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Robert Bond am 29. Juni 2014 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Warwick James Barnes am 29. Juni 2014 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2013 | 13 Seiten | AA | ||||||||||||||
Eintragung der Belastung 037985580005 | 37 Seiten | MR01 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 23 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Eintragung der Belastung 037985580004 | 26 Seiten | MR01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Antony David Wilkinson als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Paul Wright als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Eintragung der Belastung 037985580003 | 7 Seiten | MR01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Juni 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von John Kitchin als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Peter Masters als Sekretär | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Paul Wright als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2012 | 13 Seiten | AA | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von COUNTRY RETIREMENT LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTERS, Peter | Sekretär | Station Road RH18 5DW Forest Row Rydon House East Sussex England | 175253230001 | |||||||
| BARNES, Warwick James | Geschäftsführer | Station Road RH18 5DW Forest Row Rydon House East Sussex United Kingdom | United Kingdom | British | 194511260001 | |||||
| BOND, Robert | Geschäftsführer | Station Road RH18 5DW Forest Row Rydon House East Sussex United Kingdom | England | British | 110448850001 | |||||
| CHASE, James | Geschäftsführer | Station Road RH18 5DW Forest Row Rydon House East Sussex United Kingdom | United Kingdom | British | 158456450001 | |||||
| WILKINSON, Antony David | Geschäftsführer | Station Road RH18 5DW Forest Row Rydon House East Sussex England | England | British | 173832310002 | |||||
| DENNARD, Gwendoline | Sekretär | Fairlawn Wildernesse Avenue TN15 0EA Sevenoaks Kent | British | 71705100002 | ||||||
| WRIGHT, Paul Timothy | Sekretär | Stonescot 83 Janes Lane RH15 0QP Burgess Hill West Sussex | British | 18853840003 | ||||||
| STARTCO LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 18 The Steyne PO21 1TP Bognor Regis West Sussex | 900009720001 | |||||||
| DENNARD, Gwendoline | Geschäftsführer | Fairlawn Wildernesse Avenue TN15 0EA Sevenoaks Kent | British | 71705100002 | ||||||
| KITCHIN, John Edward | Geschäftsführer | Westbury Old Lane St Johns TN6 1RX Crowborough East Sussex | United Kingdom | British | 78449180001 | |||||
| NELSON, Hilary | Geschäftsführer | 8-9 Ship Street BN1 1AZ Brighton East Sussex | British | 67888950001 | ||||||
| TURNER, Gary Marshall | Geschäftsführer | 42 Havelock Road BN1 6GF Brighton East Sussex | British | 72224550001 | ||||||
| WRIGHT, Paul Timothy | Geschäftsführer | Stonescot 83 Janes Lane RH15 0QP Burgess Hill West Sussex | United Kingdom | British | 18853840003 | |||||
| NEWCO LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 18 The Steyne PO21 1TP Bognor Regis Sussex | 900009710001 |
Hat COUNTRY RETIREMENT LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 29. Nov. 2013 Geliefert am 09. Dez. 2013 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung 1. all registered or unregistered estates and interests in freehold and leasehold properties at or after the date of the charge owned by country retirement limited (the “company”) or in which the company has an interest from time to time (the “real property”); and. 2. the following assets (wherever located) at or after the date of the charge vested in or belonging to the company or in which the company has an interest from time to time:. (A) all other real property not effectively mortgaged or charged by paragraph 1 above; and. (B) any present or future interests (whether legal or equitable, and including the benefit of all licences) relating to any registered or unregistered trade marks, patents, copyrights, design rights, domain names, business names, confidential information, know-how and other intellectual property rights together with the rights to use any of the foregoing.. Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 29. Nov. 2013 Geliefert am 03. Dez. 2013 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 06. Nov. 2013 Geliefert am 12. Nov. 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Charges. 1) by way of legal mortgage the freehold property known as 42 the hill, littlebourne, canterbury CT3 1TA and registered at hm land registry under title number K802134 (“the property” together with all present and future buildings, fixtures (including trade and tenant’s fixtures) which are at any time on or attached to the property.. 2) by way of fixed charge over goodwill relating to the property or in the business or undertaking conducted at the property. 3) by way of a fixed charge all plant, machinery and other items attached to and forming part of the property on or at any time after the date of the legal charge. 4) by way of assignment the rental sums together with the benefit of all rights and remedies of the borrower relating to them to hold bos absolutely subject to the redemption upon repayment of the secured liabilities,. 5) by way of fixed charge all rights and interests in and claims made under any insurance policy relating to any of the property charge under the charge; and. 6) by way of a floating charge all unattached plant, machinery, chattels and goods now or at any time after the date of the legal charge on or in or used in connection with the property or the business or undertaking conducted at the property. Where –. “rental sums” means all rents profits income fees and other sums at any time payable by the lessees underlessees tenant or licensees of the property to the company pursuant to the terms of any agreements for lease leases underleases tenancies or licences to which all or any part of the property is subject but not any sums payable in respect of services provided by lessees underlessees tenants or licensees or payable in respect of insurance premiums or reasonable professional fees or expenses. Restriction on charges and disposal. 1) the company may not create or attempt to create or allow to be created or to exist any charge (whether fixed or floating) or lien or any king over the property (except in favour of bos without the prior written consent of bos. 2) the company may not sell transfer lease or otherwise dispose of all or any part of the property to agree to do so, whether at law or in equity, without the prior written consent of bos. Further assurances. The legal charge contains a further assurance provision requiring the company whenever required by bos to do anything and sign and deliver all deeds, instruments, notices and documents of any kind, in such form as bos may require, in order to enhance or perfect bos’s security under the legal charge, or to preserve the property or to enable bos to enforce the legal charge or exercise any of the powers and rights given to bos by the conditions or by law to bos or the receiver.. Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 09. März 2006 Geliefert am 22. März 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the security beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben 42 the hill littlebourne canterbury kent t/no H802134. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 29. Sept. 2000 Geliefert am 30. Sept. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 42 the hill littlebourne canterbury kent t/n K802134. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0