CHANDLERS PRINTERS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCHANDLERS PRINTERS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03800339
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CHANDLERS PRINTERS LIMITED?

    • (2222) /

    Wo befindet sich CHANDLERS PRINTERS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    c/o MBI COAKLEY LTD
    Second Floor 98-110 Tunsgate Square High Street
    GU1 3HE Guildford
    Surrey
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von CHANDLERS PRINTERS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    BASICFRAME LIMITED05. Juli 199905. Juli 1999

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CHANDLERS PRINTERS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2007

    Welche sind die letzten Einreichungen für CHANDLERS PRINTERS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    3 Seiten4.72

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 30. Okt. 2011

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 30. Apr. 2011

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 31. Okt. 2010

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 30. Apr. 2010

    5 Seiten4.68

    Vermögensübersicht mit Formular 4.19

    7 Seiten4.20

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren am 01. Mai 2009

    LRESEX

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    7 Seiten363s
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    annual-return14. Okt. 2008

    legacy

    363(288)

    legacy

    5 Seiten395

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2007

    15 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten403a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2006

    17 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten395

    legacy

    1 Seiten225

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    4 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288c

    Wer sind die Geschäftsführer von CHANDLERS PRINTERS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BURR, David John
    45 Kings Drive
    DA12 5BQ Gravesend
    Kent
    Sekretär
    45 Kings Drive
    DA12 5BQ Gravesend
    Kent
    British7599780001
    BURR, David John
    45 Kings Drive
    DA12 5BQ Gravesend
    Kent
    Geschäftsführer
    45 Kings Drive
    DA12 5BQ Gravesend
    Kent
    UkBritish7599780001
    GOULDING, Michael David
    35 St. Peters Road
    BN25 2HP Seaford
    Flint House
    East Sussex
    Geschäftsführer
    35 St. Peters Road
    BN25 2HP Seaford
    Flint House
    East Sussex
    British135943830001
    HOLMES, Nigel David
    Flat 2
    11 The Martlet
    BN3 6NT Hove
    East Sussex
    Geschäftsführer
    Flat 2
    11 The Martlet
    BN3 6NT Hove
    East Sussex
    EnglandBritish24756150004
    OGILVIE, Claire Elizabeth
    6 Amherst Road
    TN40 1QJ Bexhill On Sea
    East Sussex
    Sekretär
    6 Amherst Road
    TN40 1QJ Bexhill On Sea
    East Sussex
    British67972540002
    M W DOUGLAS & COMPANY LIMITED
    Regent House
    316 Beulah Hill
    SE19 3HP London
    Bevollmächtigter Sekretär
    Regent House
    316 Beulah Hill
    SE19 3HP London
    900007890001
    HOLLAMBY, Stephen Frank
    16 Collington Avenue
    TN39 3QA Bexhill On Sea
    East Sussex
    Geschäftsführer
    16 Collington Avenue
    TN39 3QA Bexhill On Sea
    East Sussex
    British19669180001
    DOUGLAS NOMINEES LIMITED
    Regent House
    316 Beulah Hill
    SE19 3HF London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Regent House
    316 Beulah Hill
    SE19 3HF London
    900007880001

    Hat CHANDLERS PRINTERS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 30. Juli 2008
    Geliefert am 08. Aug. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transaktionen
    • 08. Aug. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    All assets debenture
    Erstellt am 20. Dez. 2006
    Geliefert am 22. Dez. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transaktionen
    • 22. Dez. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 19. Dez. 2005
    Geliefert am 20. Dez. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Dez. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Mai 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 29. Sept. 2004
    Geliefert am 02. Okt. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of second fixed charge all book debts and other debts,floating charge all book debts and other debts now and from time to time due.
    Berechtigte Personen
    • The Paper Company Limited
    Transaktionen
    • 02. Okt. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Feb. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    All assets debenture
    Erstellt am 17. Juni 2004
    Geliefert am 30. Juni 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All assets of the company by way of a first fixed and floating charge.
    Berechtigte Personen
    • Eurofactor (UK) Limited
    Transaktionen
    • 30. Juni 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Feb. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 15. Juni 2004
    Geliefert am 17. Juni 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Twenty thousand pounds due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Saxon mews reginald road bexhill on sea east sussex.
    Berechtigte Personen
    • Steven Frank Hollamby and Sarah Josephine Mary Hollamby
    Transaktionen
    • 17. Juni 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Mai 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 12. Aug. 2003
    Geliefert am 13. Aug. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Thirty thousand pounds due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Saxon mews reginald road bexhill on sea east sussex TN39 3PJ.
    Berechtigte Personen
    • Steven Frank Hollamby and Sarah Josephine Mary Hollamby and Arbuthnot Pension Trustees Limited
    Transaktionen
    • 13. Aug. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Mai 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 08. Nov. 2002
    Geliefert am 22. Nov. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Five Arrows Commercial Finance Limited
    Transaktionen
    • 22. Nov. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Juli 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 07. Aug. 2002
    Geliefert am 08. Aug. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property k/a saxon mews, reginald road, bexhill on sea, rother east sussex t/no. ESX239371. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Mai 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 25. Juli 2002
    Geliefert am 06. Aug. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Feb. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    All assets debenture
    Erstellt am 13. Dez. 1999
    Geliefert am 15. Dez. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transaktionen
    • 15. Dez. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Juni 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    All assets debenture
    Erstellt am 17. Aug. 1999
    Geliefert am 24. Aug. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over all assets of the company.
    Berechtigte Personen
    • Alex Lawrie Receivables Financing Limited
    Transaktionen
    • 24. Aug. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Aug. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat CHANDLERS PRINTERS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    01. Mai 2009Beginn der Liquidation
    26. Apr. 2012Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Michael Timothy Bowell
    Second Floor Tunsgate Square 98-110 High Street
    GU1 3HE Guildford
    Surrey
    Praktiker
    Second Floor Tunsgate Square 98-110 High Street
    GU1 3HE Guildford
    Surrey
    Dermot Brendan Coakley
    Second Floor, Tunsgate Square 98-110 High Street
    GU1 3HE Guildford
    Surrey
    Praktiker
    Second Floor, Tunsgate Square 98-110 High Street
    GU1 3HE Guildford
    Surrey

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0