CLAIMAR CARE LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | CLAIMAR CARE LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03801649 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CLAIMAR CARE LIMITED?
- Sonstige menschliche Gesundheitsaktivitäten (86900) / Gesundheits- und Sozialwesen
Wo befindet sich CLAIMAR CARE LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Tricorn House 51-53 Hagley Road B16 8TP Birmingham |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CLAIMAR CARE LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2022 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CLAIMAR CARE LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt | 1 Seiten | DISS40 | ||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. März 2022 | 3 Seiten | AA | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 28. Juni 2022 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. März 2021 | 3 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 28. Juni 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Beendigung der Bestellung von Paul David James Weston als Geschäftsführer am 25. Sept. 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||
Geänderte Konten eines Mikrounternehmens erstellt bis 31. März 2020 | 6 Seiten | AAMD | ||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. März 2020 | 3 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 06. Juli 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. März 2019 | 2 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 06. Juli 2019 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. März 2018 | 2 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 06. Juli 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. März 2017 | 2 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 06. Juli 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Notification of a person with significant control statement | 2 Seiten | PSC08 | ||
Cessation of Housing & Care 21 as a person with significant control on 06. Apr. 2016 | 1 Seiten | PSC07 | ||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. März 2016 | 2 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 06. Juli 2016 mit Aktualisierungen | 6 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. März 2015 | 2 Seiten | AA | ||
Wer sind die Geschäftsführer von CLAIMAR CARE LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUTTON, Paul Marcus | Sekretär | 51-53 Hagley Road B16 8TP Birmingham Tricorn House England | 183500140001 | |||||||
| MOORE, Bruce John | Geschäftsführer | 51-53 Hagley Road B16 8TP Birmingham Tricorn House England | England | British | 117919920001 | |||||
| BATEMAN, Stephen John | Sekretär | c/o C/O Housing21 Baring Road HP9 2NA Beaconsfield The Triangle Buckinghamshire England | 176476120001 | |||||||
| BRUNT, Sarah | Sekretär | Avoncroft Road Stoke Heath B60 4NG Bromsgrove 67 West Midlands | British | 130638250001 | ||||||
| CEASER, James Terence | Sekretär | 31 St Laurence Road Northfield B31 2AU Birmingham West Midlands | British | 102169390001 | ||||||
| CEASER, James Terence | Sekretär | 31 Saint Laurance Road Northfield B31 2AU Birmingham West Midlands | British | 77324780001 | ||||||
| GUEST, Anthony | Sekretär | Chase House The Orchards Four Oaks B74 2PP Sutton Coldfield West Midlands | British | 15349990002 | ||||||
| HAMPTON, Sarah Delyth | Sekretär | c/o C/O Housing21 Baring Road HP9 2NA Beaconsfield The Triangle Buckinghamshire England | 151898390001 | |||||||
| HOPWOOD, Joseph William | Sekretär | Pavement Cottage Park Road GL55 6EA Chipping Campden Gloucestershire | British | 73294850001 | ||||||
| JACKSON, David | Sekretär | Institute Cottage Church Road Great Milton OX44 7PD Oxford Oxfordshire | British | 280628560001 | ||||||
| LUXTON, Claire | Sekretär | c/o C/O Housing21 Baring Road HP9 2NA Beaconsfield The Triangle Buckinghamshire England | 171459770001 | |||||||
| TOWNEND, Nicholas Adam | Sekretär | c/o C/O Housing21 Baring Road HP9 2NA Beaconsfield The Triangle Buckinghamshire England | British | 154577090001 | ||||||
| TEMPLE SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 788-790 Finchley Road NW11 7TJ London | 900001120001 | |||||||
| CEASER, James Terence | Geschäftsführer | 31 Saint Laurance Road Northfield B31 2AU Birmingham West Midlands | British | 77324780001 | ||||||
| GUEST, Anthony | Geschäftsführer | Chase House The Orchards Four Oaks B74 2PP Sutton Coldfield West Midlands | England | British | 15349990002 | |||||
| HALES, Claire Louise | Geschäftsführer | 88 Bunbury Road Northfield B31 2DW Birmingham West Midlands | British | 77324770001 | ||||||
| HALES, Mark | Geschäftsführer | 40 Vicarage Road Edgbaston B15 3EZ Birmingham Claimar House West Midlands | England | British | 115420980001 | |||||
| HARDISTY, Cheryl | Geschäftsführer | 1 Bridge Houses Bridge End ST13 8LG Leek Staffordshire | British | 116444380001 | ||||||
| HOPWOOD, Joseph William | Geschäftsführer | Pavement Cottage Park Road GL55 6EA Chipping Campden Gloucestershire | British | 73294850001 | ||||||
| JACKSON, David | Geschäftsführer | Institute Cottage Church Road Great Milton OX44 7PD Oxford Oxfordshire | United Kingdom | British | 280628560001 | |||||
| PERRY, Stephen John | Geschäftsführer | c/o C/O Housing21 Baring Road HP9 2NA Beaconsfield The Triangle Buckinghamshire England | England | British | 252596450001 | |||||
| RAGUVARAN, Pushpa | Geschäftsführer | c/o C/O Housing21 Baring Road HP9 2NA Beaconsfield The Triangle Buckinghamshire England | United Kingdom | British | 146887380001 | |||||
| ROTHWELL, Dominic | Geschäftsführer | c/o C/O Housing21 Baring Road HP9 2NA Beaconsfield The Triangle Buckinghamshire England | England | British | 156573860001 | |||||
| TOWNEND, Nicholas Adam | Geschäftsführer | c/o C/O Housing21 Baring Road HP9 2NA Beaconsfield The Triangle Buckinghamshire England | England | British | 154577090001 | |||||
| WESTON, Paul David James | Geschäftsführer | 51-53 Hagley Road B16 8TP Birmingham Tricorn House England | United Kingdom | British | 61904620002 | |||||
| COMPANY DIRECTORS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 788-790 Finchley Road NW11 7TJ London | 900001110001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CLAIMAR CARE LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Housing & Care 21 | 06. Apr. 2016 | Hagley Road B16 8TP Birmingham Tricorn House England | Ja | ||||
| |||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||
Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für CLAIMAR CARE LIMITED?
| Benachrichtigt am | Aufgehört am | Erklärung |
|---|---|---|
| 06. Apr. 2016 | Das Unternehmen weiß oder hat Grund zu der Annahme, dass es keine registrierungspflichtige Person oder registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen gibt. |
Hat CLAIMAR CARE LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| All assets debenture | Erstellt am 01. Nov. 2007 Geliefert am 09. Nov. 2007 | Vollst ändig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any principal debtor to the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Keyman policy assignment | Erstellt am 01. Nov. 2007 Geliefert am 09. Nov. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All its right, title and interest in and to the policies including all new and substituted policies relating thereto and all moneys, including bonuses accrued. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignment of life policy | Erstellt am 03. Feb. 2006 Geliefert am 10. Feb. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Assigns to the bank the policy and all money that may become payable under the polciy. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 03. Feb. 2006 Geliefert am 10. Feb. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Chattel mortgage | Erstellt am 09. Aug. 2005 Geliefert am 12. Aug. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The equipment being invoice number S1626 - paradigm office interiors limited item s-90LFD 2 90 degree radius base unit, s-140FD 1 800 x 900 base unit, s-160FD 1 1600 x 800 base unit. For further details of chattels charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 28. Jan. 2005 Geliefert am 11. Feb. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Floating charge all the undertaking,property,rights and assets of the company both present and future of any kind whatsoever and wherever situated. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 23. Dez. 2004 Geliefert am 30. Dez. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 23. Dez. 2004 Geliefert am 23. Dez. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 23. Dez. 2004 Geliefert am 23. Dez. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 22. Dez. 2003 Geliefert am 09. Jan. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben £14,250.00. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 14. März 2003 Geliefert am 18. März 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben By way of legal mortgage 264 stockport road, ashton under lyne, tameside, OL7 0NS. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 16. Mai 2002 Geliefert am 29. Mai 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 16. Mai 2002 Geliefert am 23. Mai 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 27. Okt. 1999 Geliefert am 05. Nov. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0