CLAIMAR CARE LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCLAIMAR CARE LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03801649
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CLAIMAR CARE LIMITED?

    • Sonstige menschliche Gesundheitsaktivitäten (86900) / Gesundheits- und Sozialwesen

    Wo befindet sich CLAIMAR CARE LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Tricorn House
    51-53 Hagley Road
    B16 8TP Birmingham
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CLAIMAR CARE LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2022

    Welche sind die letzten Einreichungen für CLAIMAR CARE LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt.

    1 SeitenSOAS(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt

    1 SeitenDISS40

    Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. März 2022

    3 SeitenAA

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Bestätigungserklärung erstellt am 28. Juni 2022 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. März 2021

    3 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 28. Juni 2021 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von Paul David James Weston als Geschäftsführer am 25. Sept. 2020

    1 SeitenTM01

    Geänderte Konten eines Mikrounternehmens erstellt bis 31. März 2020

    6 SeitenAAMD

    Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. März 2020

    3 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 06. Juli 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. März 2019

    2 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 06. Juli 2019 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. März 2018

    2 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 06. Juli 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. März 2017

    2 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 06. Juli 2017 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Notification of a person with significant control statement

    2 SeitenPSC08

    Cessation of Housing & Care 21 as a person with significant control on 06. Apr. 2016

    1 SeitenPSC07

    Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. März 2016

    2 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 06. Juli 2016 mit Aktualisierungen

    6 SeitenCS01

    Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. März 2015

    2 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von CLAIMAR CARE LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    HUTTON, Paul Marcus
    51-53 Hagley Road
    B16 8TP Birmingham
    Tricorn House
    England
    Sekretär
    51-53 Hagley Road
    B16 8TP Birmingham
    Tricorn House
    England
    183500140001
    MOORE, Bruce John
    51-53 Hagley Road
    B16 8TP Birmingham
    Tricorn House
    England
    Geschäftsführer
    51-53 Hagley Road
    B16 8TP Birmingham
    Tricorn House
    England
    EnglandBritish117919920001
    BATEMAN, Stephen John
    c/o C/O Housing21
    Baring Road
    HP9 2NA Beaconsfield
    The Triangle
    Buckinghamshire
    England
    Sekretär
    c/o C/O Housing21
    Baring Road
    HP9 2NA Beaconsfield
    The Triangle
    Buckinghamshire
    England
    176476120001
    BRUNT, Sarah
    Avoncroft Road
    Stoke Heath
    B60 4NG Bromsgrove
    67
    West Midlands
    Sekretär
    Avoncroft Road
    Stoke Heath
    B60 4NG Bromsgrove
    67
    West Midlands
    British130638250001
    CEASER, James Terence
    31 St Laurence Road
    Northfield
    B31 2AU Birmingham
    West Midlands
    Sekretär
    31 St Laurence Road
    Northfield
    B31 2AU Birmingham
    West Midlands
    British102169390001
    CEASER, James Terence
    31 Saint Laurance Road
    Northfield
    B31 2AU Birmingham
    West Midlands
    Sekretär
    31 Saint Laurance Road
    Northfield
    B31 2AU Birmingham
    West Midlands
    British77324780001
    GUEST, Anthony
    Chase House The Orchards
    Four Oaks
    B74 2PP Sutton Coldfield
    West Midlands
    Sekretär
    Chase House The Orchards
    Four Oaks
    B74 2PP Sutton Coldfield
    West Midlands
    British15349990002
    HAMPTON, Sarah Delyth
    c/o C/O Housing21
    Baring Road
    HP9 2NA Beaconsfield
    The Triangle
    Buckinghamshire
    England
    Sekretär
    c/o C/O Housing21
    Baring Road
    HP9 2NA Beaconsfield
    The Triangle
    Buckinghamshire
    England
    151898390001
    HOPWOOD, Joseph William
    Pavement Cottage
    Park Road
    GL55 6EA Chipping Campden
    Gloucestershire
    Sekretär
    Pavement Cottage
    Park Road
    GL55 6EA Chipping Campden
    Gloucestershire
    British73294850001
    JACKSON, David
    Institute Cottage
    Church Road Great Milton
    OX44 7PD Oxford
    Oxfordshire
    Sekretär
    Institute Cottage
    Church Road Great Milton
    OX44 7PD Oxford
    Oxfordshire
    British280628560001
    LUXTON, Claire
    c/o C/O Housing21
    Baring Road
    HP9 2NA Beaconsfield
    The Triangle
    Buckinghamshire
    England
    Sekretär
    c/o C/O Housing21
    Baring Road
    HP9 2NA Beaconsfield
    The Triangle
    Buckinghamshire
    England
    171459770001
    TOWNEND, Nicholas Adam
    c/o C/O Housing21
    Baring Road
    HP9 2NA Beaconsfield
    The Triangle
    Buckinghamshire
    England
    Sekretär
    c/o C/O Housing21
    Baring Road
    HP9 2NA Beaconsfield
    The Triangle
    Buckinghamshire
    England
    British154577090001
    TEMPLE SECRETARIES LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Bevollmächtigter Sekretär
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001120001
    CEASER, James Terence
    31 Saint Laurance Road
    Northfield
    B31 2AU Birmingham
    West Midlands
    Geschäftsführer
    31 Saint Laurance Road
    Northfield
    B31 2AU Birmingham
    West Midlands
    British77324780001
    GUEST, Anthony
    Chase House The Orchards
    Four Oaks
    B74 2PP Sutton Coldfield
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Chase House The Orchards
    Four Oaks
    B74 2PP Sutton Coldfield
    West Midlands
    EnglandBritish15349990002
    HALES, Claire Louise
    88 Bunbury Road
    Northfield
    B31 2DW Birmingham
    West Midlands
    Geschäftsführer
    88 Bunbury Road
    Northfield
    B31 2DW Birmingham
    West Midlands
    British77324770001
    HALES, Mark
    40 Vicarage Road
    Edgbaston
    B15 3EZ Birmingham
    Claimar House
    West Midlands
    Geschäftsführer
    40 Vicarage Road
    Edgbaston
    B15 3EZ Birmingham
    Claimar House
    West Midlands
    EnglandBritish115420980001
    HARDISTY, Cheryl
    1 Bridge Houses
    Bridge End
    ST13 8LG Leek
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    1 Bridge Houses
    Bridge End
    ST13 8LG Leek
    Staffordshire
    British116444380001
    HOPWOOD, Joseph William
    Pavement Cottage
    Park Road
    GL55 6EA Chipping Campden
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    Pavement Cottage
    Park Road
    GL55 6EA Chipping Campden
    Gloucestershire
    British73294850001
    JACKSON, David
    Institute Cottage
    Church Road Great Milton
    OX44 7PD Oxford
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Institute Cottage
    Church Road Great Milton
    OX44 7PD Oxford
    Oxfordshire
    United KingdomBritish280628560001
    PERRY, Stephen John
    c/o C/O Housing21
    Baring Road
    HP9 2NA Beaconsfield
    The Triangle
    Buckinghamshire
    England
    Geschäftsführer
    c/o C/O Housing21
    Baring Road
    HP9 2NA Beaconsfield
    The Triangle
    Buckinghamshire
    England
    EnglandBritish252596450001
    RAGUVARAN, Pushpa
    c/o C/O Housing21
    Baring Road
    HP9 2NA Beaconsfield
    The Triangle
    Buckinghamshire
    England
    Geschäftsführer
    c/o C/O Housing21
    Baring Road
    HP9 2NA Beaconsfield
    The Triangle
    Buckinghamshire
    England
    United KingdomBritish146887380001
    ROTHWELL, Dominic
    c/o C/O Housing21
    Baring Road
    HP9 2NA Beaconsfield
    The Triangle
    Buckinghamshire
    England
    Geschäftsführer
    c/o C/O Housing21
    Baring Road
    HP9 2NA Beaconsfield
    The Triangle
    Buckinghamshire
    England
    EnglandBritish156573860001
    TOWNEND, Nicholas Adam
    c/o C/O Housing21
    Baring Road
    HP9 2NA Beaconsfield
    The Triangle
    Buckinghamshire
    England
    Geschäftsführer
    c/o C/O Housing21
    Baring Road
    HP9 2NA Beaconsfield
    The Triangle
    Buckinghamshire
    England
    EnglandBritish154577090001
    WESTON, Paul David James
    51-53 Hagley Road
    B16 8TP Birmingham
    Tricorn House
    England
    Geschäftsführer
    51-53 Hagley Road
    B16 8TP Birmingham
    Tricorn House
    England
    United KingdomBritish61904620002
    COMPANY DIRECTORS LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001110001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CLAIMAR CARE LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Housing & Care 21
    Hagley Road
    B16 8TP Birmingham
    Tricorn House
    England
    06. Apr. 2016
    Hagley Road
    B16 8TP Birmingham
    Tricorn House
    England
    Ja
    RechtsformNot For Profit Entity
    RechtsgrundlageCo-Operative And Community Benefits Society Act 2014
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über die Aktivitäten einer Firma auszuüben oder übt diese tatsächlich aus, die nach dem Recht, das sie regelt, keine juristische Person ist; und die Mitglieder dieser Firma (in ihrer Eigenschaft als solche) haben das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.
    • Die Person hat das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über das Unternehmen auszuüben oder übt diese tatsächlich aus.

    Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für CLAIMAR CARE LIMITED?

    Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss
    Benachrichtigt amAufgehört amErklärung
    06. Apr. 2016Das Unternehmen weiß oder hat Grund zu der Annahme, dass es keine registrierungspflichtige Person oder registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen gibt.

    Hat CLAIMAR CARE LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    All assets debenture
    Erstellt am 01. Nov. 2007
    Geliefert am 09. Nov. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any principal debtor to the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent for National Westminster Bank PLC(The "Security Trustee")
    Transaktionen
    • 09. Nov. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. März 2011Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    • 08. Apr. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Keyman policy assignment
    Erstellt am 01. Nov. 2007
    Geliefert am 09. Nov. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All its right, title and interest in and to the policies including all new and substituted policies relating thereto and all moneys, including bonuses accrued. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent for National Westminster Bank PLC(The "Security Trustee")
    Transaktionen
    • 09. Nov. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Assignment of life policy
    Erstellt am 03. Feb. 2006
    Geliefert am 10. Feb. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Assigns to the bank the policy and all money that may become payable under the polciy.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Nov. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 03. Feb. 2006
    Geliefert am 10. Feb. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Nov. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Chattel mortgage
    Erstellt am 09. Aug. 2005
    Geliefert am 12. Aug. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The equipment being invoice number S1626 - paradigm office interiors limited item s-90LFD 2 90 degree radius base unit, s-140FD 1 800 x 900 base unit, s-160FD 1 1600 x 800 base unit. For further details of chattels charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 12. Aug. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. März 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 28. Jan. 2005
    Geliefert am 11. Feb. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Floating charge all the undertaking,property,rights and assets of the company both present and future of any kind whatsoever and wherever situated.
    Berechtigte Personen
    • David John Clough and Julia Clough
    Transaktionen
    • 11. Feb. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Sept. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 23. Dez. 2004
    Geliefert am 30. Dez. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 30. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. März 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 23. Dez. 2004
    Geliefert am 23. Dez. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • James Terence Ceaser and Retha Cicely Ceaser
    Transaktionen
    • 23. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Sept. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 23. Dez. 2004
    Geliefert am 23. Dez. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Mark Hales and Claire Louise Hales
    Transaktionen
    • 23. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Juli 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 22. Dez. 2003
    Geliefert am 09. Jan. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    £14,250.00.
    Berechtigte Personen
    • Sir Charles Christian Nicholson Bt Sir Michael William Bunbury Bt and William Henry Georgewilks
    Transaktionen
    • 09. Jan. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. März 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 14. März 2003
    Geliefert am 18. März 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage 264 stockport road, ashton under lyne, tameside, OL7 0NS. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. März 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Nov. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 16. Mai 2002
    Geliefert am 29. Mai 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Royal Bank of Scotland Commercial Services LTD
    Transaktionen
    • 29. Mai 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Jan. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 16. Mai 2002
    Geliefert am 23. Mai 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Mai 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Jan. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 27. Okt. 1999
    Geliefert am 05. Nov. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Nov. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Sept. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0