FOOD PARTNERS LIMITED
Überblick
Unternehmensname | FOOD PARTNERS LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 03804549 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von FOOD PARTNERS LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich FOOD PARTNERS LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 2 The Square Southall Lane UB2 5NH Heathrow |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von FOOD PARTNERS LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
DMWSL 270 LIMITED | 09. Juli 1999 | 09. Juli 1999 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von FOOD PARTNERS LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für FOOD PARTNERS LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde ausgesetzt | 1 Seiten | DISS16(SOAS) | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||
Beendigung der Bestellung von Martin Johnson als Geschäftsführer am 03. Juni 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Diarmuid Brendan Conifrey als Geschäftsführer am 24. Juni 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||
Ernennung von Mr Diarmuid Brendan Conifrey als Direktor am 08. Apr. 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||
Gerichtsbeschluss S1096 Court Order to Rectify | 6 Seiten | OC | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Aug. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2018 | 22 Seiten | AA | ||
Erfüllung der Belastung 11 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||
legacy | Seiten | ANNOTATION | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Aug. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 30. Sept. 2017 | 23 Seiten | AA | ||
legacy | 2 Seiten | AGREEMENT2 | ||
legacy | 47 Seiten | PARENT_ACC | ||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE2 | ||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 31. März 2017 bis 30. Sept. 2017 | 1 Seiten | AA01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Aug. 2017 mit Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2016 | 31 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Aug. 2016 mit Aktualisierungen | 6 Seiten | CS01 | ||
Beendigung der Bestellung von Mark Ian Tentori als Geschäftsführer am 27. Apr. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Gavin Cox als Sekretär am 08. März 2016 | 1 Seiten | TM02 | ||
Beendigung der Bestellung von Gavin Eliot Cox als Geschäftsführer am 07. März 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||
Ernennung von Mr Martin Johnson als Direktor am 25. Feb. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||
Ernennung von Mr Mark Ian Tentori als Direktor am 06. Okt. 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von FOOD PARTNERS LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COX, Gavin | Sekretär | The Square Southall Lane UB2 5NH Heathrow 2 England | 165756650001 | |||||||
MOMEN, Julian Akhtar Karim | Sekretär | Tanners Drive MK14 5BN Blakelands 28 Milton Keynes | British | 150500050001 | ||||||
ROBERTSON, Neil Charles | Sekretär | 16 Barmstedt Drive LE15 6RG Oakham Rutland | British | Chartered Accountant | 48323870001 | |||||
THORNE, Michael | Sekretär | 48 Station Road Woburn Sands MK17 8RU Milton Keynes Buckinghamshire | British | 71735980002 | ||||||
DM COMPANY SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 16 Charlotte Square EH2 4DF Edinburgh Midlothian | 900000320001 | |||||||
MACLAY MURRAY & SPENS LLP | Bevollmächtigter Sekretär | St. Vincent Street G2 5NJ Glasgow 151 | 900003400001 | |||||||
CHREE, Ian Charles Gordon | Geschäftsführer | 6 The Grange Perceton KA11 2EU Irvine Ayrshire | Scotland | British | Company Director | 65127980003 | ||||
CONIFREY, Diarmuid Brendan | Geschäftsführer | The Square Southall Lane UB2 5NH Heathrow 2 | England | Irish | Chief Finance Officer | 268799160001 | ||||
COX, Gavin Eliot | Geschäftsführer | The Square Southall Lane UB2 5NH Heathrow 2 England | United Kingdom | British | Director | 153840250001 | ||||
EARL, Elizabeth Jane | Geschäftsführer | Waverley Burners Heath GU24 0DJ Pirbright Woking Surrey | United Kingdom | British | Company Director | 202375770001 | ||||
HAZELDEAN, William James | Geschäftsführer | 6a Balmoral Court Gleneagles Village PH3 1SH Auchterarder Perthshire | Scotland | British | Company Director | 83660790002 | ||||
HULBERT, David John | Geschäftsführer | St Michaels Way Steeple Claydon MK18 2QD Buckingham 53 Buckinghamshire United Kingdom | England | British | Operational And Technical Dire | 136463020001 | ||||
JOHNSON, Martin | Geschäftsführer | The Square Southall Lane UB2 5NH Heathrow 2 | England | British | Director | 140167360001 | ||||
KILSHAW, David Charles | Geschäftsführer | Drumallan 283 North Deeside Road, Cults AB15 9PA Aberdeen | United Kingdom | British | Industrial Manager | 18455470002 | ||||
KINGSLEY BATES, Paul | Geschäftsführer | Tanners Drive Blakelands MK14 5BN Milton Keynes 28 United Kingdom | United Kingdom | British | Managing Director | 132962170001 | ||||
MCLELLAND, Stewart | Geschäftsführer | 36 East Craigs Rigg EH12 8JA Edinburgh Midlothian | Scotland | British | Director | 157009150001 | ||||
MOMEN, Julian Akhtar Karim | Geschäftsführer | Tanners Drive Blakelands MK14 5BN Milton Keynes 28 United Kingdom | England | British | Director | 51784930002 | ||||
POCOCK, Patrick William | Geschäftsführer | The Steadings Woodside Of Cloghill, Kingswells AB15 8SA Aberdeen | British | Company Director | 96978470001 | |||||
ROBERTSON, Neil Charles | Geschäftsführer | 16 Barmstedt Drive LE15 6RG Oakham Rutland | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 48323870001 | ||||
ROBINSON, Stuart John | Geschäftsführer | Westfield House Harburn EH55 8RB West Calder West Lothian | British | Company Director | 63448390001 | |||||
TENTORI, Mark Ian | Geschäftsführer | The Square Southall Lane UB2 5NH Heathrow 2 | England | British | Chief Finance Officer | 119564310001 | ||||
THOMAS, Christopher | Geschäftsführer | Poyle Road Colnbrook SL3 0QX Slough Food Partners House England | United Kingdom | British | Director | 63844650001 | ||||
THORNE, Michael | Geschäftsführer | 48 Station Road Woburn Sands MK17 8RU Milton Keynes Buckinghamshire | British | Company Director | 71735980002 | |||||
THORPE, Alan | Geschäftsführer | 7 Oak Wynd Cambuslang G72 7GS Glasgow | British | Distribution Manager | 81775420001 | |||||
TRUELOVE, Amelia Anne | Geschäftsführer | Bentley Hall Fenny Bentley DE6 1LE Ashbourne Derbyshire | British | Director | 37845970003 | |||||
WOOD, Steven John | Geschäftsführer | Poyle Road Colnbrook SL3 0QX Slough Food Partners House England | United Kingdom | British | Director | 232132390001 | ||||
25 NOMINEES LIMITED | Geschäftsführer | Royal London House 22-25 Finsbury Square EC2A 1DX London | 42409900001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei FOOD PARTNERS LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adelie Foods Group Limited | 06. Apr. 2016 | The Square, Southall Lane UB2 5NH Southall 2 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat FOOD PARTNERS LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Erstellt am 05. März 2015 Geliefert am 11. März 2015 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung None. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 31. Mai 2013 Geliefert am 07. Juni 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung A fixed charge over all land (I.E. any interest in heritable, freehold or leasehold land) vested in or charged to food partners limited, owned now or in the future. This includes all fixtures and fittings attached to the land and all rents receivable from any lease granted out of the land.. A fixed charge, subject to third party consents, over all intellectual property of food partners limited, owned now or in the future.. Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 31. Mai 2013 Geliefert am 05. Juni 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 11. Apr. 2012 Geliefert am 14. Apr. 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor or any future obligor and each grantor of security to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite guarantee and debenture | Erstellt am 11. Apr. 2012 Geliefert am 14. Apr. 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any member of the group to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Rent deposit deed | Erstellt am 20. Okt. 2011 Geliefert am 01. Nov. 2011 | Ausstehend | Gesicherter Betrag £56,000 due or to become due | |
Kurze Angaben The deposit amount see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Rent deposit deed | Erstellt am 20. Okt. 2011 Geliefert am 01. Nov. 2011 | Ausstehend | Gesicherter Betrag £18,066.80 due or to become due | |
Kurze Angaben The deposit amount see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Rent deposit deed | Erstellt am 23. Feb. 2009 Geliefert am 04. März 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All monies standing to the credit of the deposit account see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Rent deposit deed | Erstellt am 24. Apr. 2008 Geliefert am 10. Mai 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £43,505.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben £43,505.00 or the amount of the credit in the account from time to time. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 21. Apr. 2008 Geliefert am 02. Mai 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Rent deposit deed | Erstellt am 01. März 2007 Geliefert am 10. März 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Premium of £56,000 plus vat deposited by the company with the chargee and all other sums from time to time. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture accession deed | Erstellt am 04. Apr. 2006 Geliefert am 13. Apr. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each member of the group to the security agent and/or the other secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Standard security which was presented for registration in scotland on 8 may 2006 and | Erstellt am 02. Apr. 2006 Geliefert am 27. Mai 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each present or future member of the group to the security agent and/or the other security parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Rowallan business park, southcraig avenue, kilmarnock t/no. AYR3588. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Share pledge | Erstellt am 02. Apr. 2006 Geliefert am 20. Apr. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Any additional shares and related rights, additional shares means any shares in the company including any such shares comprised in related rights meaning all dividends, interest. The comapany and the existing shares being food partners kilmarnock limited reg no:SC140577, ordinary shares of £1. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A standard security which was presented for registration in scotland on the 26TH september 2005 and | Erstellt am 31. Mai 2005 Geliefert am 07. Okt. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben The property k/a rowallan business park, kilmarnock. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Rent deposit deed | Erstellt am 07. Aug. 2003 Geliefert am 13. Aug. 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The sum of £62,500 or such greater sum as is equal to one half of the current annual rental as defined in the lease. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite corporate guarantee | Erstellt am 31. Okt. 2001 Geliefert am 17. Nov. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben To exercise a right of set-off or retention in respect of all money at any time standing to the credit of the guarantor's accounts whatsoever. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 31. Okt. 2001 Geliefert am 14. Nov. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 09. Okt. 2000 Geliefert am 19. Okt. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0