FOOD PARTNERS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameFOOD PARTNERS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03804549
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von FOOD PARTNERS LIMITED?

    • Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften

    Wo befindet sich FOOD PARTNERS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    2 The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von FOOD PARTNERS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    DMWSL 270 LIMITED09. Juli 199909. Juli 1999

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von FOOD PARTNERS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2018

    Welche sind die letzten Einreichungen für FOOD PARTNERS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ2

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde ausgesetzt

    1 SeitenDISS16(SOAS)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Beendigung der Bestellung von Martin Johnson als Geschäftsführer am 03. Juni 2020

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Diarmuid Brendan Conifrey als Geschäftsführer am 24. Juni 2020

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Diarmuid Brendan Conifrey als Direktor am 08. Apr. 2020

    2 SeitenAP01

    Gerichtsbeschluss

    S1096 Court Order to Rectify
    6 SeitenOC

    Bestätigungserklärung erstellt am 30. Aug. 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2018

    22 SeitenAA

    Erfüllung der Belastung 11 vollständig

    4 SeitenMR04

    legacy

    SeitenANNOTATION

    Bestätigungserklärung erstellt am 30. Aug. 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 30. Sept. 2017

    23 SeitenAA

    legacy

    2 SeitenAGREEMENT2

    legacy

    47 SeitenPARENT_ACC

    legacy

    3 SeitenGUARANTEE2

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 31. März 2017 bis 30. Sept. 2017

    1 SeitenAA01

    Bestätigungserklärung erstellt am 30. Aug. 2017 mit Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2016

    31 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 30. Aug. 2016 mit Aktualisierungen

    6 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von Mark Ian Tentori als Geschäftsführer am 27. Apr. 2016

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Gavin Cox als Sekretär am 08. März 2016

    1 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Gavin Eliot Cox als Geschäftsführer am 07. März 2016

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Martin Johnson als Direktor am 25. Feb. 2016

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Mark Ian Tentori als Direktor am 06. Okt. 2015

    2 SeitenAP01

    Wer sind die Geschäftsführer von FOOD PARTNERS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    COX, Gavin
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    England
    Sekretär
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    England
    165756650001
    MOMEN, Julian Akhtar Karim
    Tanners Drive
    MK14 5BN Blakelands
    28
    Milton Keynes
    Sekretär
    Tanners Drive
    MK14 5BN Blakelands
    28
    Milton Keynes
    British150500050001
    ROBERTSON, Neil Charles
    16 Barmstedt Drive
    LE15 6RG Oakham
    Rutland
    Sekretär
    16 Barmstedt Drive
    LE15 6RG Oakham
    Rutland
    BritishChartered Accountant48323870001
    THORNE, Michael
    48 Station Road
    Woburn Sands
    MK17 8RU Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Sekretär
    48 Station Road
    Woburn Sands
    MK17 8RU Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British71735980002
    DM COMPANY SERVICES LIMITED
    16 Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    Midlothian
    Bevollmächtigter Sekretär
    16 Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    Midlothian
    900000320001
    MACLAY MURRAY & SPENS LLP
    St. Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    151
    Bevollmächtigter Sekretär
    St. Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    151
    900003400001
    CHREE, Ian Charles Gordon
    6 The Grange
    Perceton
    KA11 2EU Irvine
    Ayrshire
    Geschäftsführer
    6 The Grange
    Perceton
    KA11 2EU Irvine
    Ayrshire
    ScotlandBritishCompany Director65127980003
    CONIFREY, Diarmuid Brendan
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    Geschäftsführer
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    EnglandIrishChief Finance Officer268799160001
    COX, Gavin Eliot
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    England
    Geschäftsführer
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    England
    United KingdomBritishDirector153840250001
    EARL, Elizabeth Jane
    Waverley
    Burners Heath
    GU24 0DJ Pirbright Woking
    Surrey
    Geschäftsführer
    Waverley
    Burners Heath
    GU24 0DJ Pirbright Woking
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director202375770001
    HAZELDEAN, William James
    6a Balmoral Court
    Gleneagles Village
    PH3 1SH Auchterarder
    Perthshire
    Geschäftsführer
    6a Balmoral Court
    Gleneagles Village
    PH3 1SH Auchterarder
    Perthshire
    ScotlandBritishCompany Director83660790002
    HULBERT, David John
    St Michaels Way
    Steeple Claydon
    MK18 2QD Buckingham
    53
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    St Michaels Way
    Steeple Claydon
    MK18 2QD Buckingham
    53
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritishOperational And Technical Dire136463020001
    JOHNSON, Martin
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    Geschäftsführer
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    EnglandBritishDirector140167360001
    KILSHAW, David Charles
    Drumallan
    283 North Deeside Road, Cults
    AB15 9PA Aberdeen
    Geschäftsführer
    Drumallan
    283 North Deeside Road, Cults
    AB15 9PA Aberdeen
    United KingdomBritishIndustrial Manager18455470002
    KINGSLEY BATES, Paul
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    United KingdomBritishManaging Director132962170001
    MCLELLAND, Stewart
    36 East Craigs Rigg
    EH12 8JA Edinburgh
    Midlothian
    Geschäftsführer
    36 East Craigs Rigg
    EH12 8JA Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritishDirector157009150001
    MOMEN, Julian Akhtar Karim
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector51784930002
    POCOCK, Patrick William
    The Steadings
    Woodside Of Cloghill, Kingswells
    AB15 8SA Aberdeen
    Geschäftsführer
    The Steadings
    Woodside Of Cloghill, Kingswells
    AB15 8SA Aberdeen
    BritishCompany Director96978470001
    ROBERTSON, Neil Charles
    16 Barmstedt Drive
    LE15 6RG Oakham
    Rutland
    Geschäftsführer
    16 Barmstedt Drive
    LE15 6RG Oakham
    Rutland
    United KingdomBritishChartered Accountant48323870001
    ROBINSON, Stuart John
    Westfield House
    Harburn
    EH55 8RB West Calder
    West Lothian
    Geschäftsführer
    Westfield House
    Harburn
    EH55 8RB West Calder
    West Lothian
    BritishCompany Director63448390001
    TENTORI, Mark Ian
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    Geschäftsführer
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    EnglandBritishChief Finance Officer119564310001
    THOMAS, Christopher
    Poyle Road
    Colnbrook
    SL3 0QX Slough
    Food Partners House
    England
    Geschäftsführer
    Poyle Road
    Colnbrook
    SL3 0QX Slough
    Food Partners House
    England
    United KingdomBritishDirector63844650001
    THORNE, Michael
    48 Station Road
    Woburn Sands
    MK17 8RU Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    48 Station Road
    Woburn Sands
    MK17 8RU Milton Keynes
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director71735980002
    THORPE, Alan
    7 Oak Wynd
    Cambuslang
    G72 7GS Glasgow
    Geschäftsführer
    7 Oak Wynd
    Cambuslang
    G72 7GS Glasgow
    BritishDistribution Manager81775420001
    TRUELOVE, Amelia Anne
    Bentley Hall
    Fenny Bentley
    DE6 1LE Ashbourne
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    Bentley Hall
    Fenny Bentley
    DE6 1LE Ashbourne
    Derbyshire
    BritishDirector37845970003
    WOOD, Steven John
    Poyle Road
    Colnbrook
    SL3 0QX Slough
    Food Partners House
    England
    Geschäftsführer
    Poyle Road
    Colnbrook
    SL3 0QX Slough
    Food Partners House
    England
    United KingdomBritishDirector232132390001
    25 NOMINEES LIMITED
    Royal London House
    22-25 Finsbury Square
    EC2A 1DX London
    Geschäftsführer
    Royal London House
    22-25 Finsbury Square
    EC2A 1DX London
    42409900001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei FOOD PARTNERS LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Adelie Foods Group Limited
    The Square, Southall Lane
    UB2 5NH Southall
    2
    England
    06. Apr. 2016
    The Square, Southall Lane
    UB2 5NH Southall
    2
    England
    Nein
    RechtsformAdelie Foods Group Limited
    RegistrierungslandEngalnd & Wales
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortRegistrar Of Companies
    Registrierungsnummer07964277
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.

    Hat FOOD PARTNERS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 05. März 2015
    Geliefert am 11. März 2015
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    None.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    Transaktionen
    • 11. März 2015Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 31. Mai 2013
    Geliefert am 07. Juni 2013
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    A fixed charge over all land (I.E. any interest in heritable, freehold or leasehold land) vested in or charged to food partners limited, owned now or in the future. This includes all fixtures and fittings attached to the land and all rents receivable from any lease granted out of the land.. A fixed charge, subject to third party consents, over all intellectual property of food partners limited, owned now or in the future.. Notification of addition to or amendment of charge.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transaktionen
    • 07. Juni 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 10. März 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 31. Mai 2013
    Geliefert am 05. Juni 2013
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Punjab National Bank (International) Limited
    Transaktionen
    • 05. Juni 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 06. Feb. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 11. Apr. 2012
    Geliefert am 14. Apr. 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor or any future obligor and each grantor of security to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 14. Apr. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 07. Juni 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 11. Apr. 2012
    Geliefert am 14. Apr. 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any member of the group to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Pnc Business Credit, a Trading Style of Pnc Financial Services UK LTD
    Transaktionen
    • 14. Apr. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 07. Juni 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 20. Okt. 2011
    Geliefert am 01. Nov. 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £56,000 due or to become due
    Kurze Angaben
    The deposit amount see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Trw Pensions Trust Limited
    Transaktionen
    • 01. Nov. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 20. Okt. 2011
    Geliefert am 01. Nov. 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £18,066.80 due or to become due
    Kurze Angaben
    The deposit amount see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Trw Pensions Trust Limited
    Transaktionen
    • 01. Nov. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 23. Feb. 2009
    Geliefert am 04. März 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All monies standing to the credit of the deposit account see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Brixton (Unit 6 Horton Road Poyle) Limited
    Transaktionen
    • 04. März 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 24. Apr. 2008
    Geliefert am 10. Mai 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £43,505.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    £43,505.00 or the amount of the credit in the account from time to time.
    Berechtigte Personen
    • Microsoft Limited
    Transaktionen
    • 10. Mai 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. März 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 21. Apr. 2008
    Geliefert am 02. Mai 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Duke Street Capital General Partner Limited (As Security Agent for the Secured Parties)
    Transaktionen
    • 02. Mai 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Juni 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 01. März 2007
    Geliefert am 10. März 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Premium of £56,000 plus vat deposited by the company with the chargee and all other sums from time to time.
    Berechtigte Personen
    • Trw Pensions Trust Limited
    Transaktionen
    • 10. März 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture accession deed
    Erstellt am 04. Apr. 2006
    Geliefert am 13. Apr. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each member of the group to the security agent and/or the other secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Agent for the Secured Parties)
    Transaktionen
    • 13. Apr. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Juni 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 8 may 2006 and
    Erstellt am 02. Apr. 2006
    Geliefert am 27. Mai 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the security agent and/or the other security parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Rowallan business park, southcraig avenue, kilmarnock t/no. AYR3588.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Agent for the Security Parties)
    Transaktionen
    • 27. Mai 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Juni 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Share pledge
    Erstellt am 02. Apr. 2006
    Geliefert am 20. Apr. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Any additional shares and related rights, additional shares means any shares in the company including any such shares comprised in related rights meaning all dividends, interest. The comapany and the existing shares being food partners kilmarnock limited reg no:SC140577, ordinary shares of £1. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland 'Security Agent'
    Transaktionen
    • 20. Apr. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Juni 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 26TH september 2005 and
    Erstellt am 31. Mai 2005
    Geliefert am 07. Okt. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    The property k/a rowallan business park, kilmarnock.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 07. Okt. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Apr. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 07. Aug. 2003
    Geliefert am 13. Aug. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The sum of £62,500 or such greater sum as is equal to one half of the current annual rental as defined in the lease.
    Berechtigte Personen
    • Cockspur Property (General Partner) Limited and Cockspur Property (Nominee No.1) Limited
    Transaktionen
    • 13. Aug. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Composite corporate guarantee
    Erstellt am 31. Okt. 2001
    Geliefert am 17. Nov. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    To exercise a right of set-off or retention in respect of all money at any time standing to the credit of the guarantor's accounts whatsoever. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 17. Nov. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Apr. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 31. Okt. 2001
    Geliefert am 14. Nov. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 14. Nov. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Apr. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 09. Okt. 2000
    Geliefert am 19. Okt. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 19. Okt. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Nov. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0